03726341 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della società03726341 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03726341
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di 03726341 LIMITED?

    • (5510) /

    Dove si trova 03726341 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    St Helens House
    King Street
    DE1 3EE Derby
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di 03726341 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    GEMINI III LIMITED04 mar 199904 mar 1999

    Quali sono gli ultimi bilanci di 03726341 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per 03726341 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    33 pagineLIQ14

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 22 mar 2019

    30 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 22 mar 2018

    24 pagineLIQ03

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    1 pagine2.34B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 25 ott 2016

    27 pagine2.24B

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B

    11 pagine2.16B

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    2 pagineF2.18

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    54 pagine2.17B

    Avviso di nomina di un amministratore sostitutivo/aggiuntivo

    1 pagine2.40B

    Indirizzo della sede legale modificato da Wilmot House St James Court Friar Gate Derby DE1 1BT a St Helens House King Street Derby DE1 3EE in data 13 mag 2016

    2 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    pagine2.12B

    Ripristino per ordine del tribunale

    3 pagineAC92

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed the lace market hotel\certificate issued on 04/05/16
    pagineCERTNM

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 21 dic 2012

    17 pagine2.24B

    Avviso di passaggio da amministrazione a dissoluzione

    17 pagine2.35B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 02 lug 2012

    13 pagine2.24B

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    3 pagineF2.18

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B

    23 pagine2.16B

    Indirizzo della sede legale modificato da * 29-31 High Pavement Nottingham NG1 1HE* in data 25 gen 2012

    2 pagineAD01

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    46 pagine2.17B

    legacy

    4 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Chi sono gli amministratori di 03726341 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BLICK, Emma Jane
    Upper Greenhill Farm
    Warren Hills Road
    LE67 9QD Copt Oak
    Leicestershire
    Segretario
    Upper Greenhill Farm
    Warren Hills Road
    LE67 9QD Copt Oak
    Leicestershire
    BritishDirector69718200002
    BLICK, James Albert Richard
    Upper Greenhill Farm
    Warren Hills Road
    LE67 9QD Copt Oak
    Leicestershire
    Amministratore
    Upper Greenhill Farm
    Warren Hills Road
    LE67 9QD Copt Oak
    Leicestershire
    EnglandBritishDirector69718210002
    BEACHAM, Robert Michael
    2 Westbury House
    Wellington Square
    NG7 1NG Nottingham
    Nottinghamshire
    Segretario
    2 Westbury House
    Wellington Square
    NG7 1NG Nottingham
    Nottinghamshire
    BritishDirector59422880002
    ARGUS NOMINEE SECRETARIES LIMITED
    Wharf Lodge
    112 Mansfield Road
    DE1 3RA Derby
    Segretario nominato
    Wharf Lodge
    112 Mansfield Road
    DE1 3RA Derby
    900010830001
    BEACHAM, Robert Michael
    2 Westbury House
    Wellington Square
    NG7 1NG Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    2 Westbury House
    Wellington Square
    NG7 1NG Nottingham
    Nottinghamshire
    BritishDirector59422880002
    HIGGINSON, Anthony Garth
    72 Cotgrave Lane
    Tollerton
    NG12 4FY Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    72 Cotgrave Lane
    Tollerton
    NG12 4FY Nottingham
    Nottinghamshire
    BritishDirector63714360001
    HIGGINSON, David
    C/O 72 Cotgrave Lane
    Tollerton
    NG12 4FY Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    C/O 72 Cotgrave Lane
    Tollerton
    NG12 4FY Nottingham
    Nottinghamshire
    BritishDirector63931320002
    HIGGINSON, Doreen Mary
    72 Cotgrave Lane
    Tollerton
    NG12 4FY Nottingham
    Amministratore
    72 Cotgrave Lane
    Tollerton
    NG12 4FY Nottingham
    BritishDirector23481110002
    HIGGINSON, John
    Apartment 31
    21 Barker Gate
    The Lace Market
    Nottingham
    Amministratore
    Apartment 31
    21 Barker Gate
    The Lace Market
    Nottingham
    BritishDirector80290070001
    VAN DAALEN, John Mello
    Appartment A4 De Rede
    Ernest Van Dijk Kaai 5
    FOREIGN Antwerpen
    2000
    Belgium
    Amministratore
    Appartment A4 De Rede
    Ernest Van Dijk Kaai 5
    FOREIGN Antwerpen
    2000
    Belgium
    BritishCompany Director63106620002
    WHITEHEAD, John Henry Thomas
    Flat 1
    4 Western Terrace The Park
    NG7 1AF Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Flat 1
    4 Western Terrace The Park
    NG7 1AF Nottingham
    Nottinghamshire
    BritishDirector56633010001
    ARGUS NOMINEE DIRECTORS LIMITED
    Wharf Lodge
    112 Mansfield Road
    DE1 3RA Derby
    Amministratore delegato nominato
    Wharf Lodge
    112 Mansfield Road
    DE1 3RA Derby
    900010820001

    03726341 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 30 giu 2009
    Consegnato il 18 lug 2009
    Parzialmente soddisfatta
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all f/h and l/h property and assets present and future.
    Persone aventi diritto
    • John Andrew Gillions and Malcolm Charles Alan Killin as Trustees of the Finesse Loans Bare Trust
    Transazioni
    • 18 lug 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 gen 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 30 giu 2009
    Consegnato il 04 lug 2009
    Parzialmente soddisfatta
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    L/H land 29-31 high pavement nottingham t/n NT329418 anf f/h land the county tavern 27 high pavement nottingham t/n NT224271.
    Persone aventi diritto
    • Malcolm Charles Alan Killin and John Andrew Gillions
    Transazioni
    • 04 lug 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 gen 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 23 giu 2005
    Consegnato il 07 lug 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The county tavern, 27 high pavement, nottingham t/no NT224271 and 29/31 high pavement, nottingham t/no NT329418.
    Persone aventi diritto
    • Colin Vaughan Mcleod, Hugh Alastair Sinclair, John Andrew Gillions
    Transazioni
    • 07 lug 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 ago 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge over licensed premises
    Creato il 23 giu 2005
    Consegnato il 30 giu 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The country tavern 27 high pavement t/no NT224271 by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets. The benefit of all justices excise or other licences or registration certificates held from time to time in connection with the business carried on at the property and the right to recover and receive any compensation payable at any time on account of the non-renewal of such licences.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 30 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 gen 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge over licensed premises
    Creato il 23 giu 2005
    Consegnato il 30 giu 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    29 and 31 high pavement t/no NT329418. By way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets. The benefit of all justices excise or other licences or registration certificates held from time to time in connection with the business carried on at the property and the right to recover and receive any compensation payable at any time on account of the non-renewal of such licences.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 30 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 gen 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 23 giu 2005
    Consegnato il 30 giu 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 30 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 nov 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture containing fixed and floating charges
    Creato il 24 set 2002
    Consegnato il 05 ott 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from spice effect limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Rysafe Trustee Company (C.I.) Limited as Trustee of the Mello Trust
    Transazioni
    • 05 ott 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 giu 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 22 giu 2001
    Consegnato il 03 lug 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a the county tavern 25 & 27 high pavement t/n NT224271. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 03 lug 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 giu 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 21 nov 2000
    Consegnato il 09 dic 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H 29-31 high pavement the lace market nottingham. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 09 dic 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 giu 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 12 gen 2000
    Consegnato il 19 gen 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 19 gen 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 giu 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    03726341 LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    03 gen 2012Inizio dell'amministrazione
    23 mar 2017Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Dean Anthony Nelson
    Smith Cooper Limited, 158 Edmund Street
    B3 2HB Birmingham
    Praticante
    Smith Cooper Limited, 158 Edmund Street
    B3 2HB Birmingham
    Nicholas Charles Osborn Lee
    St. Helens House King Street
    DE1 3EE Derby
    Derbyshire
    Praticante
    St. Helens House King Street
    DE1 3EE Derby
    Derbyshire
    2
    DataTipo
    23 mar 2017Inizio della liquidazione
    15 nov 2019Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Nicholas Charles Osborn Lee
    138 Edmund Street
    B3 2HB Birmingham
    Praticante
    138 Edmund Street
    B3 2HB Birmingham
    Dean Anthony Nelson
    St. Helens House King Street
    DE1 3EE Derby
    Derbyshire
    Praticante
    St. Helens House King Street
    DE1 3EE Derby
    Derbyshire
    Nicholas Charles Osborn Lee
    138 Edmund Street
    B3 2HB Birmingham
    Liquidatore proposto
    138 Edmund Street
    B3 2HB Birmingham
    Dean Anthony Nelson
    St. Helens House King Street
    DE1 3EE Derby
    Derbyshire
    Liquidatore proposto
    St. Helens House King Street
    DE1 3EE Derby
    Derbyshire

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0