PRODUCT PROCUREMENT SERVICES LIMITED
Panoramica
Nome della società | PRODUCT PROCUREMENT SERVICES LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 03726605 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | Sì |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di PRODUCT PROCUREMENT SERVICES LIMITED?
- (7487) /
Dove si trova PRODUCT PROCUREMENT SERVICES LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Gloucester House 72 London Road AL1 1NS St Albans Hertfordshire |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di PRODUCT PROCUREMENT SERVICES LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
MEAUJO (406) LIMITED | 04 mar 1999 | 04 mar 1999 |
Quali sono le ultime deposizioni per PRODUCT PROCUREMENT SERVICES LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori | 4 pagine | 4.72 | ||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 03 feb 2011 | 6 pagine | 4.68 | ||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 03 ago 2010 | 9 pagine | 4.68 | ||
Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori | 12 pagine | 2.34B | ||
Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 21 giu 2009 | 14 pagine | 2.24B | ||
Risultato della riunione dei creditori | 37 pagine | 2.23B | ||
Dichiarazione della proposta dell'amministratore | 37 pagine | 2.17B | ||
Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B | 12 pagine | 2.16B | ||
legacy | 1 pagine | 288b | ||
legacy | 1 pagine | 287 | ||
Nomina di un amministratore | 1 pagine | 2.12B | ||
legacy | 1 pagine | 225 | ||
legacy | 1 pagine | 288b | ||
legacy | 1 pagine | 288b | ||
legacy | 2 pagine | 288a | ||
Bilancio redatto al 30 set 2007 | 21 pagine | AA | ||
legacy | 4 pagine | 363a | ||
legacy | 1 pagine | 225 | ||
legacy | 1 pagine | 288b | ||
legacy | 1 pagine | 288b | ||
legacy | 1 pagine | 288b | ||
legacy | 1 pagine | 288b | ||
legacy | 1 pagine | 288c | ||
Bilancio redatto al 31 mar 2006 | 20 pagine | AA |
Chi sono gli amministratori di PRODUCT PROCUREMENT SERVICES LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEVERS, Michael John Eyre | Amministratore | 86 Gillhurst Road Harbourne B17 8PA Birmingham West Midlands | Uk | British | Director | 80584980001 | ||||
KING, David Richard | Amministratore | 29 Riffhams Drive CM2 7DE Great Baddow Essex | United Kingdom | British | Business Developer | 92253870001 | ||||
ASH, Roderick Martin | Segretario | 18 Whinbrook Grove LS17 6AF Leeds West Yorkshire | British | Company Director | 1786820001 | |||||
BRIARS, Mark Anthony | Segretario | Galleydene SS7 2QA Hadleigh 21 Essex United Kingdom | British | Chartered Accountant | 135777020001 | |||||
CHAPMAN, Kieran Paul | Segretario | 64 Windmill Road CO9 1JN Halstead Essex | British | Accountant | 119140190001 | |||||
IEVERS, Michael John Eyre | Segretario | 86 Gillhurst Road Harbourne B17 8PA Birmingham West Midlands | British | 80584980001 | ||||||
LAWTON, Kirsten | Segretario | 31 Orchard Avenue KT7 0BB Thames Ditton Surrey | British | 50045660001 | ||||||
MCMELLON, Christopher John | Segretario | 12 Grovehill Crescent TR11 3HR Falmouth Cornwall | British | Company Secretary | 43249730003 | |||||
SINCLAIR, Rebecca Claire | Segretario | South Woodham Ferrers CM3 5QU Essex Fennbrook House | British | 132717880001 | ||||||
WINTER, Thomas George | Segretario | Bonython House Bicknacre Road CM3 4JR Danbury Essex | British | Accountant | 92253520001 | |||||
PHILSEC LIMITED | Segretario nominato | St Philips House St Philips Place B3 2PP Birmingham West Midlands | 900006520001 | |||||||
ASH, Roderick Martin | Amministratore | 18 Whinbrook Grove LS17 6AF Leeds West Yorkshire | United Kingdom | British | Company Director | 1786820001 | ||||
BELDEAU, Michael Henri | Amministratore | Summerhill House 16 Meadway KT10 9HF Esher Surrey | British | Director | 76429710002 | |||||
BOND, Gordon | Amministratore | Omega Durford Wood GU31 5AN Petersfield Hampshire | British | Chief Executive | 37448240001 | |||||
BONSEY, Colin Peter | Amministratore | 114 Village Way TW15 2JU Ashford Middlesex | British | Finance Director | 3301850001 | |||||
BRIARS, Mark Anthony | Amministratore | Galleydene SS7 2QA Hadleigh 21 Essex United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 135777020001 | ||||
DARBYSHIRE, Ian Simpson | Amministratore | High Barn Flasby BD23 3PU Skipton North Yorkshire | British | Company Director | 64545980001 | |||||
FIRTH, Steven | Amministratore | 8 Poplar Grove BD19 6JG Cleckheaton West Yorkshire | England | British | None | 104177470001 | ||||
HALLIDAY, Peter Edwin | Amministratore | 40 Woodfields TN13 2RB Sevenoaks Kent | British | Chartered Accountant | 29224200001 | |||||
HIRST, Stephen | Amministratore | 12 Ireton Road CO3 3AT Colchester Essex | England | British | Chartered Accountant | 15209580001 | ||||
IEVERS, Michael John Eyre | Amministratore | 86 Gillhurst Road Harbourne B17 8PA Birmingham West Midlands | Uk | British | Accountant | 80584980001 | ||||
KNIGHT, Joanna Felicity | Amministratore | The Orchard Mill Lane, Earl Stonham IP14 5HS Stowmarket | England | British | Company Director | 35903430004 | ||||
MCLELLAN, Hugh | Amministratore | 90 Melton Road NR18 0DF Wymondham Norfolk | United Kingdom | British | Director | 111458450001 | ||||
POSKITT, John Robert | Amministratore | 11 Severn Avenue Gidea Park RM2 6EA Romford Essex | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 92122220001 | ||||
PRESTON, Graham John | Amministratore | Baytrees 31 Priests Lane CM15 8BU Brentwood Essex | England | British | Company Director | 100555620001 | ||||
PRESTON, Graham John | Amministratore | Baytrees 31 Priests Lane CM15 8BU Brentwood Essex | England | British | Company Director | 100555620001 | ||||
PRICE, William Frederick Ernest | Amministratore | Willowbrook 20 High Street Wheatley OX33 1XX Oxford Oxfordshire | United Kingdom | British | Business Consultant | 24187260001 | ||||
SMITH, James David Michael | Amministratore | Meadowcroft Sterlings Field SL6 9PG Cookham Dean Berkshire | British | Director | 885240001 | |||||
WINTER, Thomas George | Amministratore | Bonython House Bicknacre Road CM3 4JR Danbury Essex | England | British | Accountant | 92253520001 | ||||
MEAUJO INCORPORATIONS LIMITED | Amministratore delegato nominato | St Philips House St Philips Place B3 2PP Birmingham West Midlands | 900006510001 |
PRODUCT PROCUREMENT SERVICES LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Creato il 30 set 2004 Consegnato il 02 ott 2004 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal mortgage | Creato il 22 gen 2004 Consegnato il 04 feb 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each and every obligor to the lender on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari L/H property at montrose road dukes park industrial estate chelmsford all rights and claims in relation to the property. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal mortgage | Creato il 22 gen 2004 Consegnato il 23 gen 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each and every obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The property premises at montrose road dukes park industrial estate chelmsford essex. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 25 nov 2003 Consegnato il 02 dic 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
All assets debenture deed | Creato il 27 mag 2002 Consegnato il 31 mag 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
PRODUCT PROCUREMENT SERVICES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| In amministrazione |
| ||||||||||||||||||||||
2 |
| Liquidazione volontaria dei creditori |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0