IGROUP3 LIMITED
Panoramica
| Nome della società | IGROUP3 LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03730890 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di IGROUP3 LIMITED?
- Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto
Dove si trova IGROUP3 LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 30 Finsbury Square EC2P 2YU London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di IGROUP3 LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| OCWEN 3 LIMITED | 08 mar 1999 | 08 mar 1999 |
Quali sono gli ultimi bilanci di IGROUP3 LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 30 nov 2016 |
Quali sono le ultime deposizioni per IGROUP3 LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 8 pagine | LIQ13 | ||||||||||
Cessazione della carica di Kalpna Shah come segretario in data 31 gen 2018 | 2 pagine | TM02 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da PO Box 2497 Building 4 Hatters Lane Watford WD18 1YY United Kingdom a 30 Finsbury Square London EC2P 2YU in data 01 dic 2017 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 1 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 5 pagine | LIQ01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Richard William Bird come amministratore in data 29 set 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 nov 2016 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 08 mar 2017 con aggiornamenti | 6 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Laurence Anne Renee Perrin come amministratore in data 30 dic 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Miss Samantha Jones come amministratore in data 10 ott 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Bernardus Petrus Maria Van Bunnik come amministratore in data 01 ott 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Building 4 Hatters Lane Croxley Green Business Park Watford Hertfordshire WD18 8YF a PO Box 2497 Building 4 Hatters Lane Watford WD18 1YY in data 23 ago 2016 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Manuel Uria-Fernandez come amministratore in data 14 giu 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Richard William Bird come amministratore in data 14 giu 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 08 mar 2016 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 nov 2015 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Manuel Uria-Fernandez il 17 dic 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Steven Mark Pickering come amministratore in data 11 set 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mrs Kalpna Shah come segretario in data 10 lug 2015 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Fn Secretary Limited come segretario in data 10 lug 2015 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 08 mar 2015 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Mrs Laurence Anne Renee Perrin come amministratore in data 16 feb 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 nov 2014 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di IGROUP3 LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JONES, Samantha | Amministratore | Finsbury Square EC2P 2YU London 30 | United Kingdom | British | 216074420001 | |||||
| SHAH, Kalpna | Segretario | Finsbury Square EC2P 2YU London 30 | 199403800001 | |||||||
| SHAH, Kalpna | Segretario | 18 Vicarage Road WD18 0EH Watford Hertfordshire | British | 80753870001 | ||||||
| FN SECRETARY LIMITED | Segretario | Hatters Lane Croxley Green Business Park WD18 8YF Watford Building 4 Hertfordshire United Kingdom | 88740300002 | |||||||
| RUTLAND SECRETARIES LIMITED | Segretario | Rutland House 148 Edmund Street B3 2JR Birmingham | 38851450001 | |||||||
| AINSWORTH, Keith | Amministratore | 76 Howes Lane Finham CV3 6PJ Coventry Warwickshire | United Kingdom | British | 46161840001 | |||||
| BELLORA, Michael Richard | Amministratore | Russet House 1a Latchmoor Avenue SL9 8LL Gerrards Cross Buckinghamshire | American | 98453650001 | ||||||
| BERRY, Duncan Gee | Amministratore | Hatters Lane Croxley Green Business Park WD18 8YF Watford Building 4 Hertfordshire | England | British | 107695600022 | |||||
| BIRD, Richard William | Amministratore | Building 4 Hatters Lane WD18 1YY Watford PO BOX 2497 United Kingdom | United Kingdom | British | 209298590001 | |||||
| BOAKES, Jeremy Edward | Amministratore | 41 Sherrards Park Road AL8 7LD Welwyn Garden City Herts | British | 106122240001 | ||||||
| BRENNAN, Peter | Amministratore | 10 Ardross Avenue HA6 3DS Northwood Middlesex | British | 84912240001 | ||||||
| CRICHTON, Susan Elizabeth | Amministratore | The Pheasantries Ley Hill HP5 3QR Chesham Buckinghamshire | England | British | 69358970001 | |||||
| DE RIDDER, Kimon Celicourt Macris, Dr | Amministratore | Hatters Lane Croxley Green Business Park WD18 8YF Watford Building 4 Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 131081660001 | |||||
| DEANE JOHNS, Simon Joshua | Amministratore | 61 Stanlake Road W12 7HG London | Australian | 80748330001 | ||||||
| DLUTOWSKI, Joseph Arthur | Amministratore | 13127 Silver Fox Lane Palm Beach Gardens Palm Beach County 33418 United States Of America | American | 66506120001 | ||||||
| ERBEY, William Charles | Amministratore | 110 Sunset Avenue Apartment 2b 3947 Palm Beach Florida 33480-3947 United Statesof America | American | 58072470001 | ||||||
| EVANS, Kellie Victoria | Amministratore | Hatters Lane Croxley Green Business Park WD18 8YF Watford Building 4 Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 167417000001 | |||||
| FERGUSON, Ian George | Amministratore | Hatters Lane Croxley Green Business Park WD18 8YF Watford Building 4 Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 133318850001 | |||||
| FLYNN, William John | Amministratore | Hatters Lane Croxley Green Business Park WD18 8YF Watford Building 4 Hertfordshire United Kingdom | British | 99330320002 | ||||||
| GARDEN, Robert James | Amministratore | Hatters Lane Croxley Green Business Park WD18 8YF Watford Building 4 Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 152764360001 | |||||
| GUNNIGLE, Clodagh | Amministratore | Hatters Lane Croxley Green Business Park WD18 8YF Watford Building 4 Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | Irish | 138244630002 | |||||
| HARRIS, Jeffrey | Amministratore | 9 Northaw Place Coopers Lane EN6 4NQ Northaw Hertfordshire | American | 98233530002 | ||||||
| HARVEY, David | Amministratore | Hatters Lane Croxley Green Business Park WD18 8YF Watford Building 4 Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 97086950001 | |||||
| HEESE, Bruno | Amministratore | Hatters Lane Croxley Green Business Park WD18 8YF Watford Building 4 Hertfordshire | British | 115371680001 | ||||||
| HUNKIN, Ricky David | Amministratore | 2 Hockeridge View Oakwood HP4 3NB Berkhamsted Hertfordshire | British | 115390900001 | ||||||
| JOHAR, Mandeep Singh | Amministratore | Hatters Lane Croxley Green Business Park WD18 8YF Watford Building 4 Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | Indian | 127046380002 | |||||
| JOHNSON, Alec David | Amministratore | 12 The Witherings, Emerson Park RM11 2RA Hornchurch Essex | United Kingdom | British | 103446140001 | |||||
| KAGAN, Jeffrey Allan | Amministratore | 14 Norrice Lea N2 0RE London | Australian | 78535300001 | ||||||
| MILLWARD, Keith Roger | Amministratore | Le Marque Manor Close Penn HP10 8HZ High Wycombe Buckinghamshire | United Kingdom | British | 80388420001 | |||||
| PARROTT, Marc Richard | Amministratore | 30 Robin Hood Road CM15 9EN Brentwood Essex | British | 30126180001 | ||||||
| PERRIN, Laurence Anne Renee | Amministratore | Building 4 Hatters Lane WD18 1YY Watford PO BOX 2497 United Kingdom | United Kingdom | French | 183220720001 | |||||
| PICKERING, Steven Mark | Amministratore | Hatters Lane Croxley Green Business Park WD18 8YF Watford Building 4 Hertfordshire | United Kingdom | British | 164833430002 | |||||
| PUNCH, Andrew Robert | Amministratore | Pepys Way 6 Ford Road GU24 9EJ Bisley Surrey | United Kingdom | British | 147703850001 | |||||
| SANDERS, Colin George | Amministratore | Burleigh Grange Nightingales Lane HP8 4SR Chalfont St Giles Buckinghamshire | British | 81421480002 | ||||||
| SHAVE, Colin John Varnell | Amministratore | Hatters Lane Croxley Green Business Park WD18 8YF Watford Building 4 Hertfordshire United Kingdom | England | Usa And British | 90360350002 |
Chi sono le persone con controllo significativo di IGROUP3 LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ge Money Mortgages Limited | 06 apr 2016 | Hatters Lane Croxley Green Business Park WD18 1YY Watford PO BOX 2497 Building 4 Hertfordshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
IGROUP3 LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of charge | Creato il 03 nov 2000 Consegnato il 21 nov 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The aggregate of all indebtedness liabilities and obligations due or to become due or to become due from the company to the chargee or to the secured creditors (as defined) on any account whatsoever pursuant to the facility documents (as defined) | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Assignation in security (incorporating intimation thereof) | Creato il 16 ago 2000 Consegnato il 29 ago 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The payment and discharge of the secured obligations due or to become due from the company to the chargee in accordance with clause 2 of the deed of charge | |
Brevi particolari The whole right title and interest present and future of the company in and to the beneficial interest in the scottish mortgage loans and the collateral security pertaining thereto please refer to form 395 for full details. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Assignation in security by the chargor and ocwen limited | Creato il 19 lug 2000 Consegnato il 25 lug 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The payment and discharge of the secured obligations in accordance with the terms of clause 2 of the deed of charge dated 22 september 1999 (as defined) | |
Brevi particolari All right,title and interest in the scottish mortgage loans for £10,000.00 dated 14/7/00,account no.4003140 In favour of mr/mrs S.black and the collateral security (as defined). See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Assignation in security (incorporating intimation thereof) by the chargor and ocwen | Creato il 20 giu 2000 Consegnato il 22 giu 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The payment and discharge of the secured obligations (as defined) pursuant to the facility documents (as defined) on any account whatsoever | |
Brevi particolari The whole right,title and interest in and to the beneficial interest in the scottish mortgage loans and the collateral security thereto. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Supplemental deed of charge to a deed of charge dated 22 september 1999 | Creato il 02 giu 2000 Consegnato il 13 giu 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari All right title and interest in the new origination and sale agreement. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Assignation in security (incorporating intimation thereof) by the chargor and ocwen limited | Creato il 24 mag 2000 Consegnato il 26 mag 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The payment and discharge of the secured obligations (as defined) pursuant to the facility documents (as defined) on any account whatsoever | |
Brevi particolari The whole right,title and interest in and to the beneficial interest in the scottish mortgage loans and the collateral security thereto. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Assignation in security (incorporating intimation thereof) by the chargor and ocwen limited | Creato il 21 apr 2000 Consegnato il 22 apr 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the facility documents (as defined) and in accordance with the terms of clause 2 of the deed of charge | |
Brevi particolari All right,title and interest in the scottish mortgage loans and the collateral security thereto. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of charge | Creato il 22 set 1999 Consegnato il 02 ott 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The aggregate of all indebtedness liabilities and obligations due or to become due or to become due from the company to the chargee or to the secured creditors (as defined) on any account whatsoever pursuant to the facility documents (as defined) | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
IGROUP3 LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0