IGROUP3 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàIGROUP3 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03730890
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di IGROUP3 LIMITED?

    • Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova IGROUP3 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di IGROUP3 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    OCWEN 3 LIMITED08 mar 199908 mar 1999

    Quali sono gli ultimi bilanci di IGROUP3 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 nov 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per IGROUP3 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    8 pagineLIQ13

    Cessazione della carica di Kalpna Shah come segretario in data 31 gen 2018

    2 pagineTM02

    Indirizzo della sede legale modificato da PO Box 2497 Building 4 Hatters Lane Watford WD18 1YY United Kingdom a 30 Finsbury Square London EC2P 2YU in data 01 dic 2017

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 06 nov 2017

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Cessazione della carica di Richard William Bird come amministratore in data 29 set 2017

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 nov 2016

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 08 mar 2017 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    Cessazione della carica di Laurence Anne Renee Perrin come amministratore in data 30 dic 2016

    1 pagineTM01

    Nomina di Miss Samantha Jones come amministratore in data 10 ott 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Bernardus Petrus Maria Van Bunnik come amministratore in data 01 ott 2016

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da Building 4 Hatters Lane Croxley Green Business Park Watford Hertfordshire WD18 8YF a PO Box 2497 Building 4 Hatters Lane Watford WD18 1YY in data 23 ago 2016

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Manuel Uria-Fernandez come amministratore in data 14 giu 2016

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Richard William Bird come amministratore in data 14 giu 2016

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 08 mar 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital14 mar 2016

    Stato del capitale al 14 mar 2016

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 nov 2015

    6 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Manuel Uria-Fernandez il 17 dic 2015

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di Steven Mark Pickering come amministratore in data 11 set 2015

    1 pagineTM01

    Nomina di Mrs Kalpna Shah come segretario in data 10 lug 2015

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Fn Secretary Limited come segretario in data 10 lug 2015

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 08 mar 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital27 mar 2015

    Stato del capitale al 27 mar 2015

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Nomina di Mrs Laurence Anne Renee Perrin come amministratore in data 16 feb 2015

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 nov 2014

    7 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di IGROUP3 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    JONES, Samantha
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    Amministratore
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    United KingdomBritish216074420001
    SHAH, Kalpna
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    Segretario
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    199403800001
    SHAH, Kalpna
    18 Vicarage Road
    WD18 0EH Watford
    Hertfordshire
    Segretario
    18 Vicarage Road
    WD18 0EH Watford
    Hertfordshire
    British80753870001
    FN SECRETARY LIMITED
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Segretario
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    88740300002
    RUTLAND SECRETARIES LIMITED
    Rutland House
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    Segretario
    Rutland House
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    38851450001
    AINSWORTH, Keith
    76 Howes Lane
    Finham
    CV3 6PJ Coventry
    Warwickshire
    Amministratore
    76 Howes Lane
    Finham
    CV3 6PJ Coventry
    Warwickshire
    United KingdomBritish46161840001
    BELLORA, Michael Richard
    Russet House
    1a Latchmoor Avenue
    SL9 8LL Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Russet House
    1a Latchmoor Avenue
    SL9 8LL Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    American98453650001
    BERRY, Duncan Gee
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    Amministratore
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    EnglandBritish107695600022
    BIRD, Richard William
    Building 4
    Hatters Lane
    WD18 1YY Watford
    PO BOX 2497
    United Kingdom
    Amministratore
    Building 4
    Hatters Lane
    WD18 1YY Watford
    PO BOX 2497
    United Kingdom
    United KingdomBritish209298590001
    BOAKES, Jeremy Edward
    41 Sherrards Park Road
    AL8 7LD Welwyn Garden City
    Herts
    Amministratore
    41 Sherrards Park Road
    AL8 7LD Welwyn Garden City
    Herts
    British106122240001
    BRENNAN, Peter
    10 Ardross Avenue
    HA6 3DS Northwood
    Middlesex
    Amministratore
    10 Ardross Avenue
    HA6 3DS Northwood
    Middlesex
    British84912240001
    CRICHTON, Susan Elizabeth
    The Pheasantries
    Ley Hill
    HP5 3QR Chesham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    The Pheasantries
    Ley Hill
    HP5 3QR Chesham
    Buckinghamshire
    EnglandBritish69358970001
    DE RIDDER, Kimon Celicourt Macris, Dr
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish131081660001
    DEANE JOHNS, Simon Joshua
    61 Stanlake Road
    W12 7HG London
    Amministratore
    61 Stanlake Road
    W12 7HG London
    Australian80748330001
    DLUTOWSKI, Joseph Arthur
    13127 Silver Fox Lane
    Palm Beach Gardens
    Palm Beach County 33418
    United States Of America
    Amministratore
    13127 Silver Fox Lane
    Palm Beach Gardens
    Palm Beach County 33418
    United States Of America
    American66506120001
    ERBEY, William Charles
    110 Sunset Avenue Apartment 2b
    3947 Palm Beach
    Florida 33480-3947
    United Statesof America
    Amministratore
    110 Sunset Avenue Apartment 2b
    3947 Palm Beach
    Florida 33480-3947
    United Statesof America
    American58072470001
    EVANS, Kellie Victoria
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish167417000001
    FERGUSON, Ian George
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish133318850001
    FLYNN, William John
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    British99330320002
    GARDEN, Robert James
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish152764360001
    GUNNIGLE, Clodagh
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomIrish138244630002
    HARRIS, Jeffrey
    9 Northaw Place
    Coopers Lane
    EN6 4NQ Northaw
    Hertfordshire
    Amministratore
    9 Northaw Place
    Coopers Lane
    EN6 4NQ Northaw
    Hertfordshire
    American98233530002
    HARVEY, David
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish97086950001
    HEESE, Bruno
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    Amministratore
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    British115371680001
    HUNKIN, Ricky David
    2 Hockeridge View
    Oakwood
    HP4 3NB Berkhamsted
    Hertfordshire
    Amministratore
    2 Hockeridge View
    Oakwood
    HP4 3NB Berkhamsted
    Hertfordshire
    British115390900001
    JOHAR, Mandeep Singh
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomIndian127046380002
    JOHNSON, Alec David
    12 The Witherings, Emerson Park
    RM11 2RA Hornchurch
    Essex
    Amministratore
    12 The Witherings, Emerson Park
    RM11 2RA Hornchurch
    Essex
    United KingdomBritish103446140001
    KAGAN, Jeffrey Allan
    14 Norrice Lea
    N2 0RE London
    Amministratore
    14 Norrice Lea
    N2 0RE London
    Australian78535300001
    MILLWARD, Keith Roger
    Le Marque Manor Close
    Penn
    HP10 8HZ High Wycombe
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Le Marque Manor Close
    Penn
    HP10 8HZ High Wycombe
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish80388420001
    PARROTT, Marc Richard
    30 Robin Hood Road
    CM15 9EN Brentwood
    Essex
    Amministratore
    30 Robin Hood Road
    CM15 9EN Brentwood
    Essex
    British30126180001
    PERRIN, Laurence Anne Renee
    Building 4
    Hatters Lane
    WD18 1YY Watford
    PO BOX 2497
    United Kingdom
    Amministratore
    Building 4
    Hatters Lane
    WD18 1YY Watford
    PO BOX 2497
    United Kingdom
    United KingdomFrench183220720001
    PICKERING, Steven Mark
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    Amministratore
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United KingdomBritish164833430002
    PUNCH, Andrew Robert
    Pepys Way
    6 Ford Road
    GU24 9EJ Bisley
    Surrey
    Amministratore
    Pepys Way
    6 Ford Road
    GU24 9EJ Bisley
    Surrey
    United KingdomBritish147703850001
    SANDERS, Colin George
    Burleigh Grange
    Nightingales Lane
    HP8 4SR Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Burleigh Grange
    Nightingales Lane
    HP8 4SR Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    British81421480002
    SHAVE, Colin John Varnell
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandUsa And British90360350002

    Chi sono le persone con controllo significativo di IGROUP3 LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 1YY Watford
    PO BOX 2497 Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 1YY Watford
    PO BOX 2497 Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleUnited Kingdom (England)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione3770776
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    IGROUP3 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of charge
    Creato il 03 nov 2000
    Consegnato il 21 nov 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The aggregate of all indebtedness liabilities and obligations due or to become due or to become due from the company to the chargee or to the secured creditors (as defined) on any account whatsoever pursuant to the facility documents (as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Morgan Stanley Mortgage Servicing Limited(The "Security Trustee")
    Transazioni
    • 21 nov 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 gen 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignation in security (incorporating intimation thereof)
    Creato il 16 ago 2000
    Consegnato il 29 ago 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The payment and discharge of the secured obligations due or to become due from the company to the chargee in accordance with clause 2 of the deed of charge
    Brevi particolari
    The whole right title and interest present and future of the company in and to the beneficial interest in the scottish mortgage loans and the collateral security pertaining thereto please refer to form 395 for full details. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Morgan Stanley Mortgage Servicing Limited(In It's Capacity as Security Trustee in Terms of the Deed of Charge)
    Transazioni
    • 29 ago 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 gen 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignation in security by the chargor and ocwen limited
    Creato il 19 lug 2000
    Consegnato il 25 lug 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The payment and discharge of the secured obligations in accordance with the terms of clause 2 of the deed of charge dated 22 september 1999 (as defined)
    Brevi particolari
    All right,title and interest in the scottish mortgage loans for £10,000.00 dated 14/7/00,account no.4003140 In favour of mr/mrs S.black and the collateral security (as defined). See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Morgan Stanley Mortgage Servicing Limited,as Security Trustee in Terms of the Deed of Charge
    Transazioni
    • 25 lug 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 gen 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignation in security (incorporating intimation thereof) by the chargor and ocwen
    Creato il 20 giu 2000
    Consegnato il 22 giu 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The payment and discharge of the secured obligations (as defined) pursuant to the facility documents (as defined) on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The whole right,title and interest in and to the beneficial interest in the scottish mortgage loans and the collateral security thereto. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Morgan Stanley Mortgage Servicing Limited, as Security Trustee in Terms of the Deed of Charge(The "Security Trustee")
    Transazioni
    • 22 giu 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 gen 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental deed of charge to a deed of charge dated 22 september 1999
    Creato il 02 giu 2000
    Consegnato il 13 giu 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    All right title and interest in the new origination and sale agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Morgan Stanley Mortgage Servicing Limited (As Security Trustee)
    Transazioni
    • 13 giu 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 gen 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignation in security (incorporating intimation thereof) by the chargor and ocwen limited
    Creato il 24 mag 2000
    Consegnato il 26 mag 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The payment and discharge of the secured obligations (as defined) pursuant to the facility documents (as defined) on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The whole right,title and interest in and to the beneficial interest in the scottish mortgage loans and the collateral security thereto. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Morgan Stanley Mortgage Servicing Limited,as Security Trustee in Terms of the Deed of Charge
    Transazioni
    • 26 mag 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 gen 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignation in security (incorporating intimation thereof) by the chargor and ocwen limited
    Creato il 21 apr 2000
    Consegnato il 22 apr 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the facility documents (as defined) and in accordance with the terms of clause 2 of the deed of charge
    Brevi particolari
    All right,title and interest in the scottish mortgage loans and the collateral security thereto. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Morgan Stanley Mortgage Servicing Limited,as Security Trustee in Terms of the Deed of Charge
    Transazioni
    • 22 apr 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 gen 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge
    Creato il 22 set 1999
    Consegnato il 02 ott 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The aggregate of all indebtedness liabilities and obligations due or to become due or to become due from the company to the chargee or to the secured creditors (as defined) on any account whatsoever pursuant to the facility documents (as defined)
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Morgan Stanley Mortgage Servicing Limited (As Security Trustee)
    Transazioni
    • 02 ott 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 mar 2000Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 03 mar 2000Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 16 giu 2000Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 30 gen 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    IGROUP3 LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    06 nov 2017Inizio della liquidazione
    13 lug 2018Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Sean Kenneth Croston
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praticante
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0