HARMONY PUB COMPANY TRADING LIMITED

HARMONY PUB COMPANY TRADING LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHARMONY PUB COMPANY TRADING LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03732095
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HARMONY PUB COMPANY TRADING LIMITED?

    • Commercio al dettaglio di bevande in negozi specializzati (47250) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
    • Pub e bar (56302) / Attività di alloggio e di ristorazione
    • Locazione e gestione di immobili di società di edilizia residenziale (68201) / Attività immobiliari

    Dove si trova HARMONY PUB COMPANY TRADING LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HARMONY PUB COMPANY TRADING LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HERITAGE PUB COMPANY TRADING LIMITED15 apr 200315 apr 2003
    ATLASWAY 1 LTD12 mar 199912 mar 1999

    Quali sono gli ultimi bilanci di HARMONY PUB COMPANY TRADING LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al01 giu 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per HARMONY PUB COMPANY TRADING LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per HARMONY PUB COMPANY TRADING LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    9 pagine4.71

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 18 mag 2015

    8 pagine4.68

    Cessazione della carica di Glenn Pearson come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Andrew Clifford come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Kevin Georgel come amministratore

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da * 150 Aldersgate Street London EC1A 4EJ* in data 05 giu 2014

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    2 pagine600

    Risoluzione di insolvenza

    Resolution insolvency:business of liquidator
    1 pagineLIQ MISC RES

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione

    LRESSP

    Soddisfazione dell'onere 037320950009 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 037320950010 in pieno

    1 pagineMR04

    Bilancio annuale redatto al 12 mar 2014 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital12 mar 2014

    Stato del capitale al 12 mar 2014

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Cessazione della carica di Jonathan Paveley come amministratore

    2 pagineTM01

    Bilancio redatto al 01 giu 2013

    13 pagineAA

    Memorandum e Statuto

    10 pagineMEM/ARTS

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di autorità per acquistare un numero di azioni

    RES09
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum di Associazione

    RES01

    Iscrizione dell'ipoteca 037320950010

    53 pagineMR01

    Iscrizione dell'ipoteca 037320950009

    87 pagineMR01

    Bilancio annuale redatto al 12 mar 2013 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01

    Bilancio redatto al 26 mag 2012

    14 pagineAA

    legacy

    6 pagineMG02

    legacy

    5 pagineMG02

    Dettagli del direttore cambiati per Glenn Pearson il 28 set 2012

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di HARMONY PUB COMPANY TRADING LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    A G SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Segretario
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    90084920001
    GROSS, Milton
    86 Filey Avenue
    N16 6JJ London
    Segretario
    86 Filey Avenue
    N16 6JJ London
    Usa2986750004
    INGHAM, Michael Harry Peter
    3 Lauriston Road
    Wimbledon
    SW19 4TJ London
    Segretario
    3 Lauriston Road
    Wimbledon
    SW19 4TJ London
    British2739650001
    NIEDERMAN, Rivka
    Jessam Avenue
    E5 9DU London
    30
    Segretario
    Jessam Avenue
    E5 9DU London
    30
    British113503670001
    FORM 10 SECRETARIES FD LTD
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    Segretario nominato
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    900014000001
    BROWN, Aaron Maxwell
    11 Carlyle Close
    N2 0QU London
    Amministratore
    11 Carlyle Close
    N2 0QU London
    AmericanDirector98928830001
    CLIFFORD, Andrew Francis James
    Steam Mill Business Centre
    Steam Mill Street
    CH3 5AN Chester
    Suite H3
    United Kingdom
    Amministratore
    Steam Mill Business Centre
    Steam Mill Street
    CH3 5AN Chester
    Suite H3
    United Kingdom
    EnglandBritishProperty Director119327230001
    D'ARCY, Lynne
    5 Winwick Park Avenue
    WA2 8XB Warrington
    Cheshire
    Amministratore
    5 Winwick Park Avenue
    WA2 8XB Warrington
    Cheshire
    United KingdomBritishCompany Director106840540001
    FINNEY, Francis John
    Summers End
    8 Weaverlake
    DE13 8AD Yoxall
    Staffordshire
    Amministratore
    Summers End
    8 Weaverlake
    DE13 8AD Yoxall
    Staffordshire
    EnglandBritishDirector89286280002
    GEORGEL, Kevin Roger
    Steam Mill Street
    CH3 5AN Chester
    Suite H3 Steam Mill Business Centre
    Amministratore
    Steam Mill Street
    CH3 5AN Chester
    Suite H3 Steam Mill Business Centre
    United KingdomBritishManaging Director153480970001
    GROSS, Milton
    86 Filey Avenue
    N16 6JJ London
    Amministratore
    86 Filey Avenue
    N16 6JJ London
    UsaDirector2986750004
    HARRISON, David John
    Main Street
    Winster
    DE4 2DH Matlock
    The Archway
    Derbyshire
    Amministratore
    Main Street
    Winster
    DE4 2DH Matlock
    The Archway
    Derbyshire
    United KingdomBritishChartered Accountant62175190001
    LANDESBERG, Alan
    Allingham Court
    44 The Bishops Avenue Hampstead
    N2 OBA London
    Flat 3,
    Amministratore
    Allingham Court
    44 The Bishops Avenue Hampstead
    N2 OBA London
    Flat 3,
    EnglandBritishCompany Director142883260001
    LANDESBERG, Gary Mitchell
    122 Wigmore Street
    W1U 3RX London
    Amministratore
    122 Wigmore Street
    W1U 3RX London
    United KingdomBritishCompany Director54137480002
    O'NEILL, John
    Westbourne
    Gorse Bank Lane, Baslow
    DE45 1SG Bakewell
    Derbyshire
    Amministratore
    Westbourne
    Gorse Bank Lane, Baslow
    DE45 1SG Bakewell
    Derbyshire
    BritishDirector89254470001
    PAVELEY, Jonathan David, Dr
    Steam Mill Street
    CH3 5AN Chester
    Suite H3 Steam Mill Business Centre
    Amministratore
    Steam Mill Street
    CH3 5AN Chester
    Suite H3 Steam Mill Business Centre
    United KingdomBritishCompany Director100582600002
    PEARSON, Glenn
    Steam Mill Business Centre
    Steam Mill Street
    CH3 5AN Chester
    Suite H3
    United Kingdom
    Amministratore
    Steam Mill Business Centre
    Steam Mill Street
    CH3 5AN Chester
    Suite H3
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant Cfo123243570001
    PERCY, Andrew Graeme
    5 Carlton Avenue
    SK9 4EP Wilmslow
    Cheshire
    Amministratore
    5 Carlton Avenue
    SK9 4EP Wilmslow
    Cheshire
    BritishCompany Director53017070002
    ROSENBERG, David
    Green Verges
    Priory Drive
    HA7 3HL Stanmore
    Middlesex
    Amministratore
    Green Verges
    Priory Drive
    HA7 3HL Stanmore
    Middlesex
    EnglandBritishCompany Director2541410004
    ROSENBERG, Elliot Simon
    Brooklands 33 Linksway
    HA6 2XA Northwood
    Middlesex
    Amministratore
    Brooklands 33 Linksway
    HA6 2XA Northwood
    Middlesex
    EnglandBritishDirector2541420006
    SCHREIBER, David
    143 Upper Clapton Road
    E5 9DB London
    Amministratore
    143 Upper Clapton Road
    E5 9DB London
    EnglandBritishDirector75594970001
    SCHREIBER, Jacob
    10 Gilda Crescent
    N16 6JP London
    Amministratore
    10 Gilda Crescent
    N16 6JP London
    United KingdomBritishDirector67574090001
    SMALLEY, Timothy John
    Chivers Road
    CM15 0LG Stondon Massey
    Stondon Place
    Essex
    Amministratore
    Chivers Road
    CM15 0LG Stondon Massey
    Stondon Place
    Essex
    United KingdomBritishDirector102593650002
    WILSON, Hugh Wingate
    The Home Farm
    Fenton Road Stubton
    NG23 5DB Newark
    Nottinghamshire
    Amministratore
    The Home Farm
    Fenton Road Stubton
    NG23 5DB Newark
    Nottinghamshire
    BritishCompany Director89126810001
    FORM 10 DIRECTORS FD LTD
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    Amministratore delegato nominato
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    900013990001

    HARMONY PUB COMPANY TRADING LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 27 giu 2013
    Consegnato il 12 lug 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Admiral Taverns Bidco Limited
    Transazioni
    • 12 lug 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 15 mag 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 27 giu 2013
    Consegnato il 09 lug 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • U.S. Bank Trustees Limited (As Security Agent and Trustee for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 09 lug 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 16 mag 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 17 nov 2009
    Consegnato il 02 dic 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC in Its Capacity as Security Trustee
    Transazioni
    • 02 dic 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 27 dic 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 17 nov 2009
    Consegnato il 02 dic 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first legal mortgage the original property: and all estates or interests in f/h, l/h or commonhold property and which is owned by the chargor as at the date of the debenture, and in each case, all premises and fixtures on such property for the time being. By way of fixed charge all other estates or interests in f/h, l/h or commonhold property: the proceeds of sale of its secured property and all licences to enter on or use any secured property see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Admiral Taverns Bidco Limited
    Transazioni
    • 02 dic 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 27 dic 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 30 gen 2009
    Consegnato il 07 feb 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 07 feb 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 dic 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 24 lug 2007
    Consegnato il 04 ago 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Irish Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 04 ago 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 dic 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 24 lug 2007
    Consegnato il 02 ago 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 02 ago 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 dic 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 08 ago 2005
    Consegnato il 13 ago 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Irish Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 13 ago 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment of keyman
    Creato il 24 nov 2003
    Consegnato il 25 nov 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The policies, all sums assured by them and all bonuses and benefits which may arise under them and the company's whole right title and interest in the policy no's 0102078318, 0102078318 and 0102077781. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 25 nov 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 15 apr 2003
    Consegnato il 19 apr 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 19 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    HARMONY PUB COMPANY TRADING LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    19 mag 2014Inizio della liquidazione
    15 giu 2016Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Colin Peter Dempster
    Ten George Street
    EH2 2DZ Edinburgh
    Praticante
    Ten George Street
    EH2 2DZ Edinburgh
    Derek Hyslop
    10 George Street
    EH2 2DZ Edinburgh
    Praticante
    10 George Street
    EH2 2DZ Edinburgh

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0