INDUSTRIAL DORMANT LIMITED

INDUSTRIAL DORMANT LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàINDUSTRIAL DORMANT LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03734948
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di INDUSTRIAL DORMANT LIMITED?

    • Commercio all'ingrosso di altri combustibili e prodotti connessi (46719) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

    Dove si trova INDUSTRIAL DORMANT LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    West Terrace
    Esh Winning
    DH7 9PT Durham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di INDUSTRIAL DORMANT LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HARGREAVES INDUSTRIAL DORMANT LIMITED02 giu 201402 giu 2014
    HARGREAVES INDUSTRIAL SERVICES LIMITED05 lug 200105 lug 2001
    NORTH EAST LAND DEVELOPMENT LIMITED17 mar 199917 mar 1999

    Quali sono gli ultimi bilanci di INDUSTRIAL DORMANT LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mag 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per INDUSTRIAL DORMANT LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01
    X9EZQSY1

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mag 2020

    10 pagineAA
    A9EN7WAH

    Dichiarazione di conformità presentata il 17 mar 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01
    X910IBJ6

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name31 ott 2019

    Cambio di nome" per delibera

    NM01
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 30 ott 2019

    RES15
    X8H5J9LK

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mag 2019

    10 pagineAA
    A8DEJ65E

    Nomina di Hargreaves Corporate Director Limited come amministratore in data 31 lug 2019

    2 pagineAP02
    X8AWCBKR

    Dichiarazione di conformità presentata il 17 mar 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01
    X81PE8HM

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mag 2018

    10 pagineAA
    A7WY0GSW

    Cessazione della carica di Julie May Haynes come amministratore in data 01 giu 2018

    1 pagineTM01
    X77JIN95

    Nomina di Mr John William Young Strachan Samuel come amministratore in data 22 mag 2018

    2 pagineAP01
    X76IBAUJ

    Nomina di Mr Gordon Frank Colenso Banham come amministratore in data 22 mag 2018

    2 pagineAP01
    X76IB5JC

    Dichiarazione di conformità presentata il 17 mar 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01
    X724BGJD

    Bilancio redatto al 31 mag 2017

    13 pagineAA
    A70MXQ2W

    Cessazione della carica di Kevin James Stewart Dougan come amministratore in data 01 dic 2017

    1 pagineTM01
    X6KLKL8A

    Nomina di Julie May Haynes come amministratore in data 01 dic 2017

    2 pagineAP01
    X6KLKKD6

    Cessazione della carica di Iain Duncan Cockburn come amministratore in data 03 ott 2017

    1 pagineTM01
    X6GFW0FS

    Dichiarazione di conformità presentata il 17 mar 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01
    X62U5N02

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mag 2016

    10 pagineAA
    A6174MIO

    Bilancio annuale redatto al 17 mar 2016 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital29 mar 2016

    Stato del capitale al 29 mar 2016

    • Capitale: GBP 1
    SH01
    X53SITVD

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mag 2015

    7 pagineAA
    A51NUNTU

    Bilancio annuale redatto al 17 mar 2015 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital19 mar 2015

    Stato del capitale al 19 mar 2015

    • Capitale: GBP 1
    SH01
    X43I19DK

    Bilancio redatto al 31 mag 2014

    9 pagineAA
    A420KJW9

    Dimissioni del revisore

    2 pagineAUD
    A3GQY04Q

    Chi sono gli amministratori di INDUSTRIAL DORMANT LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BANHAM, Gordon Frank Colenso
    West Terrace
    Esh Winning
    DH7 9PT Durham
    Amministratore
    West Terrace
    Esh Winning
    DH7 9PT Durham
    EnglandBritishDirector212097850001
    SAMUEL, John William Young Strachan
    West Terrace
    Esh Winning
    DH7 9PT Durham
    Amministratore
    West Terrace
    Esh Winning
    DH7 9PT Durham
    EnglandBritishDirector3909060002
    HARGREAVES CORPORATE DIRECTOR LIMITED
    Esh Winning
    DH7 9PT Durham
    West Terrace
    England
    Amministratore
    Esh Winning
    DH7 9PT Durham
    West Terrace
    England
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione11459305
    251432920001
    BROTHERSTON, Robert
    7 Heath Close
    NE11 9TF Gateshead
    Tyne & Wear
    Segretario
    7 Heath Close
    NE11 9TF Gateshead
    Tyne & Wear
    British52698550001
    HODGSON, Terence Michael
    50 Snows Green Road
    Shotley Bridge
    DH8 0ER Consett
    County Durham
    Segretario
    50 Snows Green Road
    Shotley Bridge
    DH8 0ER Consett
    County Durham
    British13281750007
    MACQUARRIE, Stephen Nigel
    West Terrace
    Esh Winning
    DH7 9PT Durham
    Segretario
    West Terrace
    Esh Winning
    DH7 9PT Durham
    British38438540006
    TEMPLE SECRETARIES LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Segretario nominato
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001120001
    BANHAM, Gordon Frank Colenso
    The Sands
    DH1 1NU Durham
    37 Ferens Park
    Co Durham
    Amministratore
    The Sands
    DH1 1NU Durham
    37 Ferens Park
    Co Durham
    United KingdomBritishDirector132506640001
    BIRKETT, John Paul
    130 Navigation Loop
    ST15 8ZH Stone
    Staffordshire
    Amministratore
    130 Navigation Loop
    ST15 8ZH Stone
    Staffordshire
    BritishManaging Director97156210001
    BROTHERSTON, Robert
    7 Heath Close
    NE11 9TF Gateshead
    Tyne & Wear
    Amministratore
    7 Heath Close
    NE11 9TF Gateshead
    Tyne & Wear
    United KingdomBritishAccountant52698550001
    COCKBURN, Iain Duncan
    West Terrace
    Esh Winning
    DH7 9PT Durham
    Amministratore
    West Terrace
    Esh Winning
    DH7 9PT Durham
    United KingdomBritishDirector53876310007
    DILLON, Peter Marshall
    Broomfield Bank Lane
    Upper Denby
    HD8 8UT Huddersfield
    West Yorkshire
    Amministratore
    Broomfield Bank Lane
    Upper Denby
    HD8 8UT Huddersfield
    West Yorkshire
    BritishChartered Accountant5143680001
    DOUGAN, Kevin James Stewart
    West Terrace
    Esh Winning
    DH7 9PT Durham
    Amministratore
    West Terrace
    Esh Winning
    DH7 9PT Durham
    EnglandBritishDirector8715190003
    DOUGAN, Kevin James Stewart
    1 Darley Court
    Plawsworth
    DH2 3LQ Chester Le Street
    County Durham
    Amministratore
    1 Darley Court
    Plawsworth
    DH2 3LQ Chester Le Street
    County Durham
    United KingdomBritishEngineer8715190001
    HAYNES, Julie May
    West Terrace
    Esh Winning
    DH7 9PT Durham
    Amministratore
    West Terrace
    Esh Winning
    DH7 9PT Durham
    EnglandBritishDirector227950140001
    HODGSON, Terence Michael
    50 Snows Green Road
    Shotley Bridge
    DH8 0ER Consett
    County Durham
    Amministratore
    50 Snows Green Road
    Shotley Bridge
    DH8 0ER Consett
    County Durham
    EnglandBritishCompany Director13281750007
    MACQUARRIE, Stephen Nigel
    9 Aykley Vale
    Aykley Heads
    DH1 5WA Durham City
    County Durham
    Amministratore
    9 Aykley Vale
    Aykley Heads
    DH1 5WA Durham City
    County Durham
    United KingdomBritishTown Planner38438540006
    SOWERBY, Neal
    24 Brookes Rise
    Langley Moor
    DH7 8XY Durham
    Amministratore
    24 Brookes Rise
    Langley Moor
    DH7 8XY Durham
    EnglandBritishTechnical Director62472480001
    YOUNG, Paul Andrew
    18 Kira Drive
    Pity Me
    DH1 5GU Durham
    Amministratore
    18 Kira Drive
    Pity Me
    DH1 5GU Durham
    BritishManaging Director62472150003
    YOUNG, Robert
    Townhead Farm
    Iveston
    DH8 7TD Consett
    Co Durham
    Amministratore
    Townhead Farm
    Iveston
    DH8 7TD Consett
    Co Durham
    EnglandBritishManaging Director3899280001

    Chi sono le persone con controllo significativo di INDUSTRIAL DORMANT LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Esh Winning
    DH7 9PT Durham
    West Terrace
    England
    06 apr 2016
    Esh Winning
    DH7 9PT Durham
    West Terrace
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 1985
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione4140051
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    INDUSTRIAL DORMANT LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Mortgage debenture
    Creato il 29 ago 2003
    Consegnato il 04 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Enterprise Finance Europe (UK) Limited
    Transazioni
    • 04 set 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 giu 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 18 mar 2002
    Consegnato il 25 mar 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transazioni
    • 25 mar 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 ott 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 27 nov 2000
    Consegnato il 05 dic 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever (including, without limitation, under the financing documents)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • G E Capital Commercial Finance Limited (The "Security Holder")
    Transazioni
    • 05 dic 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 giu 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    All assets debenture
    Creato il 13 ott 2000
    Consegnato il 24 ott 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Ge Capital Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 24 ott 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 giu 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0