BIS DATACENTRES LTD

BIS DATACENTRES LTD

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBIS DATACENTRES LTD
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03740487
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BIS DATACENTRES LTD?

    • Trattamento dei dati, hosting e attività correlate (63110) / Informazione e comunicazione

    Dove si trova BIS DATACENTRES LTD?

    Indirizzo della sede legale
    Commodity Quay
    St Katharine Docks
    E1W 1AZ London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BIS DATACENTRES LTD?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ABOVENET UK LIMITED22 mar 199922 mar 1999

    Quali sono gli ultimi bilanci di BIS DATACENTRES LTD?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2022

    Quali sono le ultime deposizioni per BIS DATACENTRES LTD?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2022

    6 pagineAA

    Cessazione della carica di Stylianos Karaolis come amministratore in data 11 mag 2022

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr David Colin Manuel come amministratore in data 11 mag 2022

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 04 mar 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Steven Keith Mitchell come amministratore in data 23 dic 2021

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Stylianos Karaolis come amministratore in data 15 dic 2021

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2021

    6 pagineAA

    Cessazione della carica di David Michael Howson come amministratore in data 12 mag 2021

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Simon Crawley-Trice come amministratore in data 12 mag 2021

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 04 mar 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 mar 2020

    6 pagineAA

    legacy

    59 paginePARENT_ACC

    legacy

    2 pagineAGREEMENT2

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    Dichiarazione di conformità presentata il 04 mar 2020 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Nomina di Mr Matthew Redding come segretario in data 28 ott 2019

    3 pagineAP03

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 mar 2019

    7 pagineAA

    legacy

    48 paginePARENT_ACC

    legacy

    2 pagineAGREEMENT2

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    Soddisfazione dell'onere 037404870007 in pieno

    1 pagineMR04

    legacy

    1 pagineSH20

    Chi sono gli amministratori di BIS DATACENTRES LTD?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    REDDING, Matthew
    St Katharine Docks
    E1W 1AZ London
    Commodity Quay
    United Kingdom
    Segretario
    St Katharine Docks
    E1W 1AZ London
    Commodity Quay
    United Kingdom
    264431440001
    CRAWLEY-TRICE, Simon
    St Katharine Docks
    E1W 1AZ London
    Commodity Quay
    Amministratore
    St Katharine Docks
    E1W 1AZ London
    Commodity Quay
    United KingdomBritish283625300001
    MANUEL, David Colin
    St Katharine Docks
    E1W 1AZ London
    Commodity Quay
    Amministratore
    St Katharine Docks
    E1W 1AZ London
    Commodity Quay
    EnglandBritish78406280002
    BOOTH, Andrew
    St Katharine Docks
    E1W 1AZ London
    Commodity Quay
    United Kingdom
    Segretario
    St Katharine Docks
    E1W 1AZ London
    Commodity Quay
    United Kingdom
    177300960001
    DE LISSER, Ferdinand George
    5 The Drive
    Wimbledon
    SW20 8TG London
    Segretario
    5 The Drive
    Wimbledon
    SW20 8TG London
    British93810330001
    LINTON, Georgina Charmaine
    Flat 3, 29 Saint Gabriels Road
    NW2 4DT London
    Segretario
    Flat 3, 29 Saint Gabriels Road
    NW2 4DT London
    British74271030001
    MCSWEEN, Angus
    5 Ellergreen Road
    Bearsden
    G61 2RU Glasgow
    Scotland
    Segretario
    5 Ellergreen Road
    Bearsden
    G61 2RU Glasgow
    Scotland
    British50499250001
    WADLER, Arnold L
    85 School Road East
    07746 Marlboro
    New Jersey
    Usa
    Segretario
    85 School Road East
    07746 Marlboro
    New Jersey
    Usa
    Us52556910001
    WEDGE, Andrew Neil
    106 Bushy Park Road
    TW11 9DL Teddington
    Middlesex
    Segretario
    106 Bushy Park Road
    TW11 9DL Teddington
    Middlesex
    British83050670001
    ABOGADO NOMINEES LIMITED
    100 New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    Segretario
    100 New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    73539350001
    MD SECRETARIES LIMITED
    C/0 Mcgrigors Llp
    141 Bothwell Street
    G2 7EQ Glasgow
    Segretario nominato
    C/0 Mcgrigors Llp
    141 Bothwell Street
    G2 7EQ Glasgow
    900005110001
    BENEDETTO, Gerard
    36 Old Trolly Road
    06877 Ridgefield
    Ct Usa
    Amministratore
    36 Old Trolly Road
    06877 Ridgefield
    Ct Usa
    American74339480001
    CHAPMAN, Kirsty
    St Katharine Docks
    E1W 1AZ London
    Commodity Quay
    Amministratore
    St Katharine Docks
    E1W 1AZ London
    Commodity Quay
    EnglandBritish237752510001
    DE LISSER, Ferdinand George
    The Drive
    SW20 8TG London
    5
    England
    Amministratore
    The Drive
    SW20 8TG London
    5
    England
    EnglandBritish93810330001
    DOBBIE, William
    32 Saxe Coburg Place
    EH3 5BP Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    32 Saxe Coburg Place
    EH3 5BP Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish107339410001
    DOWBIGGIN, John
    47 Goodhart Place
    Limehouse
    E14 8EQ London
    Amministratore
    47 Goodhart Place
    Limehouse
    E14 8EQ London
    British79349610002
    DOWBIGGIN, John Ross
    Coulsdon Road
    Old Coulsdon
    CR5 2LD Croydon
    47
    Surrey
    Amministratore
    Coulsdon Road
    Old Coulsdon
    CR5 2LD Croydon
    47
    Surrey
    United KingdomBritish129698260001
    GRANT, Anthony Bryce
    King William Street
    EC4R 9AS London
    33
    England
    Amministratore
    King William Street
    EC4R 9AS London
    33
    England
    EnglandBritish80908880001
    HOWE, Adrian Trevor
    St Katharine Docks
    E1W 1AZ London
    Commodity Quay
    Amministratore
    St Katharine Docks
    E1W 1AZ London
    Commodity Quay
    EnglandBritish130448940002
    HOWSON, David Michael
    St Katharine Docks
    E1W 1AZ London
    Commodity Quay
    Amministratore
    St Katharine Docks
    E1W 1AZ London
    Commodity Quay
    EnglandBritish224111570002
    ING, Michael Andrew
    St Katharine Docks
    E1W 1AZ London
    Commodity Quay
    Amministratore
    St Katharine Docks
    E1W 1AZ London
    Commodity Quay
    United KingdomBritish199320020001
    JOHNS, Peter Michael
    4 Court Royal Mews
    SO15 2TU Southampton
    Hampshire
    Amministratore
    4 Court Royal Mews
    SO15 2TU Southampton
    Hampshire
    British55651330002
    KARAOLIS, Stylianos
    St Katharine Docks
    E1W 1AZ London
    Commodity Quay
    Amministratore
    St Katharine Docks
    E1W 1AZ London
    Commodity Quay
    United KingdomBritish290867510001
    LAY, Randall Robert
    360 Hamilton Avenue
    White Plains
    New York
    10601
    Usa
    Amministratore
    360 Hamilton Avenue
    White Plains
    New York
    10601
    Usa
    American79348250001
    MCSWEEN, Angus
    5 Ellergreen Road
    Bearsden
    G61 2RU Glasgow
    Scotland
    Amministratore
    5 Ellergreen Road
    Bearsden
    G61 2RU Glasgow
    Scotland
    ScotlandBritish50499250001
    MILLS, Alastair Richard
    St Katherine Docks
    E1W 1AZ London
    Commodity Quay
    United Kingdom
    Amministratore
    St Katherine Docks
    E1W 1AZ London
    Commodity Quay
    United Kingdom
    EnglandBritish108612460002
    MITCHELL, Steven Keith
    St Katharine Docks
    E1W 1AZ London
    Commodity Quay
    Amministratore
    St Katharine Docks
    E1W 1AZ London
    Commodity Quay
    United KingdomBritish166684410001
    PYEMONT, Peter David
    The Woll
    TD7 4NY Ashkirk
    Selkirkshire
    Amministratore
    The Woll
    TD7 4NY Ashkirk
    Selkirkshire
    ScotlandBritish72248250006
    PYEMONT, Samantha
    The Woll
    TD7 4NY Ashkirk
    Selkirkshire
    Amministratore
    The Woll
    TD7 4NY Ashkirk
    Selkirkshire
    United KingdomBritish117672670001
    RAND, David
    15864 Highland Drive
    San Jose
    FOREIGN California
    95127
    Usa
    Amministratore
    15864 Highland Drive
    San Jose
    FOREIGN California
    95127
    Usa
    American69473610001
    SMITH, Ronald Watson
    St Katherine Docks
    E1W 1AZ London
    Commodity Quay
    United Kingdom
    Amministratore
    St Katherine Docks
    E1W 1AZ London
    Commodity Quay
    United Kingdom
    EnglandBritish62182300001
    SPAGNOLO, Mark Francis
    360 Hamilton Avenue
    White Plains
    New York
    10601
    Usa
    Amministratore
    360 Hamilton Avenue
    White Plains
    New York
    10601
    Usa
    American79348190001
    STEINER, Paul, Dr
    3897 Corina Way
    94303 Palo Alto
    California
    Usa
    Amministratore
    3897 Corina Way
    94303 Palo Alto
    California
    Usa
    Austrian64092980001
    TANZI, Nicholas Martin
    5 Briscoe Chase
    07456 Ringwood
    New Jersey Usa
    Amministratore
    5 Briscoe Chase
    07456 Ringwood
    New Jersey Usa
    American74339240001
    TAYLOR, Ian Frederick
    31 Rushenden Furlong
    LU7 9QX Pitstone
    Bedfordshire
    Amministratore
    31 Rushenden Furlong
    LU7 9QX Pitstone
    Bedfordshire
    British78598110001

    Chi sono le persone con controllo significativo di BIS DATACENTRES LTD?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Bis Limited
    St Katharine Docks
    E1W 1AZ London
    Commodity Quay
    England
    06 apr 2016
    St Katharine Docks
    E1W 1AZ London
    Commodity Quay
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    BIS DATACENTRES LTD ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 26 ott 2015
    Consegnato il 26 ott 2015
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Axa Private Debt Iii Sàrl
    Transazioni
    • 26 ott 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 15 apr 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 26 mar 2013
    Consegnato il 08 apr 2013
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each charging company and each obligor to the chargee and the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Penta Capital LLP (As Security Trustee)
    Transazioni
    • 08 apr 2013Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 16 set 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 26 mar 2013
    Consegnato il 08 apr 2013
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each charging company and each obligor to the chargee and the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Penta Capital LLP (As Security Trustee)
    Transazioni
    • 08 apr 2013Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 16 set 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 26 mar 2013
    Consegnato il 05 apr 2013
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited (the "Security Agent")
    Transazioni
    • 05 apr 2013Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 16 set 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 05 set 2007
    Consegnato il 12 set 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 12 set 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 mag 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charge over shares
    Creato il 15 nov 2006
    Consegnato il 28 nov 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £675,000 due or to become due from the company to
    Brevi particolari
    658,853,300 ordinary b shares and 439,235,500 ordinary a shares in abovenet UK limited.
    Persone aventi diritto
    • Abovenet, Inc and Abovenet Communications, Inc
    Transazioni
    • 28 nov 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 20 giu 2000
    Consegnato il 29 giu 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Rent service charges insurance premiums or other contribution to the cost of insurance of the premises,outgoings value added tax and other payments payable to or recoverable by east india dock (building two) limited ("the landlord"),or in respect of which the landlord is entitled to be indemnified by abovenet UK limited ("the tenant") under the agreement for lease of even date; claims demands damages losses costs and expenses arising out of or incidental to breach by the tenant of the covenants and conditions in the lease or of obligations in the deed
    Brevi particolari
    The tenant's interest in the interest-bearing account maintained at a UK clearing bank by the landlord in which to hold the sum which the tenant has provided to the landlord to meet liabilities which are for the time being unexpended (the initial sum being £88,125).
    Persone aventi diritto
    • East India Dock (Building Two) Limited
    Transazioni
    • 29 giu 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 dic 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0