WORKSPACE 5 LIMITED

WORKSPACE 5 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàWORKSPACE 5 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03741554
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di WORKSPACE 5 LIMITED?

    • Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari

    Dove si trova WORKSPACE 5 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Canterbury Court Kennington Park
    1-3 Brixton Road
    SW9 6DE London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di WORKSPACE 5 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    INNERSCOPE LIMITED26 mar 199926 mar 1999

    Quali sono gli ultimi bilanci di WORKSPACE 5 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per WORKSPACE 5 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 21 feb 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2016

    4 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da Chester House Kennington Park 1-3 Brixton Road London SW9 6DE a Canterbury Court Kennington Park 1-3 Brixton Road London SW9 6DE in data 01 nov 2016

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 21 feb 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital24 feb 2016

    Stato del capitale al 24 feb 2016

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2015

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 21 feb 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital26 feb 2015

    Stato del capitale al 26 feb 2015

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2014

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 21 feb 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital17 mar 2014

    Stato del capitale al 17 mar 2014

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2013

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 21 feb 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2012

    4 pagineAA

    Nomina di Mr Jameson Paul Hopkins come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Harry Platt come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 21 feb 2012 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2011

    4 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da * Magenta House 85 Whitechapel Road London E1 1DU* in data 29 lug 2011

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 21 feb 2011 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Graham Colin Clement il 02 mar 2011

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Harry Platt il 19 ott 2010

    2 pagineCH01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2010

    4 pagineAA

    legacy

    3 pagineMG02

    Chi sono gli amministratori di WORKSPACE 5 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CARFORA, Carmelina
    Kennington Park
    1-3 Brixton Road
    SW9 6DE London
    Canterbury Court
    England
    Segretario
    Kennington Park
    1-3 Brixton Road
    SW9 6DE London
    Canterbury Court
    England
    150286860001
    CLEMETT, Graham Colin
    Kennington Park
    1-3 Brixton Road
    SW9 6DE London
    Canterbury Court
    England
    Amministratore
    Kennington Park
    1-3 Brixton Road
    SW9 6DE London
    Canterbury Court
    England
    United KingdomBritish123744930001
    HOPKINS, Jameson Paul
    Kennington Park
    1-3 Brixton Road
    SW9 6DE London
    Canterbury Court
    England
    Amministratore
    Kennington Park
    1-3 Brixton Road
    SW9 6DE London
    Canterbury Court
    England
    United KingdomBritish79842180002
    BINNS, Adam
    15 Langhams Way
    Wargrave
    RG10 8AX Reading
    Berkshire
    Segretario
    15 Langhams Way
    Wargrave
    RG10 8AX Reading
    Berkshire
    British113638490001
    MACDONALD, Iain Graham Ross
    172 White Hill
    HP5 1AZ Chesham
    Buckinghamshire
    Segretario
    172 White Hill
    HP5 1AZ Chesham
    Buckinghamshire
    British66669510002
    SAHA, Nirmal Chandra
    Sutherland
    Old Avenue
    KT13 0PQ Weybridge
    Surrey
    Segretario
    Sutherland
    Old Avenue
    KT13 0PQ Weybridge
    Surrey
    British31811850002
    TAYLOR, Robert Mark
    15 Hollow Way Lane
    HP6 6DJ Amersham
    Buckinghamshire
    Segretario
    15 Hollow Way Lane
    HP6 6DJ Amersham
    Buckinghamshire
    British43039830001
    WALDMAN, Matthew
    195 Broomwood Road
    SW11 6JX London
    Segretario
    195 Broomwood Road
    SW11 6JX London
    British64012810001
    WHALLEY, Amanda
    12 Merchant Court
    61 Wapping Wall Wapping
    E1W 3SD London
    Segretario
    12 Merchant Court
    61 Wapping Wall Wapping
    E1W 3SD London
    British124348320001
    THE COMPANY REGISTRATION AGENTS LIMITED
    Leonard Street
    EC2A 4QS London
    83
    Segretario nominato
    Leonard Street
    EC2A 4QS London
    83
    900013740001
    BAMBER, Claire
    14b Rastell Avenue
    SW2 4XP London
    Amministratore
    14b Rastell Avenue
    SW2 4XP London
    Irish64346470003
    CARRAGHER, Madeleine
    17 Stadium Street
    Chelsea
    SW10 0PU London
    Amministratore
    17 Stadium Street
    Chelsea
    SW10 0PU London
    British46150230001
    MARPLES, James Patrick
    Churchfield
    All Saints Lane Sutton Courtenay
    OX14 4AG Abingdon
    Oxfordshire
    Amministratore
    Churchfield
    All Saints Lane Sutton Courtenay
    OX14 4AG Abingdon
    Oxfordshire
    British57707320002
    PLATT, Harry
    Kennington Park
    1-3 Brixton Road
    SW9 6DE London
    Chester House
    United Kingdom
    Amministratore
    Kennington Park
    1-3 Brixton Road
    SW9 6DE London
    Chester House
    United Kingdom
    United KingdomBritish41914500003
    PORTER, Alan Redvers
    The Clock House
    Horsham Road Capel
    RH5 5JJ Dorking
    Surrey
    Amministratore
    The Clock House
    Horsham Road Capel
    RH5 5JJ Dorking
    Surrey
    British17838310001
    TAYLOR, Robert Mark
    15 Hollow Way Lane
    HP6 6DJ Amersham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    15 Hollow Way Lane
    HP6 6DJ Amersham
    Buckinghamshire
    British43039830001
    WALDMAN, Matthew
    195 Broomwood Road
    SW11 6JX London
    Amministratore
    195 Broomwood Road
    SW11 6JX London
    British64012810001
    LUCIENE JAMES LIMITED
    83 Leonard Street
    EC2A 4QS London
    Amministratore delegato nominato
    83 Leonard Street
    EC2A 4QS London
    900003210001

    Chi sono le persone con controllo significativo di WORKSPACE 5 LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Workspace Glebe Limited
    Kennington Park
    1-3 Brixton Road
    SW9 6DE London
    Canterbury Court
    England
    06 apr 2016
    Kennington Park
    1-3 Brixton Road
    SW9 6DE London
    Canterbury Court
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Autorità legaleEngland And Wales
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    WORKSPACE 5 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Supplemental debenture supplemental to a debenture dated 15 july 2002 and
    Creato il 24 ago 2005
    Consegnato il 31 ago 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from an obligor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The new property being the f/h land known as grand union centre north kensington london t/n NGL608575 all buildings and fixtures, and all rights to any proceeds of sale,. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bradford & Bingley PLC as Security Trustee for Each of the Finance Parties
    Transazioni
    • 31 ago 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 lug 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Supplemental debenture supplemental to a debenture dated 15 july 2002 and
    Creato il 18 ago 2003
    Consegnato il 20 ago 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from an obligor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Aladdin business centre, long drive, greenford, middlesex t/n MX128991, farnborough business centre, eelmore road, farnborough, GU15 7XA t/n HP354443, romford seedbed centre, davidson way, romford, essex t/n EGL226569 (refer to form 395 for further details). By way of fixed charge all buildings and fixtures, all rights to and interest in any proceeds of sale. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bradford & Bingley PLC as Security Trustee for Each of the Finance Parties
    Transazioni
    • 20 ago 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 mag 2006Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 07 lug 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 15 lug 2002
    Consegnato il 25 lug 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All and any monies obligations and liabilities due or to become due from an obligor to the chargee as security trustee for each of the finance parties (the "security trustee") on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bradford & Bingley PLC
    Transazioni
    • 25 lug 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 giu 2005Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 07 lug 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A supplemental debenture made between workspace 3 limited, workspace 4 limited, workspace 5 limited (together the "companies" and each a "company") and westdeutsche landesbank girozentrale
    Creato il 09 dic 1999
    Consegnato il 20 dic 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations and liabilities of each obligor to the finance parties or any of them under each of the finance documents (all defined therein)
    Brevi particolari
    Its right title and interest in all present and future agreements contracts deeds licences undertakings in respect of its mortgaged property. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Westdeutsche Landesbank Girozentrale
    Transazioni
    • 20 dic 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 lug 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security agreement made between workspace 1 limited, workspace 3 limited, workspace 4 limited, workspace 5 limited (together the company, the obligors and each a obligor), workspace holdings limited (wh) and westdeutsche landesbank girozentrale (the trustee)
    Creato il 22 nov 1999
    Consegnato il 08 dic 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities of the company to the trustee under each of the finance documents (as defined)
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge the investment security accounts which means the investment collection account - account no.8637261 And the investment disbursements account - account no.8632278. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Westdeutsche Landesbank Girozentrale (The Trustee)
    Transazioni
    • 08 dic 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 lug 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 23 lug 1999
    Consegnato il 06 ago 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Westdeutsche Landesbank Girozentrale
    Transazioni
    • 06 ago 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 dic 1999Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 17 lug 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0