TRADE AUTOMOTIVE FINANCE LIMITED

TRADE AUTOMOTIVE FINANCE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTRADE AUTOMOTIVE FINANCE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03741574
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TRADE AUTOMOTIVE FINANCE LIMITED?

    • Leasing finanziario (64910) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova TRADE AUTOMOTIVE FINANCE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    15 High Street
    NN13 7DH Brackley
    Northamptonshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di TRADE AUTOMOTIVE FINANCE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 apr 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per TRADE AUTOMOTIVE FINANCE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 apr 2016

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 26 mar 2016 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital21 apr 2016

    Stato del capitale al 21 apr 2016

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 apr 2015

    6 pagineAA

    Cessazione della carica di Robin John Cook come amministratore in data 30 lug 2015

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Karl Durham come amministratore in data 30 lug 2015

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 26 mar 2015 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital07 apr 2015

    Stato del capitale al 07 apr 2015

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 apr 2014

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 26 mar 2014 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital01 mag 2014

    Stato del capitale al 01 mag 2014

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 apr 2013

    6 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da * 110 Regent Road Leicester Leicestershire LE1 7LT* in data 09 dic 2013

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Graham Brewin come amministratore

    2 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Robin John Cook il 26 mar 2013

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 26 mar 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 apr 2012

    4 pagineAA

    Cessazione della carica di Graham Waters come segretario

    2 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 26 mar 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Cessazione della carica di Nigel Hecks come amministratore

    2 pagineTM01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 apr 2011

    5 pagineAA

    Nomina di Robin John Cook come amministratore

    3 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 26 mar 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Graham Albert Brewin il 26 mar 2011

    2 pagineCH01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 apr 2010

    6 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di TRADE AUTOMOTIVE FINANCE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    DURHAM, Karl
    NN13 7DH Brackley
    15 High Street
    Northamptonshire
    United Kingdom
    Amministratore
    NN13 7DH Brackley
    15 High Street
    Northamptonshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector70998490005
    BUDDEN, Glenys
    10 Methuen Avenue
    Fulwood
    PR2 9QX Preston
    Segretario
    10 Methuen Avenue
    Fulwood
    PR2 9QX Preston
    British62652640001
    PHILLIPS, Christopher John
    15 The Hollow
    Mickleover
    DE3 0DH Derby
    Segretario
    15 The Hollow
    Mickleover
    DE3 0DH Derby
    BritishAccountant41522550001
    WATERS, Graham Edward
    Warren Hills Cottage
    Warren Hills Road
    LE67 4UY Coalville
    Leicestershire
    Segretario
    Warren Hills Cottage
    Warren Hills Road
    LE67 4UY Coalville
    Leicestershire
    British74322660001
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Segretario nominato
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    BREWIN, Graham Albert
    Princes Close
    Anstey
    LE7 7EG Leicester
    9
    Amministratore
    Princes Close
    Anstey
    LE7 7EG Leicester
    9
    EnglandBritishFinancial Consultant110453300002
    COOK, Robin John
    Wildmere Road
    Wildmere Industrial Estate
    OX16 3JU Banbury
    18
    Oxfordshire
    England
    Amministratore
    Wildmere Road
    Wildmere Industrial Estate
    OX16 3JU Banbury
    18
    Oxfordshire
    England
    EnglandBritishExecutive Director159984450002
    HECKS, Nigel Adrian
    Red Hill Barn Cottage
    Burton Bandalls Cotes
    LE12 5TE Loughborough
    Leicestershire
    Amministratore
    Red Hill Barn Cottage
    Burton Bandalls Cotes
    LE12 5TE Loughborough
    Leicestershire
    United KingdomBritishMotor Factor5298250001
    LONDON LAW SERVICES LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Amministratore delegato nominato
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001500001

    TRADE AUTOMOTIVE FINANCE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of assignment in respect of repurchase agreement given by trade automotive supplies LTD
    Creato il 23 ott 2000
    Consegnato il 27 ott 2000
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the company's title rights and interest whatsoever in and to all the hire contracts including the right to receive the hire debts and all equipment from time to time purchased by the company from ing pursuant to an option given by the company by ing. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ing Lease (UK) Limited
    Transazioni
    • 27 ott 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed of assignment in respect of repurchase agreement given by ravewhite LTD t/a grove motor colours
    Creato il 23 ott 2000
    Consegnato il 27 ott 2000
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All rights and interest whatsoever in and to all the hire contracts and the right to receive the hire debts and all equipment from time to time purchased pursuant to an option given to the company by ing.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ing Lease (UK) Limited
    Transazioni
    • 27 ott 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed of assignment in respect of repurchase agreement given by hex holdings LTD
    Creato il 02 ott 2000
    Consegnato il 11 ott 2000
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All rights title and interest in and to all the hire contracts including the hire debts and all equipment (as defined therein). See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ing Lease (UK) LTD
    Transazioni
    • 11 ott 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    Block discounting agreement
    Creato il 23 set 1999
    Consegnato il 25 set 1999
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    First floating charge over all indebtedness whatsoever with all guarantees and securities therefore; all rights,title and other rights,liens and indemnities. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hitachi Credit (U.K.) PLC
    Transazioni
    • 25 set 1999Registrazione di un'ipoteca (395)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0