IMPEY SHOWERS LTD

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàIMPEY SHOWERS LTD
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03742299
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di IMPEY SHOWERS LTD?

    • Fabbricazione di altri mobili n.c.a. (31090) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova IMPEY SHOWERS LTD?

    Indirizzo della sede legale
    Conquest Business Park
    Cad Rd
    TA19 9EA Ilton
    Somerset
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di IMPEY SHOWERS LTD?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    IMPEY UK LTD16 feb 200416 feb 2004
    CREATIVE HEALTHCARE LTD.29 mar 199929 mar 1999

    Quali sono gli ultimi bilanci di IMPEY SHOWERS LTD?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per IMPEY SHOWERS LTD?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Cessazione della carica di John Kenneth Blackburn come amministratore in data 01 dic 2020

    1 pagineTM01

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Nomina di Mr Stephen Richard Huntly come amministratore in data 01 dic 2020

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 29 mar 2020 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Cessazione della carica di Robert Alan Jarvis come amministratore in data 18 dic 2019

    1 pagineTM01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 20 dic 2019

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Indirizzo della sede legale modificato da Building 3 Stanmore Industrial Estate Bridgnorth Shropshire WV15 5HP a Conquest Business Park Cad Rd Ilton Somerset TA19 9EA in data 01 nov 2019

    1 pagineAD01

    Bilancio redatto al 31 dic 2018

    22 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 29 mar 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Soddisfazione dell'onere 037422990010 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 9 in pieno

    2 pagineMR04

    Bilancio redatto al 31 dic 2017

    20 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 29 mar 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2016

    20 pagineAA

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Conquest House Conquest Business Park Cad Road Ilton, Ilminster Somerset TA19 9EA England a 4a Stanmore Industrial Estate Bridgnorth WV15 5HP

    1 pagineAD02

    Dichiarazione di conformità presentata il 29 mar 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Nomina di Mr Mark Richard Dain come segretario in data 31 ago 2016

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Renee Teresa Barrett come amministratore in data 31 ago 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Renee Teresa Barrett come segretario in data 31 ago 2016

    1 pagineTM02

    Chi sono gli amministratori di IMPEY SHOWERS LTD?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    DAIN, Mark Richard
    Cad Rd
    TA19 9EA Ilton
    Conquest Business Park
    Somerset
    England
    Segretario
    Cad Rd
    TA19 9EA Ilton
    Conquest Business Park
    Somerset
    England
    218748320001
    DAIN, Mark Richard
    Cad Rd
    TA19 9EA Ilton
    Conquest Business Park
    Somerset
    England
    Amministratore
    Cad Rd
    TA19 9EA Ilton
    Conquest Business Park
    Somerset
    England
    EnglandEnglish117343980001
    HUNTLY, Stephen Richard
    Cad Rd
    TA19 9EA Ilton
    Conquest Business Park
    Somerset
    England
    Amministratore
    Cad Rd
    TA19 9EA Ilton
    Conquest Business Park
    Somerset
    England
    EnglandBritish277651870001
    BARRETT, Renee Teresa
    Stanmore Industrial Estate
    WV15 5HP Bridgnorth
    Building 3
    Shropshire
    Segretario
    Stanmore Industrial Estate
    WV15 5HP Bridgnorth
    Building 3
    Shropshire
    161768270001
    GRAVE, Jacquelyn Eva
    Kentmere
    Snowden Cottage Lane
    TA20 1LN Chard
    Somerset
    Segretario
    Kentmere
    Snowden Cottage Lane
    TA20 1LN Chard
    Somerset
    British63240160002
    JONES, Gary
    Bassnage Road
    B63 4HG Halesowen
    70
    West Midlands
    Segretario
    Bassnage Road
    B63 4HG Halesowen
    70
    West Midlands
    British150912700001
    CHETTLEBURGH INTERNATIONAL LIMITED
    Temple House
    20 Holywell Row
    EC2A 4JB London
    Segretario nominato
    Temple House
    20 Holywell Row
    EC2A 4JB London
    900000860001
    BALL, Howard Ashley
    23 Barrowfield Close
    Burton Bradstock
    DT6 4RH Bridport
    Dorset
    Amministratore
    23 Barrowfield Close
    Burton Bradstock
    DT6 4RH Bridport
    Dorset
    United KingdomBritish107722530002
    BARRETT, Renee Teresa
    Stanmore Industrial Estate
    WV15 5HP Bridgnorth
    Building 3
    Shropshire
    Amministratore
    Stanmore Industrial Estate
    WV15 5HP Bridgnorth
    Building 3
    Shropshire
    EnglandBritish80782310002
    BEGGS, Rebecca Jane
    18 The Beacon
    TA19 9AH Ilminster
    Beacon Orchard
    Somerset
    Amministratore
    18 The Beacon
    TA19 9AH Ilminster
    Beacon Orchard
    Somerset
    United KingdomBritish79319110004
    BLACKBURN, John Kenneth
    Cad Rd
    TA19 9EA Ilton
    Conquest Business Park
    Somerset
    England
    Amministratore
    Cad Rd
    TA19 9EA Ilton
    Conquest Business Park
    Somerset
    England
    EnglandBritish113390120001
    DIMELOE, Peter William
    Stanmore Industrial Estate
    WV15 5HP Bridgnorth
    Building 3
    Shropshire
    Amministratore
    Stanmore Industrial Estate
    WV15 5HP Bridgnorth
    Building 3
    Shropshire
    United KingdomBritish36078950001
    GENT, Stephen Alan
    Stanmore Industrial Estate
    WV15 5HP Bridgnorth
    Building 3
    Shropshire
    Amministratore
    Stanmore Industrial Estate
    WV15 5HP Bridgnorth
    Building 3
    Shropshire
    United KingdomBritish80476320002
    GRAVE, Benjamin John
    Windsor Crescent
    TA20 2HG Chard
    22
    Somerset
    Amministratore
    Windsor Crescent
    TA20 2HG Chard
    22
    Somerset
    EnglandBritish105591080004
    GRAVE, Jacquelyn Eva
    Kentmere
    Snowden Cottage Lane
    TA20 1LN Chard
    Somerset
    Amministratore
    Kentmere
    Snowden Cottage Lane
    TA20 1LN Chard
    Somerset
    United KingdomBritish63240160002
    GRAVE, Robert Charles
    Japonica Cottage
    342 High Street
    BA22 9PJ Hardington Mandeville
    Somerset
    Amministratore
    Japonica Cottage
    342 High Street
    BA22 9PJ Hardington Mandeville
    Somerset
    United KingdomBritish69130170002
    GRAVE, Robert Bruce
    Kentmere
    Snowdon Cottage Lane
    TA20 1LN Chard
    Somerset
    Amministratore
    Kentmere
    Snowdon Cottage Lane
    TA20 1LN Chard
    Somerset
    United KingdomBritish63240150005
    JARVIS, Robert Alan
    Cad Rd
    TA19 9EA Ilton
    Conquest Business Park
    Somerset
    England
    Amministratore
    Cad Rd
    TA19 9EA Ilton
    Conquest Business Park
    Somerset
    England
    EnglandBritish131619900001
    MCCORMICK, Keith
    Stanmore Industrial Estate
    WV15 5HP Bridgnorth
    Building 3
    Shropshire
    Amministratore
    Stanmore Industrial Estate
    WV15 5HP Bridgnorth
    Building 3
    Shropshire
    United KingdomBritish89897960001
    PILAAR, Niels Jan
    Stanmore Industrial Estate
    WV15 5HP Bridgnorth
    Building 3
    Shropshire
    Amministratore
    Stanmore Industrial Estate
    WV15 5HP Bridgnorth
    Building 3
    Shropshire
    NetherlandsDutch150912500001

    Chi sono le persone con controllo significativo di IMPEY SHOWERS LTD?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Cram Uk Holding Ltd
    Stanmore Industrial Estate
    WV15 5HP Bridgnorth
    4a
    England
    06 apr 2016
    Stanmore Industrial Estate
    WV15 5HP Bridgnorth
    4a
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act
    Luogo di registrazioneLondon
    Numero di registrazione07214057
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    IMPEY SHOWERS LTD ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 17 dic 2014
    Consegnato il 02 gen 2015
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Nine trademarks being UK00002236308, UK00002272075, UK00002471001, UK00002472030, UK00002473084, UK00002520800, UK00002601191, UK00002628724, UK00002638446.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Abn Amro Commercial Finance PLC
    Transazioni
    • 02 gen 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 04 gen 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 20 mar 2013
    Consegnato il 05 apr 2013
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or any of the other borrowers to the banks (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of fixed charge all the debts, any deposits, margins, commissions or other rights, all loan capital, indebtedness or liabilities, the contracts and by way of floating charge all the stock-in-trade see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ing Bank N.V. and Abn Amro Bank N.V.
    Transazioni
    • 05 apr 2013Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 12 dic 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charge of deposit
    Creato il 30 mar 2010
    Consegnato il 09 apr 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The deposit initially of £62,000 credited to account designation number 23542551 with the bank and any addition to that deposit and any deposit or account from time to time of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposit or account.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 09 apr 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 12 ott 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Fixed and floating charge
    Creato il 05 dic 2006
    Consegnato il 07 dic 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transazioni
    • 07 dic 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 set 2011Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 01 dic 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 25 ago 2006
    Consegnato il 09 set 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Commercial unit conquest business park cad road ilton ilminster somerset. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 09 set 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 apr 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 25 ago 2006
    Consegnato il 09 set 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Development land at conquest business park cad road ilton ilminster somerset. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 09 set 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 apr 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 25 ago 2006
    Consegnato il 09 set 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Conquest house conquest business park cad road ilton ilminster somerset. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 09 set 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 apr 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 23 giu 2006
    Consegnato il 04 lug 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 04 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 apr 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 12 ago 2004
    Consegnato il 20 ago 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Plot 4 spinnaker quay lawrence road plymouth city of plymouth t/no DN481911.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 20 ago 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 apr 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 07 ott 2003
    Consegnato il 27 ott 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The construction equipment centre and plot 4 conquest business park ilton ilminster somerset t/no WS24171.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 27 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 dic 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0