MARTINEAU NO. 1 LIMITED
Panoramica
| Nome della società | MARTINEAU NO. 1 LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03744367 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di MARTINEAU NO. 1 LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova MARTINEAU NO. 1 LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 5 Strand London WC2N 5AF |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di MARTINEAU NO. 1 LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| SHELFCO (NO.1634) LIMITED | 31 mar 1999 | 31 mar 1999 |
Quali sono gli ultimi bilanci di MARTINEAU NO. 1 LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2010 |
Quali sono le ultime deposizioni per MARTINEAU NO. 1 LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Ashley Peter Blake il 30 mar 2012 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per David Leslie Frank Holt il 30 mar 2012 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 mar 2012 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Richard John Akers il 30 mar 2012 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Cessazione della carica di David John Atkins come amministratore in data 26 ott 2011 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Ls Company Secretaries Limited come segretario in data 30 apr 2011 | 2 pagine | AP04 | ||||||||||
Cessazione della carica di Peter Maxwell Dudgeon come segretario in data 30 apr 2011 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 mar 2011 con elenco completo degli azionisti | 8 pagine | AR01 | ||||||||||
Nomina di Paul Wylie come amministratore | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di James Mount come amministratore | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di John Smith come amministratore | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 mar 2010 con elenco completo degli azionisti | 18 pagine | AR01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Erna Boogaard come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2008 | 4 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 8 pagine | 363a | ||||||||||
legacy | 3 pagine | 288a | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288b | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288b | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288b | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di MARTINEAU NO. 1 LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS COMPANY SECRETARIES LIMITED | Segretario | Strand WC2N 5AF London 5 United Kingdom |
| 159674790001 | ||||||||||
| AKERS, Richard John | Amministratore | Strand WC2N 5AF London 5 United Kingdom | United Kingdom | English | 73246590001 | |||||||||
| BLAKE, Ashley Peter | Amministratore | Strand WC2N 5AF London 5 United Kingdom | England | British | 83319540002 | |||||||||
| HOLT, David Leslie Frank | Amministratore | Strand WC2N 5AF London 5 United Kingdom | England | United Kingdom | 100070620002 | |||||||||
| WYLIE, Paul | Amministratore | 50 Bothwell Street G2 6HR Glasgow Ignis Investment Services Limited | Scotland | British | 123380350001 | |||||||||
| DUDGEON, Peter Maxwell | Segretario | 41 Links Road KT17 3PP Epsom Surrey | British | 14674480002 | ||||||||||
| DUDGEON, Peter Maxwell | Segretario | 41 Links Road KT17 3PP Epsom Surrey | British | 14674480002 | ||||||||||
| E P S SECRETARIES LIMITED | Segretario nominato | 50 Stratton Street W1X 6NX London | 900004930001 | |||||||||||
| HENDERSON SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Segretario | 4 Broadgate EC2M 2DA London | 6118210006 | |||||||||||
| ASHTON, Mark Arthur | Amministratore | Oakfield Hollycombe Close GU30 7HR Liphook Hants | United Kingdom | British | 110886440001 | |||||||||
| ATKINS, David John | Amministratore | 60 Dukes Wood Drive SL9 7LF Gerrards Cross The Barn Buckinghamshire | United Kingdom | British | 144036070001 | |||||||||
| BOOGAARD, Erna Marina | Amministratore | 29 Jameson Street W8 7SH London | Dutch | 123714450001 | ||||||||||
| BYWATER, John Andrew | Amministratore | Craigens Hill Foot Lane Burn Bridge HG3 1NT Harrogate North Yorkshire | England | British | 71820020003 | |||||||||
| BYWATER, John Andrew | Amministratore | Craigens Hill Foot Lane Burn Bridge HG3 1NT Harrogate North Yorkshire | England | British | 71820020003 | |||||||||
| COLE, Peter William Beaumont | Amministratore | Walnut Tree Farm Walnut Tree Road Pirton SG5 3PX Hitchin Hertfordshire | England | British | 51145990001 | |||||||||
| COOPER, Martin Richard | Amministratore | 1 Old Rectory Meadow Denver PE38 0DF Downham Market Norfolk | England | English | 53175830001 | |||||||||
| COTTINGHAM, Philip George | Amministratore | 53 Eastbury Road HA6 3AP Northwood Middlesex | England | British | 77221700003 | |||||||||
| DE BARR, Robert Henry | Amministratore | Watermark Thames Lawn St Peter Street SL7 1QA Marlow Buckinghamshire | England | British | 14885390006 | |||||||||
| DODDS, John Andrew William | Amministratore | South Cockerham Hacche Lane EX36 3EH South Molton Devon | England | British | 27325060004 | |||||||||
| EMERY, Jonathan Michael | Amministratore | Percy Road TW12 2JS Hampton 93 Middlesex | British | 78621400001 | ||||||||||
| FIELD, Graham | Amministratore | 20 Hawthorne Road BR1 2HH Bickley Kent | British | 64221620001 | ||||||||||
| FORSTER, Vanessa | Amministratore | 7 Parkwood House Parkwood Road SW19 7AQ Wimbledon | England | British | 126248600001 | |||||||||
| HUTCHINGS, Lawrence Francis | Amministratore | Brody House Strype Street E1 7LQ London Flat 503 United Kingdom | England | British | 134630060001 | |||||||||
| HUTCHINGS, Lawrence Francis | Amministratore | Brody House Strype Street E1 7LQ London Flat 503 United Kingdom | England | British | 134630060001 | |||||||||
| MOUNT, James Robert | Amministratore | Flat 28 123-125 Ladbroke Road W11 3PU London | United Kingdom | British | 115430900001 | |||||||||
| PALMER, Colin Edward | Amministratore | Flat B 1 Underwood Street N1 7LY London | United Kingdom | British | 70083400002 | |||||||||
| RICHARDS, Robert John Godwin | Amministratore | Dukes Wood Boxhill Road KT20 7PQ Tadworth Surrey | England | British | 36764280002 | |||||||||
| SMITH, John Simon Bertie | Amministratore | 32 Mingle Lane Stapleford CB2 5SY Cambridge Cambridgeshire | United Kingdom | British | 94659700001 | |||||||||
| VARNHAM, Neil Clive | Amministratore | The Cedars Sawtry Road, Glatton PE28 5RZ Huntingdon Cambridgeshire | United Kingdom | British | 67903580001 | |||||||||
| WHITE, Myles Bernard | Amministratore | Wesley House Lower High Street TN5 6LP Wadhurst East Sussex | England | British | 65380230004 | |||||||||
| WRIGHT, Geoffrey Harcroft | Amministratore | Michaelmas House 4 The Riddings CR3 6DW Caterham Surrey | British | 8585700001 | ||||||||||
| MIKJON LIMITED | Amministratore delegato nominato | 50 Stratton Street W1X 5FL London | 900004920001 |
MARTINEAU NO. 1 LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Agreement | Creato il 11 feb 2000 Consegnato il 28 feb 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The payment of £33,750 on 11TH february 2000 and further payment of £ 11,500 on each of 11TH february 2002,2003 and 2004 due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari The deposited sums of £68,250. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0