KEEPSAFE MANAGEMENT LIMITED

KEEPSAFE MANAGEMENT LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàKEEPSAFE MANAGEMENT LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03745402
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di KEEPSAFE MANAGEMENT LIMITED?

    • Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova KEEPSAFE MANAGEMENT LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    15 The Crescent
    TA1 4EB Taunton
    Somerset
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di KEEPSAFE MANAGEMENT LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    LAWGRA (NO.534) LIMITED01 apr 199901 apr 1999

    Quali sono gli ultimi bilanci di KEEPSAFE MANAGEMENT LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2012

    Quali sono le ultime deposizioni per KEEPSAFE MANAGEMENT LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 set 2012

    7 pagineAA

    Dimissioni del revisore

    2 pagineAUD

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dimissioni del revisore

    2 pagineAUD

    Bilancio annuale redatto al 01 apr 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital26 apr 2013

    Stato del capitale al 26 apr 2013

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Risoluzioni

    Resolutions
    8 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01
    capital

    Risoluzioni

    Agreement 28/06/2012
    RES13

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    7 pagineMG01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 set 2011

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 apr 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 set 2010

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 apr 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 mar 2010 al 30 set 2010

    1 pagineAA01

    Bilancio annuale redatto al 01 apr 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da 201 Bishopsgate London EC2M 3AF

    1 pagineAD02

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Nomina di Gillespie Macandrew Secretaries Limited come segretario

    2 pagineAP04

    Nomina di Mr Peter David Roper Landale come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Simon Squair Hodgson come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Alister William Jack come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Lilian Wong come amministratore

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di KEEPSAFE MANAGEMENT LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GILLESPIE MACANDREW SECRETARIES LIMITED
    Atholl Crescent
    EH3 8EJ Edinburgh
    5
    Midlothian
    United Kingdom
    Segretario
    Atholl Crescent
    EH3 8EJ Edinburgh
    5
    Midlothian
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazioneSC287766
    110304810001
    HODGSON, Simon Squair
    Atholl Crescent
    EH3 8EJ Edinburgh
    5
    Midlothian
    United Kingdom
    Amministratore
    Atholl Crescent
    EH3 8EJ Edinburgh
    5
    Midlothian
    United Kingdom
    ScotlandBritish89025200003
    JACK, Alister William
    Atholl Crescent
    EH3 8EJ Edinburgh
    5
    Midlothian
    United Kingdom
    Amministratore
    Atholl Crescent
    EH3 8EJ Edinburgh
    5
    Midlothian
    United Kingdom
    ScotlandBritish159211330001
    LANDALE, Peter David Roper
    Atholl Crescent
    EH3 8EJ Edinburgh
    5
    Midlothian
    Amministratore
    Atholl Crescent
    EH3 8EJ Edinburgh
    5
    Midlothian
    United KingdomBritish49635220001
    SMYTH, Michael Anthony
    8 Regent Square
    WC1H 8HZ London
    Segretario
    8 Regent Square
    WC1H 8HZ London
    British4337440001
    LAWGRAM SECRETARIES LIMITED
    More London Riverside
    SE1 2AU London
    4
    Segretario nominato
    More London Riverside
    SE1 2AU London
    4
    900004760001
    MAWLAW SECRETARIES LIMITED
    Bishopsgate
    EC2M 3AF London
    201
    Segretario
    Bishopsgate
    EC2M 3AF London
    201
    39182980003
    BAILLIE, Mark William
    Little Stream
    Woodlands Road West
    GU25 4PN Virginia Water
    Surrey
    Amministratore
    Little Stream
    Woodlands Road West
    GU25 4PN Virginia Water
    Surrey
    Australian112156520002
    CARPENTER, Malcolm Edward
    100 Pennycress Way
    MK16 8TT Newport Pagnell
    Buckinghamshire
    Amministratore
    100 Pennycress Way
    MK16 8TT Newport Pagnell
    Buckinghamshire
    British115886430001
    CLARKE, Christine
    Sloane Avenue
    SW3 3XB London
    Mgpa 60
    United Kingdom
    Amministratore
    Sloane Avenue
    SW3 3XB London
    Mgpa 60
    United Kingdom
    British138932540001
    CLEGG, Michael Bailey
    Upwey 36 Old Turnpike
    PO16 7HA Fareham
    Hampshire
    Amministratore
    Upwey 36 Old Turnpike
    PO16 7HA Fareham
    Hampshire
    British57300000001
    EDGE, Roderick Boris Clifford
    The Water Tower Knoll Road
    GU7 2EJ Godalming
    Surrey
    Amministratore
    The Water Tower Knoll Road
    GU7 2EJ Godalming
    Surrey
    SurreyBritish15622690001
    JEFFREY, Alexander Daniel
    Ainger Road
    NW 3AH London
    46a
    Amministratore
    Ainger Road
    NW 3AH London
    46a
    United KingdomBritish129962520001
    LUCCIONI, Laurent Xavier
    Sloane Avenue
    SW3 3XB London
    Mgpa 60
    United Kingdom
    Amministratore
    Sloane Avenue
    SW3 3XB London
    Mgpa 60
    United Kingdom
    United KingdomFrench131705720001
    PERUSAT, Marc Michel
    Citypoint
    1 Ropemaker Street
    EC2Y 9HD London
    Level 35
    United Kingdom
    Amministratore
    Citypoint
    1 Ropemaker Street
    EC2Y 9HD London
    Level 35
    United Kingdom
    United KingdomFrench115589250001
    PULIDO, Rena
    125 W Delaware Place
    FOREIGN Chicago
    Illinois Il 60610
    United States
    Amministratore
    125 W Delaware Place
    FOREIGN Chicago
    Illinois Il 60610
    United States
    Australian122049340001
    SANTER, Christopher John
    Jedburgh Street
    Clapham
    SW11 5QB London
    6
    Amministratore
    Jedburgh Street
    Clapham
    SW11 5QB London
    6
    EnglandBritish128404730001
    SMITH, Nathan Robert
    England's Lane
    NW3 4YD London
    41b
    United Kingdom
    Amministratore
    England's Lane
    NW3 4YD London
    41b
    United Kingdom
    Australian136694070001
    SMITH, Nathan Robert
    Citypoint
    1 Ropemaker Street
    EC2Y 9HD London
    Level 35
    United Kingdom
    Amministratore
    Citypoint
    1 Ropemaker Street
    EC2Y 9HD London
    Level 35
    United Kingdom
    Australian123776780001
    SMYTH, Michael Anthony
    8 Regent Square
    WC1H 8HZ London
    Amministratore
    8 Regent Square
    WC1H 8HZ London
    EnglandBritish4337440001
    TAYLOR, Michael James
    Stanley Hill Ave
    Amersham
    HP7 9BB London
    39
    United Kingdom
    Amministratore
    Stanley Hill Ave
    Amersham
    HP7 9BB London
    39
    United Kingdom
    Australian128209530001
    WILKINSON, Charles Edmund
    Utopia
    Rue De La Passee
    GY2 4TN St Sampsons
    Channel Islands
    Amministratore
    Utopia
    Rue De La Passee
    GY2 4TN St Sampsons
    Channel Islands
    GuernseyBritish127529840001
    WONG, Lilian
    Martin Place
    2000 Syndney
    1
    New South Wales
    Australia
    Amministratore
    Martin Place
    2000 Syndney
    1
    New South Wales
    Australia
    Australian139160950001
    LAWGRAM DIRECTORS LIMITED
    190 Strand
    WC2R 1JN London
    Amministratore
    190 Strand
    WC2R 1JN London
    63020940001

    KEEPSAFE MANAGEMENT LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 29 giu 2012
    Consegnato il 07 lug 2012
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 07 lug 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 28 gen 2010
    Consegnato il 09 feb 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due form each obligor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery for details of properties charged please refer to form MG01 see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Capita Trust Company Limited (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 09 feb 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 04 lug 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal mortgage
    Creato il 19 ott 2007
    Consegnato il 08 nov 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor and the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Sunbury house farnham trading estate farnham t/no SY291399. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Capita Trust Company Limited
    Transazioni
    • 08 nov 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 lug 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 31 ott 2005
    Consegnato il 02 nov 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 214-224 broomhill road brislington bristol t/n BL82345.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 02 nov 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 25 mar 2002
    Consegnato il 05 apr 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that part of the property known as 214-224 broomhill road brislington bristol. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 05 apr 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 14 mar 2001
    Consegnato il 24 mar 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that l/h property k/a the premises at garrets green lane, garrets green, birmingham.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 24 mar 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 10 ott 2000
    Consegnato il 14 ott 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H sunbury house farnham trading estate farnham surrey.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 14 ott 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 30 ago 2000
    Consegnato il 05 set 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 05 set 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0