PORTSMOUTH CITY FOOTBALL CLUB LIMITED

PORTSMOUTH CITY FOOTBALL CLUB LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPORTSMOUTH CITY FOOTBALL CLUB LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03747237
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PORTSMOUTH CITY FOOTBALL CLUB LIMITED?

    • (9261) /

    Dove si trova PORTSMOUTH CITY FOOTBALL CLUB LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PORTSMOUTH CITY FOOTBALL CLUB LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    OVERFLINT LIMITED07 apr 199907 apr 1999

    Quali sono gli ultimi bilanci di PORTSMOUTH CITY FOOTBALL CLUB LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mag 2008

    Quali sono le ultime deposizioni per PORTSMOUTH CITY FOOTBALL CLUB LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Avviso di conto finale prima della dissoluzione

    19 pagineWU15

    Nomina di un liquidatore

    3 pagineWU04

    Modificazione della composizione del comitato dei creditori o del comitato di liquidazione

    11 pagineCOM2

    Ordine del tribunale di liquidazione

    COCOMP

    Ordinanza giudiziaria in materia di insolvenza

    Court order insolvency:replacement of liquidator
    43 pagineLIQ MISC OC

    Nomina di un liquidatore

    1 pagine4.31

    Ordine del tribunale di liquidazione

    4 pagineCOCOMP

    Indirizzo della sede legale modificato da * Quadrant House 4 Thomas More Square London E1W 1YW* in data 24 mar 2011

    2 pagineAD01

    Notifica di esecuzione dell'accordo di composizione

    23 pagine1.4

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 24 feb 2011

    40 pagine2.24B

    Avviso di ordinanza del tribunale che termina l'amministrazione

    3 pagine2.33B

    Risultato della riunione dei creditori

    2 pagine2.23B

    Risultato della riunione dei creditori

    3 pagine2.23B

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    44 pagine2.17B

    legacy

    MG01

    legacy

    6 pagineMG01

    Risultato della riunione dei creditori

    2 pagine2.23B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 25 ago 2010

    67 pagine2.24B

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B

    3 pagine2.16B

    Notifica al Registro delle imprese dell'accordo di composizione volontario che entra in vigore

    10 pagine1.1

    Certificato modificato di costituzione del comitato dei creditori

    2 pagine2.26B

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    70 pagine2.17B

    Indirizzo della sede legale modificato da * Fratton Park Frogmore Road Southsea Hampshire PO4 8RA* in data 23 mar 2010

    1 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    Chi sono gli amministratori di PORTSMOUTH CITY FOOTBALL CLUB LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ROBINS, Tanya
    4 Shaftesbury Road
    PO5 3JR Southsea
    Hampshire
    Segretario
    4 Shaftesbury Road
    PO5 3JR Southsea
    Hampshire
    British91685560001
    JACOB, Mark Silas
    N20
    Amministratore
    N20
    United KingdomBritish142494720001
    JACOB, Mark Silas
    Charlotte Street
    W1T 4QG London
    70
    Amministratore
    Charlotte Street
    W1T 4QG London
    70
    United KingdomBritish146090500001
    STORRIE, Peter James
    St Helens Road
    PO11 0BT Hayling Island
    6
    Portsmouth
    Amministratore
    St Helens Road
    PO11 0BT Hayling Island
    6
    Portsmouth
    United KingdomBritish138881910001
    BRADY, Terence Patrick
    Owls Hall Cattlegate Road
    Crews Hill
    EN2 8AZ Enfield
    Middlesex
    Segretario
    Owls Hall Cattlegate Road
    Crews Hill
    EN2 8AZ Enfield
    Middlesex
    British6356520001
    DEACON, David Keith
    2 Northwood Close
    Bassett
    SO16 3QJ Southampton
    Segretario
    2 Northwood Close
    Bassett
    SO16 3QJ Southampton
    English4504230002
    GRISSETT, Keith
    20 Glendinning Avenue
    DT4 7QF Weymouth
    Segretario
    20 Glendinning Avenue
    DT4 7QF Weymouth
    British100200640001
    MITCHELL, Michael Paul
    2 Honeysuckle Close
    Iver
    SL0 0LZ Slough
    Buckinghamshire
    Segretario
    2 Honeysuckle Close
    Iver
    SL0 0LZ Slough
    Buckinghamshire
    British74684330001
    STORRIE, Peter James
    St Helens Road
    PO11 0BT Hayling Island
    6
    Portsmouth
    Segretario
    St Helens Road
    PO11 0BT Hayling Island
    6
    Portsmouth
    British138881910001
    STORRIE, Peter James
    6 St Helens Road
    PO11 0BT Hayling Island
    Hampshire
    Segretario
    6 St Helens Road
    PO11 0BT Hayling Island
    Hampshire
    British81157870002
    SAME-DAY COMPANY SERVICES LIMITED
    9 Perseverance Works
    Kingsland Road
    E2 8DD London
    Segretario nominato
    9 Perseverance Works
    Kingsland Road
    E2 8DD London
    900000980001
    AL FAHIM, Sulaiman, Dr
    112131 Dubai
    Dubai
    PO BOX
    112131
    United Arab Emirates
    Amministratore
    112131 Dubai
    Dubai
    PO BOX
    112131
    United Arab Emirates
    United Arab Emirates139956170001
    AVONDO, Roberto
    13 Spencer Road
    PO4 9RN Southsea
    Hampshire
    Amministratore
    13 Spencer Road
    PO4 9RN Southsea
    Hampshire
    EnglandItalian124988660001
    BRADY, Terence Patrick
    Owls Hall Cattlegate Road
    Crews Hill
    EN2 8AZ Enfield
    Middlesex
    Amministratore
    Owls Hall Cattlegate Road
    Crews Hill
    EN2 8AZ Enfield
    Middlesex
    EnglandBritish6356520001
    CHISSICK, David
    13 Lechi Street
    Herzeliya
    Israel
    Amministratore
    13 Lechi Street
    Herzeliya
    Israel
    British110679440002
    DEACON, David Keith
    2 Northwood Close
    Bassett
    SO16 3QJ Southampton
    Amministratore
    2 Northwood Close
    Bassett
    SO16 3QJ Southampton
    English4504230002
    DINEAGE, Frederick
    Woodlands House
    East Street, Hambledon
    PO7 4RX Waterlooville
    Hampshire
    Amministratore
    Woodlands House
    East Street, Hambledon
    PO7 4RX Waterlooville
    Hampshire
    British64352410001
    GAYDAMAK, Alexandre
    Levi Eshkol 16
    Tel Aviv
    Israel
    Amministratore
    Levi Eshkol 16
    Tel Aviv
    Israel
    French110679280002
    GRISSETT, Keith
    20 Glendinning Avenue
    DT4 7QF Weymouth
    Amministratore
    20 Glendinning Avenue
    DT4 7QF Weymouth
    EnglandBritish100200640001
    JOHNSON, Mark
    65 Brownhill Road
    Chandlers Ford Eastleigh
    SO53 2EH Southampton
    Hampshire
    Amministratore
    65 Brownhill Road
    Chandlers Ford Eastleigh
    SO53 2EH Southampton
    Hampshire
    EnglandBritish121505890001
    MANDARIC, Milan
    7792 Fisher Isalnd Drive
    Fisher Island 33131
    FOREIGN Florida Usa
    Amministratore
    7792 Fisher Isalnd Drive
    Fisher Island 33131
    FOREIGN Florida Usa
    American64192410002
    MITCHELL, Michael Paul
    Milestone 2 Honeysuckle Close
    SL0 0LZ Iver
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Milestone 2 Honeysuckle Close
    SL0 0LZ Iver
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish14373520001
    MURPHY, Martin John
    Langstone House
    25 Langstone High Street Langstone
    PO9 1RY Havant
    Hampshire
    Amministratore
    Langstone House
    25 Langstone High Street Langstone
    PO9 1RY Havant
    Hampshire
    United KingdomBritish24755690002
    ROBINS, Tanya
    4 Shaftesbury Road
    PO5 3JR Southsea
    Hampshire
    Amministratore
    4 Shaftesbury Road
    PO5 3JR Southsea
    Hampshire
    United KingdomBritish91685560001
    VANDENBERG, Bruce Maclaren
    23 Spruce Drive
    GU18 5YU Lightwater
    Surrey
    Amministratore
    23 Spruce Drive
    GU18 5YU Lightwater
    Surrey
    EnglandBritish58275980003
    WILDMAN & BATTELL LIMITED
    9 Perseverance Works
    Kingsland Road
    E2 8DD London
    Amministratore delegato nominato
    9 Perseverance Works
    Kingsland Road
    E2 8DD London
    900000970001

    PORTSMOUTH CITY FOOTBALL CLUB LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Charge over proceeds of agreement
    Creato il 24 ott 2010
    Consegnato il 28 ott 2010
    In corso
    Importo garantito
    £2,208,675.00 all monies due or to become due from the company (in administration) acting by its administrators to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    As a continuing security for the payment and discharge of the secured obligations such right, title and interest may have present and future to in and arising out or in respect of the proceeds and the rights see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Alexandre Gaydamak
    Transazioni
    • 28 ott 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 07 gen 2010
    Consegnato il 20 gen 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fratton park frogmore road southsea t/n HP375034 and fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Portpin Limited
    Transazioni
    • 20 gen 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Charge deed
    Creato il 06 ott 2009
    Consegnato il 21 ott 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H fratton park frogmore road southsea t/no HP375034.
    Persone aventi diritto
    • Portpin Limited
    Transazioni
    • 21 ott 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Legal charge
    Creato il 15 lug 2009
    Consegnato il 23 lug 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the miland development 2004 limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All deposits now and in the future credited to account designation 05457955 with the bank and any deposit or account of any other description or designation which derives in whole or in part from such deposits or account.
    Persone aventi diritto
    • Coutts & Co
    Transazioni
    • 23 lug 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed of assignment of payments
    Creato il 27 lug 2007
    Consegnato il 07 ago 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    All the right title and interest in and to all amounts (including vat). See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Standard Bank PLC
    Transazioni
    • 07 ago 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 set 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over deposit
    Creato il 27 lug 2007
    Consegnato il 07 ago 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of floating charge all deposits, account number 132525 including accounts numbered 100114337. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Standard Bank PLC
    Transazioni
    • 07 ago 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 set 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment of payments
    Creato il 21 dic 2006
    Consegnato il 30 dic 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All its right title and interest in and to the fapl payments.
    Persone aventi diritto
    • Kaupthing Singer & Friedlander Limited
    Transazioni
    • 30 dic 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 26 mag 2006
    Consegnato il 01 giu 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the borrower to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land k/a fratton park frogmore road milton t/no HP375034. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Singer & Friedlander Limited
    Transazioni
    • 01 giu 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 dic 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Assignment of payments
    Creato il 26 mag 2006
    Consegnato il 01 giu 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the borrower to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All right title and interest in and to the fapl payments. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Singer & Friedlander Limited
    Transazioni
    • 01 giu 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 10 gen 2006
    Consegnato il 17 gen 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The 'rights' being the beneficial interest of the company in the players contracts and the transfer agreements and in respect of the registration of the players with the english football association. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Alexandre Gaydamak
    Transazioni
    • 17 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 lug 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 27 ott 2004
    Consegnato il 10 nov 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    F/H land k/a fratton park,frogmore road,milton,t/no HP375034. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Singer & Friedlander Limited
    Transazioni
    • 10 nov 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 set 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment of payments
    Creato il 26 ott 2004
    Consegnato il 10 nov 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The assignor assigned absolutely to the bank and in the bank's favour all its right,title and interest in and to the fapl payments. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Singer & Friedlander Limited
    Transazioni
    • 10 nov 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 set 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 10 ago 2003
    Consegnato il 19 ago 2003
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 ago 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed of charge over credit balances
    Creato il 29 apr 2000
    Consegnato il 08 mag 2000
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 08 mag 2000Registrazione di un'ipoteca (395)

    PORTSMOUTH CITY FOOTBALL CLUB LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    26 feb 2010Inizio dell'amministrazione
    24 feb 2011Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Andrew Andronikou
    Quadrant House 4 Thomas More Square
    E1W 1YW London
    Praticante
    Quadrant House 4 Thomas More Square
    E1W 1YW London
    Peter Kubik
    Quadrant House 4 Thomas More Square
    E1W 1YW London
    Praticante
    Quadrant House 4 Thomas More Square
    E1W 1YW London
    Michael Kiely
    Quadrant House 4 Thomas More Square
    E1W 1YW London
    Praticante
    Quadrant House 4 Thomas More Square
    E1W 1YW London
    2
    DataTipo
    17 giu 2010Data della riunione per approvare il CVA
    24 feb 2011Data di completamento o cessazione del CVA
    Accordo volontario di ristrutturazione aziendale (CVA)
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Andrew Andronikou
    Quadrant House 4 Thomas More Square
    E1W 1YW London
    Praticante
    Quadrant House 4 Thomas More Square
    E1W 1YW London
    Michael Kiely
    Quadrant House 4 Thomas More Square
    E1W 1YW London
    Praticante
    Quadrant House 4 Thomas More Square
    E1W 1YW London
    3
    DataTipo
    16 lug 2019Conclusione della liquidazione
    23 dic 2009Data della petizione
    24 feb 2011Inizio della liquidazione
    14 gen 2020Data di scioglimento
    Liquidazione coatta
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    The Official Receiver Or London
    21 Bloomsbury Street
    London
    WC1B 3SS
    Praticante
    21 Bloomsbury Street
    London
    WC1B 3SS
    Graham Paul Bushby
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    Praticante
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    Adrian David Allen
    Suite A, 7th Floor City Gate East Tollhouse Hill
    NG1 5FS Nottingham
    Praticante
    Suite A, 7th Floor City Gate East Tollhouse Hill
    NG1 5FS Nottingham
    Geoffrey Lambert Carton-Kelly
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    Praticante
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    David Paul Hudson
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    Praticante
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0