GH PPP HOLDINGS LIMITED

GH PPP HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàGH PPP HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03747270
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di GH PPP HOLDINGS LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova GH PPP HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Cannon Place
    78 Cannon Street
    EC4N 6AF London
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di GH PPP HOLDINGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per GH PPP HOLDINGS LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per GH PPP HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01
    A4HG8W9N

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    47 pagineAA
    S4GWKH4B

    Nomina di Mr Jonathan Peter Doberman come amministratore in data 04 set 2015

    2 pagineAP01
    X4GLEMA2

    Cessazione della carica di Nestor Augusto Castillo Borrero come amministratore in data 04 set 2015

    1 pagineTM01
    X4GLEM9U

    Dettagli del direttore cambiati per Biif Corporate Services Limited il 01 lug 2015

    1 pagineCH02
    X4ATEIZV

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Dundas & Wilson Northwest Wing Bush House Aldwych London WC2B 4EZ a Cannon Place 78 Cannon Street London EC4N 6AF in data 01 lug 2015

    1 pagineAD01
    X4AQQPWG

    Bilancio annuale redatto al 07 apr 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital11 mag 2015

    Stato del capitale al 11 mag 2015

    • Capitale: GBP 2
    SH01
    X476UFYI

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    9 pagineAA
    S3H00GKI

    Nomina di Mr Nestor Augusto Castillo Borrero come amministratore

    2 pagineAP01
    X38XN0ZT

    Cessazione della carica di Michael Forrest come amministratore

    1 pagineTM01
    X38XN0OO

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Michael Forrest il 21 mag 2014

    2 pagineCH01
    X38CUOGA

    Bilancio annuale redatto al 07 apr 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital05 mag 2014

    Stato del capitale al 05 mag 2014

    • Capitale: GBP 2
    SH01
    X379VPVN

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Michael Forrest il 11 nov 2013

    2 pagineCH01
    X2NUPEAB

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Michael Forrest il 09 ott 2013

    2 pagineCH01
    X2INYS7U

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    12 pagineAA
    S2BGKORS

    Bilancio annuale redatto al 07 apr 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    X270UPRU

    Dettagli del segretario cambiati per Infrastructure Managers Limited il 26 feb 2013

    2 pagineCH04
    X22ZS6SR

    Dettagli del direttore cambiati per Biif Corporate Services Limited il 04 set 2012

    2 pagineCH02
    X22ZTCLE

    Dettagli del direttore cambiati per Biif Corporate Services Limited il 04 set 2012

    2 pagineCH02
    X22ZSHK1

    Dettagli del segretario cambiati per Infrastructure Managers Limited il 25 feb 2013

    2 pagineCH04
    X22X64QG

    Dettagli del direttore cambiati per Biif Corporate Services Limited il 04 set 2012

    2 pagineCH02
    X22X64UH

    Indirizzo della sede legale modificato da * C/O C/O Law Debenture Corporate Services Limited Fifth Floor 100 Wood Street London EC2V 7EX United Kingdom* in data 04 set 2012

    2 pagineAD01
    A1GHW0MY

    Nomina di Michael Forrest come amministratore

    2 pagineAP01
    X1DW1OMB

    Chi sono gli amministratori di GH PPP HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    INFRASTRUCTURE MANAGERS LIMITED
    Floor
    11 Thistle Street
    EH2 1DF Edinburgh
    2nd
    United Kingdom
    Segretario
    Floor
    11 Thistle Street
    EH2 1DF Edinburgh
    2nd
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione05372427
    128530180002
    DOBERMAN, Jonathan Peter
    Palace Street
    SW1E 5JD London
    16
    United Kingdom
    Amministratore
    Palace Street
    SW1E 5JD London
    16
    United Kingdom
    United KingdomBritishFinancial Controller201234400001
    BIIF CORPORATE SERVICES LIMITED
    78 Cannon Street
    EC4N 6AF London
    Cannon Place
    United Kingdom
    Amministratore
    78 Cannon Street
    EC4N 6AF London
    Cannon Place
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione06793845
    138240210001
    BARBER, David Alan
    14 Pinewood Gate
    HG2 0JF Harrogate
    North Yorkshire
    Segretario
    14 Pinewood Gate
    HG2 0JF Harrogate
    North Yorkshire
    British69879580002
    CHETTLEBURGH INTERNATIONAL LIMITED
    Temple House
    20 Holywell Row
    EC2A 4JB London
    Segretario nominato
    Temple House
    20 Holywell Row
    EC2A 4JB London
    900000860001
    NOBLE FINANCIAL HOLDINGS LIMITED
    76 George Street
    EH2 3BU Edinburgh
    Segretario
    76 George Street
    EH2 3BU Edinburgh
    94907480001
    NOBLE PARTNERSHIP LIMITED
    76 George Street
    EH2 3BU Edinburgh
    Segretario
    76 George Street
    EH2 3BU Edinburgh
    86014010001
    AUSTIN, Robert John
    The Cottage 8 Dockroyd
    Oakworth
    BD22 7RH Keighley
    West Yorkshire
    Amministratore
    The Cottage 8 Dockroyd
    Oakworth
    BD22 7RH Keighley
    West Yorkshire
    BritishFinancial Director49285440001
    CASTILLO BORRERO, Nestor Augusto
    16 Palace Street
    SW1E 5JD London
    3i
    United Kingdom
    Amministratore
    16 Palace Street
    SW1E 5JD London
    3i
    United Kingdom
    EnglandBritishInvestment Manager182601420001
    CLARKE, Laurence Seymour
    Churchill Place
    E14 5HP London
    Barclays Bank Plc, 1
    Amministratore
    Churchill Place
    E14 5HP London
    Barclays Bank Plc, 1
    EnglandBritishDirector138241960001
    COPLEY, Peter Paul
    113 Shepherds Lane
    DA1 2PA Dartford
    Kent
    Amministratore
    113 Shepherds Lane
    DA1 2PA Dartford
    Kent
    EnglandBritishManaging Director66206120002
    FORREST, Michael
    c/o Dundas & Wilson
    Bush House
    Aldwych
    WC2B 4EZ London
    Northwest Wing
    Amministratore
    c/o Dundas & Wilson
    Bush House
    Aldwych
    WC2B 4EZ London
    Northwest Wing
    United KingdomBritishChartered Accountant169634490002
    MCCULLOCH, Paul
    33 Southwood Avenue
    Highgate
    N6 5SA London
    Amministratore
    33 Southwood Avenue
    Highgate
    N6 5SA London
    BritishInvestment Banker101810930001
    MCDONAGH, John
    30 St Botolph's Road
    Sevenoaks
    TN13 3AG Kent
    Amministratore
    30 St Botolph's Road
    Sevenoaks
    TN13 3AG Kent
    BritishDirector116580030002
    MIDDLETON, Nigel Wythen
    The Cottage
    198 High Molewood
    SG14 2PJ Hertford
    Amministratore
    The Cottage
    198 High Molewood
    SG14 2PJ Hertford
    United KingdomBritishFund Manager85320540001
    RAY, Alistair Graham
    305 Rotherhithe Street
    SE16 5EQ London
    Amministratore
    305 Rotherhithe Street
    SE16 5EQ London
    BritishInvestment Banker77528420002
    RYAN, Michael Joseph
    Central Building
    3 Matthew Parker Street
    SW1H 9NE London
    Apartment 42,
    Amministratore
    Central Building
    3 Matthew Parker Street
    SW1H 9NE London
    Apartment 42,
    United KingdomIrishCompany Director77999320003
    SAHEB-ZADHA, Faraidon
    c/o C/O Law Debenture Corporate Services Limited
    100 Wood Street
    EC2V 7EX London
    Fifth Floor
    United Kingdom
    Amministratore
    c/o C/O Law Debenture Corporate Services Limited
    100 Wood Street
    EC2V 7EX London
    Fifth Floor
    United Kingdom
    EnglandBritishOperations Director152128490001
    SCOTT-BARRETT, Nicholas Huson
    Gatehouse Farm
    Crown Lane, Ardleigh
    CO7 7QZ Colchester
    Amministratore
    Gatehouse Farm
    Crown Lane, Ardleigh
    CO7 7QZ Colchester
    BritishBanker59658050001
    SEARCH, Annabel Shirley
    Old Orchard House Church Street
    Goldsborough
    HG5 8NR Knaresborough
    North Yorkshire
    Amministratore
    Old Orchard House Church Street
    Goldsborough
    HG5 8NR Knaresborough
    North Yorkshire
    BritishAdministration Director63367650001
    TAEE, Nigel Duncan
    Scarlet Hollies
    Pinewood Road
    GU25 4PA Wentworth
    Surrey
    Amministratore
    Scarlet Hollies
    Pinewood Road
    GU25 4PA Wentworth
    Surrey
    EnglandBritishCompany Director126477140001

    GH PPP HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 28 lug 2011
    Consegnato il 10 ago 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each chargor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Security Trustee for the Finance Parties (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 10 ago 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Deed of confirmation to debenture
    Creato il 19 dic 2007
    Consegnato il 28 dic 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and the borrower to the chargee and the senior creditors (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC for Itself and as Agent and Security Trustee for Each of the Other Financeparties
    Transazioni
    • 28 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed of confirmation
    Creato il 09 nov 2007
    Consegnato il 23 nov 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    First legal mortgage all of the shares and all dividends. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC (The "Security Trustee")
    Transazioni
    • 23 nov 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed of confirmation
    Creato il 21 dic 2006
    Consegnato il 05 gen 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargor and the borrower to the chargee and the senior creditors or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All of the shares in gh bodmin holdings limited and the dividends paid or payable and all stocks, shares, securities, all sums standing to the credit of any bank account. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC for Itself and as Agent and Security Trustee for and on Behalf of the Otherfinance Parties (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 05 gen 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 01 giu 2001
    Consegnato il 12 giu 2001
    In corso
    Importo garantito
    All obligations and liabilities of (a) the chargor to the security trustee and the senior creditors (as defined), or any of them, and under the senior facility agreement (as defined) and any finance document (as defined) to which it is a party and/or (b) any deed or document supplemental thereto
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC, London, as Agent and Security Trustee for and Onbehalf of the Senior Creditors
    Transazioni
    • 12 giu 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    Account charge
    Creato il 24 gen 2001
    Consegnato il 13 feb 2001
    In corso
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities of the company to the chargee under the charge and under the security trust deed (as defined) and/or any deed or document expressed to be supplemental thereto
    Brevi particolari
    The cash collateral, the grosvenor collateral account and the debt represented thereby.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 13 feb 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    Account charge
    Creato il 31 ott 2000
    Consegnato il 15 nov 2000
    In corso
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities of the company to the chargee under the charge and under the security trust deed (as defined) including without limitation all obligations to provide the cash collateral (as defined)
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge the cash collateral, the grosvenor collateral account and the debt represented thereby and all interest and other accruals thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 15 nov 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    Account charge
    Creato il 05 set 2000
    Consegnato il 25 set 2000
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under this charge,the security trust deed (as defined) and/or any deed or document expressed to be supplemental thereto to provide the cash collateral (as defined)
    Brevi particolari
    First fixed charge over the cash collateral,the grosvenor collateral account,as defined,and the debt and all interest thereon; all other rights,titles,benefits and interest whatsoever. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 25 set 2000Registrazione di un'ipoteca (395)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0