SUMMERDALE COURT LIMITED

SUMMERDALE COURT LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSUMMERDALE COURT LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03750254
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SUMMERDALE COURT LIMITED?

    • Altre attività di assistenza sanitaria (86900) / Attività sanitarie e di assistenza sociale

    Dove si trova SUMMERDALE COURT LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Norcliffe House
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di SUMMERDALE COURT LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per SUMMERDALE COURT LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per SUMMERDALE COURT LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    13 pagineAA

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 05 ott 2015

    • Capitale: GBP 40
    5 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio annuale redatto al 06 apr 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital23 apr 2015

    Stato del capitale al 23 apr 2015

    • Capitale: GBP 400,002
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Ian Richard Smith il 19 feb 2015

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Benjamin Robert Taberner il 18 feb 2015

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di Dominic Jude Kay come amministratore in data 31 ott 2014

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    14 pagineAA

    Cessazione della carica di Dominic Kay come segretario

    1 pagineTM02

    Nomina di Mrs Abigail Mattison come segretario

    2 pagineAP03

    Dettagli del direttore cambiati per Maureen Claire Royston il 22 mag 2014

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 06 apr 2014 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital24 apr 2014

    Stato del capitale al 24 apr 2014

    • Capitale: GBP 400,002
    SH01

    Indirizzo della sede legale modificato da * Emerson Court Alderley Road Wilmslow Cheshire SK9 1NX* in data 21 feb 2014

    1 pagineAD01

    Nomina di Maureen Claire Royston come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Peter Calveley come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Ian Richard Smith come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    13 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 06 apr 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    14 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 06 apr 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di SUMMERDALE COURT LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MATTISON, Abigail
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    United Kingdom
    Segretario
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    United Kingdom
    188580880001
    ROYSTON, Maureen Claire, Dr
    Alderley Road
    Wilmslow
    SK9 1NX Cheshire
    Emerson Court
    England
    England
    Amministratore
    Alderley Road
    Wilmslow
    SK9 1NX Cheshire
    Emerson Court
    England
    England
    United KingdomBritish184190020002
    SMITH, Ian Richard
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    Amministratore
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    United KingdomBritish181082310001
    TABERNER, Benjamin Robert
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    Amministratore
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    United KingdomBritish150511890001
    BARBER, David Alan
    14 Pinewood Gate
    HG2 0JF Harrogate
    North Yorkshire
    Segretario
    14 Pinewood Gate
    HG2 0JF Harrogate
    North Yorkshire
    British69879580002
    CALDWELL, Charles Anthony
    26 Hampton Manor
    BT7 3EL Belfast
    County Antrim
    Segretario
    26 Hampton Manor
    BT7 3EL Belfast
    County Antrim
    British65779460001
    CROWE, Geoffrey Michael
    51 Oakwood Lane
    Bowdon
    WA14 3DL Altrincham
    Cheshire
    Segretario
    51 Oakwood Lane
    Bowdon
    WA14 3DL Altrincham
    Cheshire
    British38256680007
    KAY, Dominic Jude
    4 Glyn Avenue
    WA15 9DG Hale
    Cheshire
    Segretario
    4 Glyn Avenue
    WA15 9DG Hale
    Cheshire
    British145920530001
    MURPHY, Marc
    39 Cranmore Park
    BT9 6JF Belfast
    Segretario
    39 Cranmore Park
    BT9 6JF Belfast
    Irish88620540001
    PATTERSON, Gordon
    6 Cultra Park
    BT18 0QE Holywood
    County Down
    Segretario
    6 Cultra Park
    BT18 0QE Holywood
    County Down
    British65359330001
    CHETTLEBURGH INTERNATIONAL LIMITED
    Temple House
    20 Holywell Row
    EC2A 4JB London
    Segretario nominato
    Temple House
    20 Holywell Row
    EC2A 4JB London
    900000860001
    AUSTIN, Robert John
    The Cottage 8 Dockroyd
    Oakworth
    BD22 7RH Keighley
    West Yorkshire
    Amministratore
    The Cottage 8 Dockroyd
    Oakworth
    BD22 7RH Keighley
    West Yorkshire
    British49285440001
    CALDWELL, Charles Anthony
    26 Hampton Manor
    BT7 3EL Belfast
    County Antrim
    Amministratore
    26 Hampton Manor
    BT7 3EL Belfast
    County Antrim
    Northern IrelandBritish65779460001
    CALVELEY, Peter, Dr
    Canwick Hill
    Canwick
    LN4 2RF Lincoln
    The Old Vicarage
    Lincolnshire
    Amministratore
    Canwick Hill
    Canwick
    LN4 2RF Lincoln
    The Old Vicarage
    Lincolnshire
    United KingdomBritish131468590001
    HEHIR, Anthony Patrick
    Scolty Lodge 12 Oldfield Road
    Heswall
    CH60 6SE Wirral
    Merseyside
    Amministratore
    Scolty Lodge 12 Oldfield Road
    Heswall
    CH60 6SE Wirral
    Merseyside
    EnglandBritish111038070001
    HEYWOOD, Anthony George
    Harborough Hall Lane
    CO5 9UA Messing
    Harborough Hall
    Essex
    Amministratore
    Harborough Hall Lane
    CO5 9UA Messing
    Harborough Hall
    Essex
    EnglandBritish131288260001
    KAY, Dominic Jude
    4 Glyn Avenue
    WA15 9DG Hale
    Cheshire
    Amministratore
    4 Glyn Avenue
    WA15 9DG Hale
    Cheshire
    United KingdomBritish145920530001
    MITCHELL, Nicholas John
    Lymbrook
    53 Dore Road Dore
    S17 3NA Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    Lymbrook
    53 Dore Road Dore
    S17 3NA Sheffield
    South Yorkshire
    Great BritainBritish145102120001
    ORESCHNICK, Robert
    Bankfield Cold Hill Lane
    New Mill
    HD9 7JX Huddersfield
    West Yorkshire
    Amministratore
    Bankfield Cold Hill Lane
    New Mill
    HD9 7JX Huddersfield
    West Yorkshire
    American82179080001
    PATTERSON, Gordon
    No 5 Cultra Park
    BT18 0QE Holywood
    County Down
    Northern Ireland
    Amministratore
    No 5 Cultra Park
    BT18 0QE Holywood
    County Down
    Northern Ireland
    British66574310004
    PATTERSON, Gordon
    6 Cultra Park
    BT18 0QE Holywood
    County Down
    Amministratore
    6 Cultra Park
    BT18 0QE Holywood
    County Down
    Northern IrelandBritish65359330001
    PATTERSON, James
    19 Knockmore Park
    BT20 3SL Bangor
    County Down
    Northern Ireland
    Amministratore
    19 Knockmore Park
    BT20 3SL Bangor
    County Down
    Northern Ireland
    Northern IrelandBritish65359270002
    SEARCH, Annabel Shirley
    Old Orchard House Church Street
    Goldsborough
    HG5 8NR Knaresborough
    North Yorkshire
    Amministratore
    Old Orchard House Church Street
    Goldsborough
    HG5 8NR Knaresborough
    North Yorkshire
    British63367650001
    SMITH, Michael John
    11 Lower Park Road
    IG10 4NB Loughton
    Essex
    Amministratore
    11 Lower Park Road
    IG10 4NB Loughton
    Essex
    EnglandBritish641150001

    SUMMERDALE COURT LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of accession to a debenture dated 12 november 2004
    Creato il 11 mag 2005
    Consegnato il 27 mag 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All property, certain group shares, contracts specified in the rhyme debenture, certain intellectual property rights. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Scarlet Finance Limited
    Transazioni
    • 27 mag 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental legal charge (supplemental to composite guarantee and debenture dated 7TH october 1998)
    Creato il 18 ago 1999
    Consegnato il 21 ago 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies obligations and liabilities due or to become due from the obligors (as defined) or any of them to the chargee for itself and as trustee for the beneficiaries (as defined)under or in connection with the finance documents (as defined) and/or on any other account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a summerdale court nursing home 73 butchers road newham london E16 1PH t/nos: EGL340176 (part) and EGL350263 together with all buildings fixtures and fittings including trade fixtures and fittings and fixed plant and machinery from time to time thereon and/or the proceeds of sale thereof.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 21 ago 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 giu 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of accession (to composite guarnatee and mortgage debenture dated 7TH october 1998)
    Creato il 18 ago 1999
    Consegnato il 21 ago 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies obligations and liabilities due or to become due from the obligors (as defined) or any of them to the chargee for itself and as trustee for the beneficiaries (as defined)under or in connection with the finance documents (as defined) and/or on any other account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 21 ago 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 giu 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 06 mag 1999
    Consegnato il 14 mag 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land on the east side of butchers road canning town t/n EGL350263; f/h land k/a land on the east side of butchers road newham london t/n EGL340176. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Bhf-Bank Ag
    Transazioni
    • 14 mag 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 ago 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0