SUMMERDALE COURT LIMITED
Panoramica
| Nome della società | SUMMERDALE COURT LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03750254 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di SUMMERDALE COURT LIMITED?
- Altre attività di assistenza sanitaria (86900) / Attività sanitarie e di assistenza sociale
Dove si trova SUMMERDALE COURT LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Norcliffe House Station Road SK9 1BU Wilmslow |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di SUMMERDALE COURT LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2014 |
Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per SUMMERDALE COURT LIMITED?
| Bilancio annuale |
|
|---|
Quali sono le ultime deposizioni per SUMMERDALE COURT LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2014 | 13 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
Stato del capitale al 05 ott 2015
| 5 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 06 apr 2015 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Ian Richard Smith il 19 feb 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Benjamin Robert Taberner il 18 feb 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Dominic Jude Kay come amministratore in data 31 ott 2014 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2013 | 14 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Dominic Kay come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di Mrs Abigail Mattison come segretario | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Maureen Claire Royston il 22 mag 2014 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 06 apr 2014 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da * Emerson Court Alderley Road Wilmslow Cheshire SK9 1NX* in data 21 feb 2014 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Nomina di Maureen Claire Royston come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Peter Calveley come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Ian Richard Smith come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2012 | 13 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 06 apr 2013 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2011 | 14 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 06 apr 2012 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di SUMMERDALE COURT LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATTISON, Abigail | Segretario | Station Road SK9 1BU Wilmslow Norcliffe House United Kingdom | 188580880001 | |||||||
| ROYSTON, Maureen Claire, Dr | Amministratore | Alderley Road Wilmslow SK9 1NX Cheshire Emerson Court England England | United Kingdom | British | 184190020002 | |||||
| SMITH, Ian Richard | Amministratore | Station Road SK9 1BU Wilmslow Norcliffe House | United Kingdom | British | 181082310001 | |||||
| TABERNER, Benjamin Robert | Amministratore | Station Road SK9 1BU Wilmslow Norcliffe House | United Kingdom | British | 150511890001 | |||||
| BARBER, David Alan | Segretario | 14 Pinewood Gate HG2 0JF Harrogate North Yorkshire | British | 69879580002 | ||||||
| CALDWELL, Charles Anthony | Segretario | 26 Hampton Manor BT7 3EL Belfast County Antrim | British | 65779460001 | ||||||
| CROWE, Geoffrey Michael | Segretario | 51 Oakwood Lane Bowdon WA14 3DL Altrincham Cheshire | British | 38256680007 | ||||||
| KAY, Dominic Jude | Segretario | 4 Glyn Avenue WA15 9DG Hale Cheshire | British | 145920530001 | ||||||
| MURPHY, Marc | Segretario | 39 Cranmore Park BT9 6JF Belfast | Irish | 88620540001 | ||||||
| PATTERSON, Gordon | Segretario | 6 Cultra Park BT18 0QE Holywood County Down | British | 65359330001 | ||||||
| CHETTLEBURGH INTERNATIONAL LIMITED | Segretario nominato | Temple House 20 Holywell Row EC2A 4JB London | 900000860001 | |||||||
| AUSTIN, Robert John | Amministratore | The Cottage 8 Dockroyd Oakworth BD22 7RH Keighley West Yorkshire | British | 49285440001 | ||||||
| CALDWELL, Charles Anthony | Amministratore | 26 Hampton Manor BT7 3EL Belfast County Antrim | Northern Ireland | British | 65779460001 | |||||
| CALVELEY, Peter, Dr | Amministratore | Canwick Hill Canwick LN4 2RF Lincoln The Old Vicarage Lincolnshire | United Kingdom | British | 131468590001 | |||||
| HEHIR, Anthony Patrick | Amministratore | Scolty Lodge 12 Oldfield Road Heswall CH60 6SE Wirral Merseyside | England | British | 111038070001 | |||||
| HEYWOOD, Anthony George | Amministratore | Harborough Hall Lane CO5 9UA Messing Harborough Hall Essex | England | British | 131288260001 | |||||
| KAY, Dominic Jude | Amministratore | 4 Glyn Avenue WA15 9DG Hale Cheshire | United Kingdom | British | 145920530001 | |||||
| MITCHELL, Nicholas John | Amministratore | Lymbrook 53 Dore Road Dore S17 3NA Sheffield South Yorkshire | Great Britain | British | 145102120001 | |||||
| ORESCHNICK, Robert | Amministratore | Bankfield Cold Hill Lane New Mill HD9 7JX Huddersfield West Yorkshire | American | 82179080001 | ||||||
| PATTERSON, Gordon | Amministratore | No 5 Cultra Park BT18 0QE Holywood County Down Northern Ireland | British | 66574310004 | ||||||
| PATTERSON, Gordon | Amministratore | 6 Cultra Park BT18 0QE Holywood County Down | Northern Ireland | British | 65359330001 | |||||
| PATTERSON, James | Amministratore | 19 Knockmore Park BT20 3SL Bangor County Down Northern Ireland | Northern Ireland | British | 65359270002 | |||||
| SEARCH, Annabel Shirley | Amministratore | Old Orchard House Church Street Goldsborough HG5 8NR Knaresborough North Yorkshire | British | 63367650001 | ||||||
| SMITH, Michael John | Amministratore | 11 Lower Park Road IG10 4NB Loughton Essex | England | British | 641150001 |
SUMMERDALE COURT LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of accession to a debenture dated 12 november 2004 | Creato il 11 mag 2005 Consegnato il 27 mag 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All property, certain group shares, contracts specified in the rhyme debenture, certain intellectual property rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Supplemental legal charge (supplemental to composite guarantee and debenture dated 7TH october 1998) | Creato il 18 ago 1999 Consegnato il 21 ago 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies obligations and liabilities due or to become due from the obligors (as defined) or any of them to the chargee for itself and as trustee for the beneficiaries (as defined)under or in connection with the finance documents (as defined) and/or on any other account whatsoever | |
Brevi particolari F/H property k/a summerdale court nursing home 73 butchers road newham london E16 1PH t/nos: EGL340176 (part) and EGL350263 together with all buildings fixtures and fittings including trade fixtures and fittings and fixed plant and machinery from time to time thereon and/or the proceeds of sale thereof. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of accession (to composite guarnatee and mortgage debenture dated 7TH october 1998) | Creato il 18 ago 1999 Consegnato il 21 ago 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies obligations and liabilities due or to become due from the obligors (as defined) or any of them to the chargee for itself and as trustee for the beneficiaries (as defined)under or in connection with the finance documents (as defined) and/or on any other account whatsoever | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 06 mag 1999 Consegnato il 14 mag 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H land on the east side of butchers road canning town t/n EGL350263; f/h land k/a land on the east side of butchers road newham london t/n EGL340176. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0