BRIXTON (FRADLEY) LIMITED

BRIXTON (FRADLEY) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBRIXTON (FRADLEY) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03752788
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BRIXTON (FRADLEY) LIMITED?

    • (7499) /

    Dove si trova BRIXTON (FRADLEY) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BRIXTON (FRADLEY) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    INDUSTRIOUS (FRADLEY) LIMITED16 set 200216 set 2002
    SAVILLE GORDON ESTATES (FRADLEY AERODROME) LIMITED14 giu 199914 giu 1999
    DUALSHAPE LIMITED15 apr 199915 apr 1999

    Quali sono gli ultimi bilanci di BRIXTON (FRADLEY) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per BRIXTON (FRADLEY) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 17 ott 2012

    4 pagine4.68

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    4 pagine4.71

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 27 set 2012

    4 pagine4.68

    Cessazione della carica di David Crawford Bridges come amministratore in data 23 mar 2012

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Vanessa Kate Simms come amministratore in data 01 dic 2011

    1 pagineTM01

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 28 set 2011

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Indirizzo della sede legale modificato da Cunard House 15 Regent Street London SW1Y 4LR in data 12 ott 2011

    2 pagineAD01

    legacy

    3 pagineMG02

    Dettagli del direttore cambiati per Mr David Crawford Bridges il 08 set 2011

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Gareth John Osborn il 08 set 2011

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 mag 2011 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital15 giu 2011

    Stato del capitale al 15 giu 2011

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Vanessa Kate Simms il 13 dic 2010

    2 pagineCH01

    Nomina di Mr Simon Andrew Carlyon come amministratore

    2 pagineAP01

    Dettagli del direttore cambiati per Vanessa Kate Simms il 31 ago 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Elizabeth Ann Blease il 26 lug 2010

    2 pagineCH03

    Bilancio annuale redatto al 31 mag 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    6 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da 234 Bath Road Slough SL1 4EE in data 01 lug 2010

    1 pagineAD01

    Nomina di Vanessa Kate Simms come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr David Crawford Bridges come amministratore

    2 pagineAP01

    Dettagli del segretario cambiati per Elizabeth Ann Blease il 17 nov 2009

    1 pagineCH03

    Chi sono gli amministratori di BRIXTON (FRADLEY) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BLEASE, Elizabeth Ann
    Cunard House
    15 Regent Street
    SW1Y 4LR London
    Cunard House
    England
    Segretario
    Cunard House
    15 Regent Street
    SW1Y 4LR London
    Cunard House
    England
    Other132060350001
    CARLYON, Simon Andrew
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    Amministratore
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    United KingdomAustralian158659290001
    OSBORN, Gareth John
    Bath Road
    234 Bath Road
    SL1 4EE Slough
    234
    Berkshire
    England
    Amministratore
    Bath Road
    234 Bath Road
    SL1 4EE Slough
    234
    Berkshire
    England
    United KingdomBritish91257750002
    REDDING, Philip Anthony
    Marina Place
    Hampton Wick
    KT1 4BH Kingston-Upon-Thames
    29
    Surrey
    England
    Amministratore
    Marina Place
    Hampton Wick
    KT1 4BH Kingston-Upon-Thames
    29
    Surrey
    England
    EnglandBritish126099150003
    EDWARDS, John William
    The Garden House Wolverton Road
    Norton Lindsey
    CV35 8LJ Warwickshire
    Segretario
    The Garden House Wolverton Road
    Norton Lindsey
    CV35 8LJ Warwickshire
    British44610010001
    HOWELL, Richard
    36 Arterberry Road
    Wimbledon
    SW20 8AQ London
    Flat 7 Kilmeny House
    Segretario
    36 Arterberry Road
    Wimbledon
    SW20 8AQ London
    Flat 7 Kilmeny House
    British130136450001
    MELIA, Ian Charles
    3 The Oaks
    Downs Avenue
    KT18 5HH Epsom
    Surrey
    Segretario
    3 The Oaks
    Downs Avenue
    KT18 5HH Epsom
    Surrey
    British36647460001
    SILVER, Helen Frances
    68 Glenwood Gardens
    IG2 6XU Ilford
    Essex
    Segretario
    68 Glenwood Gardens
    IG2 6XU Ilford
    Essex
    British120878580001
    WHALLEY, Amanda
    12 Merchant Court
    61 Wapping Wall Wapping
    E1W 3SD London
    Segretario
    12 Merchant Court
    61 Wapping Wall Wapping
    E1W 3SD London
    British124348320001
    WILBRAHAM, Simon Nicholas
    Queens Crescent
    AL4 9QG St. Albans
    19
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Segretario
    Queens Crescent
    AL4 9QG St. Albans
    19
    Hertfordshire
    United Kingdom
    British125719290002
    YOUNG, Mark Lees
    30 Southway
    Totteridge
    N20 8DB London
    Segretario
    30 Southway
    Totteridge
    N20 8DB London
    British85330350001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ALEXANDER, Mark Henry Campbell
    Perrymill Farm
    Inkberrow
    WR7 4JQ Worcester
    Amministratore
    Perrymill Farm
    Inkberrow
    WR7 4JQ Worcester
    United KingdomBritish60875240001
    BRIDGES, David Crawford
    Bath Road
    234 Bath Road
    SL1 4EE Slough
    234
    Berkshire
    England
    Amministratore
    Bath Road
    234 Bath Road
    SL1 4EE Slough
    234
    Berkshire
    England
    United KingdomBritish94982860002
    CAREY, Roger William
    Instow
    Burtons Way
    HP8 4BP Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Instow
    Burtons Way
    HP8 4BP Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish6069370001
    CLIVE, Nicholas Richard
    South House Roke Marsh
    Roke
    OX10 6JB Wallingford
    Oxfordshire
    Amministratore
    South House Roke Marsh
    Roke
    OX10 6JB Wallingford
    Oxfordshire
    British65521850001
    DAWSON, Peter Allan
    9 St James Close
    St Johns Wood
    NW8 7LG London
    Amministratore
    9 St James Close
    St Johns Wood
    NW8 7LG London
    British64472530003
    HOWELL, Richard
    Flat 7 Kilmeny House
    36 Arterberry Road Wimbledon
    SW20 8AQ London
    Amministratore
    Flat 7 Kilmeny House
    36 Arterberry Road Wimbledon
    SW20 8AQ London
    EnglandBritish164790590001
    KEOGAN, John Stephen Philip
    Fox Cottage
    Market Square Kineton
    CV35 0LP Warwick
    Warwickshire
    Amministratore
    Fox Cottage
    Market Square Kineton
    CV35 0LP Warwick
    Warwickshire
    EnglandBritish60874620002
    MELIA, Ian Charles
    3 The Oaks
    Downs Avenue
    KT18 5HH Epsom
    Surrey
    Amministratore
    3 The Oaks
    Downs Avenue
    KT18 5HH Epsom
    Surrey
    UkBritish36647460001
    OWEN, Steven Jonathan
    Foxholes
    Farley Green
    GU5 9DN Albury
    Surrey
    Amministratore
    Foxholes
    Farley Green
    GU5 9DN Albury
    Surrey
    United KingdomBritish29079190002
    SAVILLE, David John
    Avonside
    Grange Road Bidford On Avon
    B50 4BY Alcester
    Warwickshire
    Amministratore
    Avonside
    Grange Road Bidford On Avon
    B50 4BY Alcester
    Warwickshire
    British90607320001
    SIMMS, Vanessa Kate
    Bath Road
    234 Bath Road .
    SL1 4EE Slough
    234
    .
    England
    Amministratore
    Bath Road
    234 Bath Road .
    SL1 4EE Slough
    234
    .
    England
    United KingdomBritish155054720002
    WHALLEY, Amanda
    12 Merchant Court
    61 Wapping Wall Wapping
    E1W 3SD London
    Amministratore
    12 Merchant Court
    61 Wapping Wall Wapping
    E1W 3SD London
    British124348320001
    WHEELER, Timothy Clive
    The House In The Wood
    Northchurch Lane Ashley Green
    HP5 3PD Berkhamsted
    Hertfordshire
    Amministratore
    The House In The Wood
    Northchurch Lane Ashley Green
    HP5 3PD Berkhamsted
    Hertfordshire
    United KingdomUnited Kingdom53208700002
    WILBRAHAM, Simon Nicholas
    Queens Crescent
    AL4 9QG St. Albans
    19
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Queens Crescent
    AL4 9QG St. Albans
    19
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish125719290002
    YOUNG, Mark Lees
    30 Southway
    Totteridge
    N20 8DB London
    Amministratore
    30 Southway
    Totteridge
    N20 8DB London
    British85330350001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    BRIXTON (FRADLEY) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 10 dic 2002
    Consegnato il 20 dic 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the borrower (as defined) and the company to all or any of the secured parties (as defined) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H land and buildings in the north east side woodford lane alrewas staffordshire t/n SF310783. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Morgan Stanley Mortgage Servicing Limited (The "Security Trustee")
    Transazioni
    • 20 dic 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 set 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A debenture creating fixed and floating charges
    Creato il 02 ott 2000
    Consegnato il 11 ott 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies and liabilities due or to become due from the company to the chargee under the terms of the transaction documents
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC in Its Capacity as Security Trustee
    Transazioni
    • 11 ott 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 dic 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 21 set 2000
    Consegnato il 30 set 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land and buildings on the north east side of woodend lane alrewas t/n SF310783. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 30 set 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 dic 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    BRIXTON (FRADLEY) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    24 gen 2013Data di scioglimento
    28 set 2011Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Malcolm Cohen
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Praticante
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0