WHINNEY HILL ENERGY 2 LIMITED

WHINNEY HILL ENERGY 2 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàWHINNEY HILL ENERGY 2 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03754359
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di WHINNEY HILL ENERGY 2 LIMITED?

    • Produzione di energia elettrica (35110) / Fornitura di elettricità, gas, vapore e aria condizionata

    Dove si trova WHINNEY HILL ENERGY 2 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    6th Floor 33 Holborn
    EC1N 2HT London
    England
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di WHINNEY HILL ENERGY 2 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per WHINNEY HILL ENERGY 2 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 29 nov 2019

    • Capitale: GBP 0.01
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    The issued shares capital of the company redeuced from £37,485.59 to £0.01 by cancelling and extinguishing 3,748,558 ordinary shares of £0.01 each in the capital of the company 13/11/2019
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Dichiarazione di conformità presentata il 25 apr 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Nomina di Octopus Company Secretarial Services Limited come segretario in data 15 nov 2018

    2 pagineAP04

    Cessazione della carica di Sharna Ludlow come segretario in data 15 nov 2018

    1 pagineTM02

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2018

    5 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Paul Stephen Latham il 07 set 2018

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Company Secretary Sharna Ludlow il 25 apr 2018

    1 pagineCH03

    Dichiarazione di conformità presentata il 25 apr 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Dettagli del segretario cambiati per Company Secretary Sharna Ludlow il 16 mar 2018

    1 pagineCH03

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2017

    5 pagineAA

    Cessazione della carica di Kamalika Ria Banerjee come segretario in data 19 feb 2018

    1 pagineTM02

    Nomina di Kamalika Ria Banerjee come segretario in data 30 ott 2017

    2 pagineAP03

    Nomina di Mr Paul Stephen Latham come amministratore in data 15 ago 2017

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 27 apr 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Matthew George Setchell il 20 feb 2017

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2016

    5 pagineAA

    Cessazione della carica di Tim James Senior come amministratore in data 06 ott 2016

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Matthew George Setchell come amministratore in data 06 ott 2016

    2 pagineAP01

    I registri sono stati trasferiti all'indirizzo della sede legale registrata 6th Floor 33 Holborn London England EC1N 2HT

    2 pagineAD04

    Chi sono gli amministratori di WHINNEY HILL ENERGY 2 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    OCTOPUS COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    England
    England
    Segretario
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    England
    England
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione11677818
    253893850001
    LATHAM, Paul Stephen
    33 Holborn
    EC1N 2HT London
    6th Floor
    England
    England
    Amministratore
    33 Holborn
    EC1N 2HT London
    6th Floor
    England
    England
    United KingdomBritish146527710002
    SETCHELL, Matthew George
    33 Holborn
    EC1N 2HT London
    6th Floor
    England
    England
    Amministratore
    33 Holborn
    EC1N 2HT London
    6th Floor
    England
    England
    EnglandBritish157021230004
    WILKINSON, Edwin John
    Deben Mill Business Centre
    Old Maltings Approach
    IP12 1BL Woodbridge
    6
    Suffolk
    United Kingdom
    Amministratore
    Deben Mill Business Centre
    Old Maltings Approach
    IP12 1BL Woodbridge
    6
    Suffolk
    United Kingdom
    EnglandBritish86926370001
    BANERJEE, Kamalika Ria
    33 Holborn
    EC1N 2HT London
    6th Floor
    England
    England
    Segretario
    33 Holborn
    EC1N 2HT London
    6th Floor
    England
    England
    239579570001
    FITZHERBERT, David Henry
    12 Gordon Place
    W8 4JD London
    Segretario
    12 Gordon Place
    W8 4JD London
    Irish74254060001
    GOOLD, James Edward Ian
    37 Lavender Sweep
    SW11 1DY London
    Segretario
    37 Lavender Sweep
    SW11 1DY London
    British63011810002
    LUDLOW, Sharna, Company Secretary
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    England
    England
    Segretario
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    England
    England
    208745520001
    PENTECOST, Alexandra Helen
    2 Stratton Villas
    Milbourne
    SN16 9JB Malmesbury
    Wiltshire
    Segretario
    2 Stratton Villas
    Milbourne
    SN16 9JB Malmesbury
    Wiltshire
    British70254590001
    WARD, Karen
    33 Holborn
    EC1N 2HT London
    6th Floor
    England
    England
    Segretario
    33 Holborn
    EC1N 2HT London
    6th Floor
    England
    England
    204136920001
    EVERSECRETARY LIMITED
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    Segretario
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    60471940015
    FITZHERBERT, David Henry
    12 Gordon Place
    W8 4JD London
    Amministratore
    12 Gordon Place
    W8 4JD London
    United KingdomIrish74254060001
    GOOLD, James Edward Ian
    37 Lavender Sweep
    SW11 1DY London
    Amministratore
    37 Lavender Sweep
    SW11 1DY London
    British63011810002
    HOLMES, Randall Duane
    36 Neustadt Lane
    10514 Chappaqua
    New York Ny 10514
    Usa
    Amministratore
    36 Neustadt Lane
    10514 Chappaqua
    New York Ny 10514
    Usa
    American64549270001
    PATON, John Derek
    Deben Mill Business Centre
    Old Maltings Approach
    IP12 1BL Woodbridge
    6
    Suffolk
    United Kingdom
    Amministratore
    Deben Mill Business Centre
    Old Maltings Approach
    IP12 1BL Woodbridge
    6
    Suffolk
    United Kingdom
    United KingdomBritish76165310001
    SENIOR, Timothy James, Dr
    33 Holborn
    EC1N 2HT London
    6th Floor
    England
    England
    Amministratore
    33 Holborn
    EC1N 2HT London
    6th Floor
    England
    England
    EnglandBritish244462470001
    SWANSON, Robert Ernest
    119 Turtle Point Road
    Tuxedo Park
    New York 10987
    Usa
    Amministratore
    119 Turtle Point Road
    Tuxedo Park
    New York 10987
    Usa
    American95188450001
    THORNEYCROFT, Maxwell Bennett
    80 Elgin Crescent
    W11 2JL London
    Amministratore
    80 Elgin Crescent
    W11 2JL London
    United KingdomBritish3367180002
    TILSTONE, David Paul
    12 Manor Road
    TN4 8UE Tunbridge Wells
    Kent
    Amministratore
    12 Manor Road
    TN4 8UE Tunbridge Wells
    Kent
    United KingdomBritish117871440001
    WEST, Andrew Thomas
    4 Filkins Hall
    Filkins
    GL7 3JJ Lechdale
    Gloucestershire
    Amministratore
    4 Filkins Hall
    Filkins
    GL7 3JJ Lechdale
    Gloucestershire
    United KingdomBritish79568920001
    WILSON, Douglas Ralph
    312 Highland Avenue
    07450 Ridgewood
    New Jersey 07450
    Usa
    Amministratore
    312 Highland Avenue
    07450 Ridgewood
    New Jersey 07450
    Usa
    American91734800002
    WYNDHAM, Harry Hugh Patrick
    56 Stockwell Park Crescent
    SW9 0DG London
    Amministratore
    56 Stockwell Park Crescent
    SW9 0DG London
    EnglandBritish37118660001

    Chi sono le persone con controllo significativo di WHINNEY HILL ENERGY 2 LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    33 Holborn
    EC1N 2HT London
    6th Floor
    England
    England
    06 apr 2016
    33 Holborn
    EC1N 2HT London
    6th Floor
    England
    England
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleUnited Kingdom (England)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione03966429
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    WHINNEY HILL ENERGY 2 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 21 gen 2010
    Consegnato il 22 gen 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Fortis Bank, UK Branch
    Transazioni
    • 22 gen 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 12 mag 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 22 feb 2007
    Consegnato il 09 mar 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The secured obligations under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All land equipment insurances debts goodwill and uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Fortis Bank S.A./N.V. on Behalf of Itself and the Finance Parties
    Transazioni
    • 09 mar 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 mag 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 04 mag 2006
    Consegnato il 17 mag 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company,by each borrower and each other project company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All its interest in the property,together with all buildings and fixtures thereon,the proceeds of sale of all or any part thereof and the benefit of any covenants. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 17 mag 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of accession
    Creato il 16 ott 2001
    Consegnato il 30 ott 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All money and all obligations and liabilities due or to become due by the chargor to the chargee (the bank) under or pursuant to the composite guarantee and debenture dated 30TH june 2000 and the deed of accession and all moneys and liabilities now or hereafter due owing or incurred to the bank (including without limitation all moneys and liabilities due owing or incurred under or pursuant to the facility agreement) by each other company on any account whatsoever (all terms as defined)
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 30 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 03 lug 2000
    Consegnato il 21 lug 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 21 lug 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 nov 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0