FSG SECURITY PLC

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàFSG SECURITY PLC
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà per azioni
    Numero di società 03759409
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di FSG SECURITY PLC?

    • (7460) /

    Dove si trova FSG SECURITY PLC?

    Indirizzo della sede legale
    Pannell House
    159 Charles Street
    LE1 1LD Leicester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di FSG SECURITY PLC?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ECOHAZEL LTD26 apr 199926 apr 1999

    Quali sono gli ultimi bilanci di FSG SECURITY PLC?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2008

    Quali sono le ultime deposizioni per FSG SECURITY PLC?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    10 pagine4.72

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 01 giu 2013

    2 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 01 giu 2012

    11 pagine4.68

    Ordinanza giudiziaria in materia di insolvenza

    Court order INSOLVENCY:replacement of liquidator
    34 pagineLIQ MISC OC

    Avviso di cessazione di funzioni come liquidatore volontario

    1 pagine4.40

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 13 ott 2011

    12 pagine4.68

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Ordinanza giudiziaria in materia di insolvenza

    Court order insolvency:- replacement of liquidator
    27 pagineLIQ MISC OC

    Avviso di cessazione di funzioni come liquidatore volontario

    1 pagine4.40

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 29 lug 2011

    11 pagine4.68

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    3 pagineF10.2

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 23 lug 2010

    13 pagine2.24B

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    11 pagine2.34B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 27 feb 2010

    12 pagine2.24B

    Risultato della riunione dei creditori

    3 pagine2.23B

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.15B/2.14B

    53 pagine2.16B

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    58 pagine2.17B

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine287

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    legacy

    1 pagine288c

    Chi sono gli amministratori di FSG SECURITY PLC?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WOODFORD, Christopher
    Wall Hill Road
    Allesley
    CV5 9EN Coventry
    3
    West Midlands
    Amministratore
    Wall Hill Road
    Allesley
    CV5 9EN Coventry
    3
    West Midlands
    British107149630004
    BOWDEN, Garry Raymond
    3 Perryford Drive
    B91 3XE Solihull
    West Midlands
    Segretario
    3 Perryford Drive
    B91 3XE Solihull
    West Midlands
    Australian46567860001
    CASHMORE, Michael James
    16 Nightingale Court
    Kelvedon Grove
    B91 2UG Solihull
    West Midlands
    Segretario
    16 Nightingale Court
    Kelvedon Grove
    B91 2UG Solihull
    West Midlands
    British94577950001
    CONYBEARE, Steven James
    113-123 Upper Richmond Road
    SW15 2TL London
    Segretario
    113-123 Upper Richmond Road
    SW15 2TL London
    British62127530001
    DAVIES, Keith
    49 Landor Road
    Knowle
    B93 9HZ Solihull
    Segretario
    49 Landor Road
    Knowle
    B93 9HZ Solihull
    British85602300001
    DONEGAN, Simon Patrick
    The Old School House
    Northend
    RG9 6LJ Henley Upon Thames
    Oxfordshire
    Segretario
    The Old School House
    Northend
    RG9 6LJ Henley Upon Thames
    Oxfordshire
    British77399210003
    LAWRENCE, Christopher
    4 Sunderland Close
    RG5 4XR Woodley
    Berkshire
    Segretario
    4 Sunderland Close
    RG5 4XR Woodley
    Berkshire
    British77399470001
    WAKELEY, David Peacefull
    166 Rosemary Hill Road
    B74 4HN Sutton Coldfield
    West Midlands
    Segretario
    166 Rosemary Hill Road
    B74 4HN Sutton Coldfield
    West Midlands
    British86839080001
    WEBB, David John
    44 Phipps Hatch Lane
    EN2 0HN Enfield
    Middlesex
    Segretario
    44 Phipps Hatch Lane
    EN2 0HN Enfield
    Middlesex
    British38372670002
    FORM 10 SECRETARIES FD LTD
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    Segretario nominato
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    900014000001
    BOWDEN, Garry Raymond
    3 Perryford Drive
    B91 3XE Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    3 Perryford Drive
    B91 3XE Solihull
    West Midlands
    Australian46567860001
    BROWN, Neil Philip
    5 Woodlands Lane
    NN18 8HJ Great Oakley
    Northamptonshire
    Amministratore
    5 Woodlands Lane
    NN18 8HJ Great Oakley
    Northamptonshire
    British81334660001
    CAPON, Val St John
    21 The Street
    Rustington
    BN16 3PA Littlehampton
    West Sussex
    Amministratore
    21 The Street
    Rustington
    BN16 3PA Littlehampton
    West Sussex
    EnglandBritish96311330002
    DONEGAN, Simon Patrick
    The Old School House
    Northend
    RG9 6LJ Henley Upon Thames
    Oxfordshire
    Amministratore
    The Old School House
    Northend
    RG9 6LJ Henley Upon Thames
    Oxfordshire
    British77399210003
    GUNSTON, John Wellesley, Sir
    12 Carlyle Court
    Chelsea Harbour
    SW10 0UQ London
    Amministratore
    12 Carlyle Court
    Chelsea Harbour
    SW10 0UQ London
    British45875000002
    HALLER, Frederic Zachary
    The Brick House 2a Dunstan Road
    NW11 8AA London
    Amministratore
    The Brick House 2a Dunstan Road
    NW11 8AA London
    EnglandBritish36104430001
    HIGGINS, Neil
    6 Lurgashall
    RH15 0BL Burgess Hill
    West Sussex
    Amministratore
    6 Lurgashall
    RH15 0BL Burgess Hill
    West Sussex
    British64447450002
    HOBBS, Keith Raymond
    Benwhyles
    Medstead
    GU34 5EA Alton
    Amministratore
    Benwhyles
    Medstead
    GU34 5EA Alton
    United KingdomBritish707020001
    LAWRENCE, Christopher
    4 Sunderland Close
    RG5 4XR Woodley
    Berkshire
    Amministratore
    4 Sunderland Close
    RG5 4XR Woodley
    Berkshire
    United Kingdom British77399470001
    LOCKIE, Dean Royston
    33 Stockburn Drive
    M35 9SD Failsworth
    Manchester
    Amministratore
    33 Stockburn Drive
    M35 9SD Failsworth
    Manchester
    British76878680001
    LUNN, Andrew Jonathan
    30 Shirland Street
    S41 7NH Chesterfield
    Derbyshire
    Amministratore
    30 Shirland Street
    S41 7NH Chesterfield
    Derbyshire
    British70754600002
    MARTIN, Leslie John, Mr.
    Parchfield House
    Colton Road
    WS15 3HG Rugeley
    Staffs
    Amministratore
    Parchfield House
    Colton Road
    WS15 3HG Rugeley
    Staffs
    EnglandEnglish116204820001
    O'REILLY, Anthony James
    3 Melton Road
    NG12 5PH Stanton On The Wolds
    Nottinghamshire
    Amministratore
    3 Melton Road
    NG12 5PH Stanton On The Wolds
    Nottinghamshire
    British97146280002
    ROBERTSON, Robert William
    117 Winwick Road
    WA12 8DB Newton Le Willows
    Merseyside
    Amministratore
    117 Winwick Road
    WA12 8DB Newton Le Willows
    Merseyside
    British100065310001
    SCOTT, Andrew Hillyer
    Lower Lye
    Holloway, East Knoyle
    SP3 6AQ Salisbury
    Wiltshire
    Amministratore
    Lower Lye
    Holloway, East Knoyle
    SP3 6AQ Salisbury
    Wiltshire
    United KingdomBritish64012720001
    TAFT, David Jackson
    The Croft
    Worcester Road Broome
    DY9 0HS Stourbridge
    West Midlands
    Amministratore
    The Croft
    Worcester Road Broome
    DY9 0HS Stourbridge
    West Midlands
    UkBritish82677730001
    WAKELEY, David Peacefull
    166 Rosemary Hill Road
    B74 4HN Sutton Coldfield
    West Midlands
    Amministratore
    166 Rosemary Hill Road
    B74 4HN Sutton Coldfield
    West Midlands
    United KingdomBritish86839080001
    FORM 10 DIRECTORS FD LTD
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    Amministratore delegato nominato
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    900013990001

    FSG SECURITY PLC ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Fixed and floating charge
    Creato il 01 giu 2006
    Consegnato il 07 giu 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transazioni
    • 07 giu 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 30 mag 2006
    Consegnato il 03 giu 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 03 giu 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Guarantee & debenture
    Creato il 20 gen 2005
    Consegnato il 27 gen 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 27 gen 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 lug 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 14 mar 2003
    Consegnato il 20 mar 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 20 mar 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 mag 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest
    Creato il 31 dic 2002
    Consegnato il 03 gen 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of fixed equitable charge all debts purchased or purported to be purchased by the chargee pursuant to an agreement for the purchase of debts between the chargee and the company (including the associated rights relating thereto) which fail to vest effectively or absolutely in the chargee for any reason.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD
    Transazioni
    • 03 gen 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 mag 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 11 giu 2002
    Consegnato il 20 giu 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 20 giu 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 apr 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 30 ott 2001
    Consegnato il 01 nov 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 01 nov 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 mag 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 10 gen 2000
    Consegnato il 13 gen 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a lease of even date
    Brevi particolari
    The initial deposit of £3,779.95 plus further sums.
    Persone aventi diritto
    • Barlows Developments Limited
    Transazioni
    • 13 gen 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 mag 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    FSG SECURITY PLC ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    30 lug 2010Fine dell'amministrazione
    28 ago 2009Inizio dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Brian James Hamblin
    Pkf
    New Guild House
    B3 2LX 45 Great Charles Street
    Queensway Birmingham
    Praticante
    Pkf
    New Guild House
    B3 2LX 45 Great Charles Street
    Queensway Birmingham
    Edward Terence Kerr
    Pkf
    Pannell House
    LE1 1LD 159 Charles Street
    Leicester
    Praticante
    Pkf
    Pannell House
    LE1 1LD 159 Charles Street
    Leicester
    2
    DataTipo
    17 apr 2014Data di scioglimento
    30 lug 2010Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Brian James Hamblin
    Pkf
    New Guild House
    B3 2LX 45 Great Charles Street
    Queensway Birmingham
    Praticante
    Pkf
    New Guild House
    B3 2LX 45 Great Charles Street
    Queensway Birmingham
    Edward Terence Kerr
    Pkf
    Pannell House
    LE1 1LD 159 Charles Street
    Leicester
    Praticante
    Pkf
    Pannell House
    LE1 1LD 159 Charles Street
    Leicester
    Ian James Gould
    Bdo Llp Pannell House
    159 Charles Street
    LE1 1LD Leicester
    Praticante
    Bdo Llp Pannell House
    159 Charles Street
    LE1 1LD Leicester

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0