FRASERS FB (PEPYS STREET) LIMITED

FRASERS FB (PEPYS STREET) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàFRASERS FB (PEPYS STREET) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03761720
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di FRASERS FB (PEPYS STREET) LIMITED?

    • (4521) /
    • (7011) /

    Dove si trova FRASERS FB (PEPYS STREET) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    81 Cromwell Road
    London
    SW7 5BW
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di FRASERS FB (PEPYS STREET) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    FAIRBRIAR PEPYS STREET LTD14 giu 200114 giu 2001
    FAIRPOINT PROPERTIES LIMITED07 dic 199907 dic 1999
    TYROLESE (450) LIMITED28 apr 199928 apr 1999

    Quali sono gli ultimi bilanci di FRASERS FB (PEPYS STREET) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per FRASERS FB (PEPYS STREET) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Cessazione della carica di Valsec Company Secretarial Services Limited come segretario

    1 pagineTM02

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 28 apr 2011 con elenco completo degli azionisti

    14 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital13 mag 2011

    Stato del capitale al 13 mag 2011

    • Capitale: GBP 1,001
    SH01

    Bilancio redatto al 30 set 2010

    10 pagineAA

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    SC removed 23/12/2010
    RES13

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Sect 551 ca 2006 23/12/2010
    RES13

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed fairbriar pepys street LTD\certificate issued on 19/01/11
    4 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name19 gen 2011

    Avviso di cambio di nome"

    CONNOT

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 23 dic 2010

    RES15

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 23 dic 2010

    • Capitale: GBP 1,000
    3 pagineSH01

    Cessazione della carica di Valad Secretarial Services Limited come segretario

    2 pagineTM02

    Nomina di Valsec Company Secretarial Services Limited come segretario

    3 pagineAP04

    Bilancio redatto al 30 set 2009

    11 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 28 apr 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del segretario cambiati per Valad Secretarial Services Limited il 28 apr 2010

    2 pagineCH04

    Dettagli del direttore cambiati per Dr Stanley Swee Han Quek il 01 ott 2009

    3 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Simon John Patrick Lear il 01 ott 2009

    3 pagineCH01

    Bilancio redatto al 30 set 2008

    12 pagineAA

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    2 pagine288c

    Bilancio redatto al 30 set 2007

    10 pagineAA

    legacy

    2 pagine288a

    Chi sono gli amministratori di FRASERS FB (PEPYS STREET) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    NG, Seng Khoon
    101 Coldershaw Road
    W13 9DU London
    Segretario
    101 Coldershaw Road
    W13 9DU London
    British90211410001
    LEAR, Simon John Patrick
    Cromwell Road
    SW7 5BW London
    81
    Amministratore
    Cromwell Road
    SW7 5BW London
    81
    United KingdomBritish138750860001
    QUEK, Stanley Swee Han, Dr
    Cromwell Road
    SW7 5BW London
    81
    Amministratore
    Cromwell Road
    SW7 5BW London
    81
    SingaporeSingaporean123800250001
    BALCHIN, Mark Nicholas
    6 Fleming Close
    GU14 8BT Farnborough
    Hampshire
    Segretario
    6 Fleming Close
    GU14 8BT Farnborough
    Hampshire
    British812680001
    TYROLESE (SECRETARIAL) LIMITED
    66 Lincoln's Inn Fields
    WC2A 3LH London
    Segretario nominato
    66 Lincoln's Inn Fields
    WC2A 3LH London
    900002460001
    VALAD SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Melville Street
    EH3 7NS Edinburgh
    4a
    Scotland
    Segretario
    Melville Street
    EH3 7NS Edinburgh
    4a
    Scotland
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazioneSC219311
    133355520001
    VALSEC COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    Segretario
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione7307485
    154200410001
    BALCHIN, Mark Nicholas
    6 Fleming Close
    GU14 8BT Farnborough
    Hampshire
    Amministratore
    6 Fleming Close
    GU14 8BT Farnborough
    Hampshire
    UkBritish812680001
    HENG, Jeffrey Wah Yong
    60 Chuan Garden
    FOREIGN Singapore
    558570
    Singapore
    Amministratore
    60 Chuan Garden
    FOREIGN Singapore
    558570
    Singapore
    Singaporean70088270001
    MCBRIDE, Stephen Paul
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    Amministratore
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    United KingdomBritish56953000002
    MCCABE, Kevin Charles
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    Amministratore
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    British109250000001
    PAIRMAN, Lynda Annette
    Ballagawne Cottage Ballagawne Road
    Colby
    IM9 4AZ Castletown
    Isle Of Man
    Amministratore
    Ballagawne Cottage Ballagawne Road
    Colby
    IM9 4AZ Castletown
    Isle Of Man
    British132910006
    QUEK, Stanley Swee Han, Dr
    24 Olive Road
    Singapore
    1129
    Amministratore
    24 Olive Road
    Singapore
    1129
    SingaporeSingaporean123800250001
    VAN REYK, Philip
    Cherry Tree House
    Chequers Lane
    RG27 0NT Eversley
    Hampshire
    Amministratore
    Cherry Tree House
    Chequers Lane
    RG27 0NT Eversley
    Hampshire
    EnglandBritish76943220003
    TYROLESE (DIRECTORS) LIMITED
    66 Lincoln's Inn Fields
    WC2A 3LH London
    Amministratore delegato nominato
    66 Lincoln's Inn Fields
    WC2A 3LH London
    900002470001
    TYROLESE (SECRETARIAL) LIMITED
    66 Lincoln's Inn Fields
    WC2A 3LH London
    Amministratore delegato nominato
    66 Lincoln's Inn Fields
    WC2A 3LH London
    900002460001

    FRASERS FB (PEPYS STREET) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 07 gen 2000
    Consegnato il 15 gen 2000
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The l/h property k/a 1 pepys street london t/n NGL767041. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 15 gen 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 07 gen 2000
    Consegnato il 15 gen 2000
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 15 gen 2000Registrazione di un'ipoteca (395)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0