OLYMPIA GROUP LIMITED

OLYMPIA GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàOLYMPIA GROUP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03764367
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di OLYMPIA GROUP LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova OLYMPIA GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Hill House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di OLYMPIA GROUP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    EARLS COURT & OLYMPIA GROUP LIMITED01 ott 199901 ott 1999
    HEXAGON 237 LIMITED04 mag 199904 mag 1999

    Quali sono gli ultimi bilanci di OLYMPIA GROUP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per OLYMPIA GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    13 pagineLIQ13

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato Olympia London Hammersmith Road Kensington London W14 8UX

    2 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Olympia London Hammersmith Road Kensington London W14 8UX England a Olympia London Hammersmith Road Kensington London W14 8UX

    2 pagineAD02

    Indirizzo della sede legale modificato da Olympia London Hammersmith Road Kensington London W14 8UX England a Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR in data 24 ott 2018

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 01 ott 2018

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    7 pagineLIQ01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 24 set 2018

    • Capitale: GBP 1.00
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Cessazione della carica di Yvonne Lillian Denyer come amministratore in data 10 set 2018

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Gavin Stuart Charles Neilan come amministratore in data 24 mag 2018

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Nigel Howard Nathan come amministratore in data 24 mag 2018

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Andrew Matthew Thorpe come amministratore in data 24 mag 2018

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 04 mag 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    I registri sono stati trasferiti all'indirizzo della sede legale registrata Olympia London Hammersmith Road Kensington London W14 8UX

    1 pagineAD04

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Gavin Stuart Charles Neilan il 30 ago 2017

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Andrew Matthew Thorpe il 30 ago 2017

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Lloyd Eng-Meng Lee il 30 ago 2017

    2 pagineCH01

    Nomina di Ms Yvonne Lillian Denyer come segretario in data 11 set 2017

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Jagdish Johal come segretario in data 11 set 2017

    1 pagineTM02

    Indirizzo della sede legale modificato da 4th Floor, 26-28 Mount Row London W1K 3SG United Kingdom a Olympia London Hammersmith Road Kensington London W14 8UX in data 30 ago 2017

    1 pagineAD01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato Olympia London Hammersmith Road Kensington London W14 8UX

    1 pagineAD03

    Chi sono gli amministratori di OLYMPIA GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    DENYER, Yvonne Lillian
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Segretario
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    238953230001
    LEE, Lloyd Eng-Meng
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Amministratore
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    United KingdomAmerican86610230004
    ROCCOGRANDE, Frank Charles
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Amministratore
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    United KingdomAmerican220664170001
    CONWAY, Simon Alexander Malcolm
    York Lodge
    High Wood Hill Mill
    NW7 4HA London
    Greater London
    Segretario
    York Lodge
    High Wood Hill Mill
    NW7 4HA London
    Greater London
    British88608520001
    FOLGER, Susan
    40 Broadway
    London
    SW1H 0BU
    Segretario
    40 Broadway
    London
    SW1H 0BU
    British68599110002
    JOHAL, Jagdish
    Mount Row
    W1K 3SG London
    4th Floor, 24-26
    United Kingdom
    Segretario
    Mount Row
    W1K 3SG London
    4th Floor, 24-26
    United Kingdom
    229032480001
    MCCAVENY, Leigh
    Grosvenor Street
    W1K 4QZ London
    15
    Segretario
    Grosvenor Street
    W1K 4QZ London
    15
    207687630001
    MORRIS, Jack Anthony
    2 Linnell Drive
    NW11 7LJ London
    Segretario
    2 Linnell Drive
    NW11 7LJ London
    British2460900001
    NEAL, Peter Richard
    Earls Court Exhibition Centre
    Warwick Road
    SW5 9TA London
    Segretario
    Earls Court Exhibition Centre
    Warwick Road
    SW5 9TA London
    British95289870001
    PAVEY, Ruth Elizabeth
    Grosvenor Street
    W1K 4QZ London
    15
    Segretario
    Grosvenor Street
    W1K 4QZ London
    15
    British151473460001
    PILCHER, Timothy James
    46 Caldervale Road
    Clapham
    SW4 9LZ London
    Segretario
    46 Caldervale Road
    Clapham
    SW4 9LZ London
    British72758230001
    HEXAGON REGISTRARS LIMITED
    Ten Dominion Street
    EC2M 2EE London
    Segretario nominato
    Ten Dominion Street
    EC2M 2EE London
    900013760001
    ARCULUS, Thomas David Guy
    Flat 193 County Hall North Block
    1a Belvedere Road
    SE1 7GH London
    Amministratore
    Flat 193 County Hall North Block
    1a Belvedere Road
    SE1 7GH London
    British80344070001
    BARTON, Robin Michael
    45 Sandrock Hill Road
    Wrecclesham
    GU10 4RJ Farnham
    Surrey
    Amministratore
    45 Sandrock Hill Road
    Wrecclesham
    GU10 4RJ Farnham
    Surrey
    United KingdomBritish110323990001
    BLACK, William Reginald
    Grosvenor Street
    W1K 4QZ London
    15
    Amministratore
    Grosvenor Street
    W1K 4QZ London
    15
    EnglandBritish41017610002
    CONWAY, Simon Alexander Malcolm
    York Lodge
    High Wood Hill Mill
    NW7 4HA London
    Greater London
    Amministratore
    York Lodge
    High Wood Hill Mill
    NW7 4HA London
    Greater London
    EnglandBritish88608520001
    DAS, Soumen
    Grosvenor Street
    W1K 4QZ London
    15
    Amministratore
    Grosvenor Street
    W1K 4QZ London
    15
    United KingdomBritish150962550001
    DENYER, Yvonne Lillian
    Hammersmith Road
    Kensington
    W14 8UX London
    Olympia London
    England
    Amministratore
    Hammersmith Road
    Kensington
    W14 8UX London
    Olympia London
    England
    United KingdomBritish102647680002
    DURANT, Ian Charles
    57 The Avenue
    Kew
    TW9 2AL Richmond
    Surrey
    Amministratore
    57 The Avenue
    Kew
    TW9 2AL Richmond
    Surrey
    United KingdomBritish150020002
    EDINGTON, George Gordon
    7 St Simons Avenue
    Putney
    SW15 6DU London
    Amministratore
    7 St Simons Avenue
    Putney
    SW15 6DU London
    United KingdomBritish1386790001
    FISCHEL, David Andrew
    40 Broadway
    London
    SW1H 0BU
    Amministratore
    40 Broadway
    London
    SW1H 0BU
    United KingdomBritish8845220002
    GOOLD, Jonathan Pearson
    13 Lillian Road
    Barnes
    SW13 9JG London
    Amministratore
    13 Lillian Road
    Barnes
    SW13 9JG London
    British79723100001
    HAWKSWORTH, Ian David
    Grosvenor Street
    W1K 4QZ London
    15
    Amministratore
    Grosvenor Street
    W1K 4QZ London
    15
    United KingdomBritish115713550001
    JOBANPUTRA, Situl Suryakant
    Grosvenor Street
    W1K 4QZ London
    15
    United Kingdom
    Amministratore
    Grosvenor Street
    W1K 4QZ London
    15
    United Kingdom
    United KingdomBritish220745230001
    KIMBLE, Simon Reed, Mr.
    125 Blythe Road
    W14 0HL London
    Amministratore
    125 Blythe Road
    W14 0HL London
    British76923040002
    KING, Suzanne Jane
    114 Ramillies Road
    W4 1JA London
    Amministratore
    114 Ramillies Road
    W4 1JA London
    United KingdomBritish87195220001
    LEEFE, Simon Neville Arden
    Cuckfield Road
    Ansty
    RH17 5AJ Haywards Heath
    West Riddens
    West Sussex
    Amministratore
    Cuckfield Road
    Ansty
    RH17 5AJ Haywards Heath
    West Riddens
    West Sussex
    United KingdomBritish136410560001
    LYONS, Anthony
    Bracknell Gardens
    NW3 7EE London
    25
    Amministratore
    Bracknell Gardens
    NW3 7EE London
    25
    United KingdomBritish117463490002
    MORRIS, Andrew Bernard
    5 Ruskin Close
    NW11 7AU London
    Amministratore
    5 Ruskin Close
    NW11 7AU London
    United KingdomBritish2464800001
    MORRIS, Jack Anthony
    2 Linnell Drive
    NW11 7LJ London
    Amministratore
    2 Linnell Drive
    NW11 7LJ London
    EnglandBritish2460900001
    NATHAN, Nigel Howard
    Hammersmith Road
    Kensington
    W14 8UX London
    Olympia London
    England
    Amministratore
    Hammersmith Road
    Kensington
    W14 8UX London
    Olympia London
    England
    United KingdomBritish66508820005
    NEILAN, Gavin Stuart Charles
    Hammersmith Road
    Kensington
    W14 8UX London
    Olympia London
    England
    Amministratore
    Hammersmith Road
    Kensington
    W14 8UX London
    Olympia London
    England
    United KingdomBritish220664190001
    PILCHER, Timothy James
    46 Caldervale Road
    Clapham
    SW4 9LZ London
    Amministratore
    46 Caldervale Road
    Clapham
    SW4 9LZ London
    British72758230001
    SELLINS, Jonathan Robert
    W13
    Amministratore
    W13
    United KingdomBritish108633180001
    SELLINS, Jonathan Robert
    W13
    Amministratore
    W13
    United KingdomBritish108633180001

    Chi sono le persone con controllo significativo di OLYMPIA GROUP LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Mount Row
    W1K 3SG London
    26-28
    England
    06 apr 2016
    Mount Row
    W1K 3SG London
    26-28
    England
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione05089859
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    OLYMPIA GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 20 apr 2017
    Consegnato il 25 apr 2017
    In corso
    Breve descrizione
    The mortgaged property being olympia exhibition halls, hammersmith road, london W14 8UX with title number BGL31510.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lgim Commercial Lending Limited, One Coleman Street, London, EC2R 5AA (As Security Agent)
    Transazioni
    • 25 apr 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 20 apr 2017
    Consegnato il 25 apr 2017
    In corso
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lgim Commercial Lending Limited, One Coleman Street, London, EC2R 5AA (As Security Agent and Secured Party)
    Transazioni
    • 25 apr 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 16 feb 2017
    Consegnato il 17 feb 2017
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    The properties owned by the chargor as specified (and defined) in the supplemental charge registered by this form MR01 ("supplemental charge") and including, amongst others, leasehold land being part of olympia way, hammersmith, london and registered at the land registry with title number BGL23331. For more details please refer to the supplemental charge.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Credit Agricole Corporate and Investment Bank as Security Trustee for the Secured Parties
    Transazioni
    • 17 feb 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 25 apr 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 19 dic 2016
    Consegnato il 23 dic 2016
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    By way of first legal mortgage, all freehold and leasehold property owned by the chargor, including (amongst others) the freehold land being olympia exhibition halls, hammersmith road, london (W14 8UX) and registered at the land registry under title number BGL31510 and the freehold land on the north west side of olympia way, kensington olympia, london and registered at the land registry under title number BGL15270, and including all buildings, fixtures, fittings and fixed plant and machinery on those properties. For more information, please see the debenture.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Credit Agricole Corporate and Investment Bank (As Security Trustee for the Secured Parties)
    Transazioni
    • 23 dic 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 25 apr 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 19 dic 2016
    Consegnato il 22 dic 2016
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Credit Agricole Corporate and Investment Bank (As Security Trustee for the Secured Parties)
    Transazioni
    • 22 dic 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 25 apr 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Share charge
    Creato il 24 dic 2009
    Consegnato il 12 gen 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The investments being ordinary shares in the issued capital of empress place limited see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation Limited
    Transazioni
    • 12 gen 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 14 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Charge over account
    Creato il 14 apr 2008
    Consegnato il 17 apr 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed charge all right title and interest in and to the account and the deposit see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC (Security Trustee)
    Transazioni
    • 17 apr 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 24 lug 2007
    Consegnato il 06 ago 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Capital and Counties Limited
    Transazioni
    • 06 ago 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 mar 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 01 feb 2006
    Consegnato il 20 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The property k/a 1. f/h olympia t/n BGL31510 2. l/h olympia way hammersmith road london t/no's BGL23329 BGL23330 BGL23331 3. l/h earls court exhibition buildings (earls COURT1) warwick road london t/n LN176409 for further details of property charged please refer to the form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 20 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 11 feb 2005
    Consegnato il 25 feb 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H olympia exhibition hall hammersmith road london t/n BGL31510 l/h olympia way hammersmith road london t/n bgl 3329 BGL23330 BGL23331 l/h earls court exhibition (earls court 1) warwick road london t/n LN176409 for further details of the properties charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries
    Transazioni
    • 25 feb 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 feb 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental legal charge which supplements the debenture dated 7 may 2004
    Creato il 11 feb 2005
    Consegnato il 23 feb 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H premises k/a olympia exhibition halls hammersmith road london t/no BGL31510 together with all buildings fixtures and fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nomura International PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries) (Thesecurity Agent)
    Transazioni
    • 23 feb 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 feb 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 07 mag 2004
    Consegnato il 11 mag 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from such chargor to each beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nomura International PLC (As Security Agent and Trustee for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 11 mag 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 feb 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over account
    Creato il 28 giu 2000
    Consegnato il 30 giu 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The actual, contingent, present and/or future obligations and liabilities of the chargor to any of the secured parties under or pursuant to any of the financing documents (including for the avoidance of doubt, the charge).
    Brevi particolari
    All the company's right title benefit and interest in and to the account including, without limitation, the balances standing to the credit of the charged account from time to time and at any time charged account being numbrer 1009702 in the name of the company held with credit suisse first boston 5 cabot square london designated ecog-poex/br disposal proceeds account. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Credit Suisse First Boston
    Transazioni
    • 30 giu 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 mag 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Keyman insurance assignment
    Creato il 22 dic 1999
    Consegnato il 29 dic 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The actual contingent present and/or future obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for the secured parties (as defined) (the "security trustee") under or pursuant to all or any of the financing documents (as defined)
    Brevi particolari
    The policies and the proceeds and the full benefit thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Credit Suisse First Boston
    Transazioni
    • 29 dic 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 mag 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 30 set 1999
    Consegnato il 13 ott 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The actual contingent present and/or future obligations and liabilities of the company formerly known as hexagon 237 limited to the chargee under or pursuant to any of the financing documents
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Credit Suisse First Boston as Agent and Trustee for the Secured Parties (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 13 ott 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 mag 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    OLYMPIA GROUP LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    01 ott 2018Inizio della liquidazione
    21 mag 2019Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Ian Harvey Dean
    1 New Street Square
    EC4A 3HQ London
    Praticante
    1 New Street Square
    EC4A 3HQ London
    Stephen Roland Browne
    1 New Street Square
    EC4A 3HQ London
    Praticante
    1 New Street Square
    EC4A 3HQ London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0