CLAYDON HOUSE LIMITED

CLAYDON HOUSE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCLAYDON HOUSE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03765160
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CLAYDON HOUSE LIMITED?

    • Strutture residenziali di assistenza infermieristica (87100) / Attività sanitarie e di assistenza sociale

    Dove si trova CLAYDON HOUSE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Asticus Building 2nd Floor
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CLAYDON HOUSE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SPEED 7731 LIMITED05 mag 199905 mag 1999

    Quali sono gli ultimi bilanci di CLAYDON HOUSE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per CLAYDON HOUSE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    2 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 mag 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    2 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 mag 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    2 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 05 mag 2016 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital31 mag 2016

    Stato del capitale al 31 mag 2016

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Dettagli del segretario cambiati per Sanne Group Secretaries (Uk) Limited il 20 lug 2015

    1 pagineCH04

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    2 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Sanne Group 2nd Floor Pollen House 10 Cork Street London W1S 3NP a Asticus Building 2nd Floor 21 Palmer Street London SW1H 0AD in data 05 ago 2015

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 05 mag 2015 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital27 mag 2015

    Stato del capitale al 27 mag 2015

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Nomina di Jonathan David Farkas come amministratore in data 27 gen 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Mathieu Streiff come amministratore in data 27 gen 2015

    1 pagineTM01

    legacy

    28 paginePARENT_ACC

    legacy

    3 pagineGUARANTEE1

    legacy

    1 pagineAGREEMENT1

    Bilancio annuale redatto al 05 mag 2014 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital03 giu 2014

    Stato del capitale al 03 giu 2014

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Dettagli del segretario cambiati per Sanne Group Secretaries Uk Limited il 31 mar 2014

    1 pagineCH04

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Mathieu Streiff il 31 mar 2014

    2 pagineCH01

    Indirizzo della sede legale modificato da * C/O Sanne Group 1 Berkeley Street London United Kingdom W1J 8DJ* in data 08 apr 2014

    1 pagineAD01

    Dimissioni di un revisore

    2 pagineAA03

    Esercizio contabile in corso abbreviato dal 31 mar 2014 al 31 dic 2013

    3 pagineAA01

    Bilancio redatto al 31 mar 2013

    15 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di CLAYDON HOUSE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SANNE GROUP SECRETARIES (UK) LIMITED
    Palmer Street
    SW1H 0AD London
    21
    England
    Segretario
    Palmer Street
    SW1H 0AD London
    21
    England
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione8334728
    175738460001
    FARKAS, Jonathan David
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building 2nd Floor
    Amministratore
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building 2nd Floor
    LuxembourgAmerican193539990001
    GRIFFIN, Craig
    Halebourne House
    Halebourne Lane
    GU24 8SL Chobham
    Surrey
    Segretario
    Halebourne House
    Halebourne Lane
    GU24 8SL Chobham
    Surrey
    British154122490001
    SCHOFIELD, Nigel Bennett
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    Segretario
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    British52338530002
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Segretario nominato
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    CORMACK, Derek George
    Pillars
    Grantley Avenue, Wonersh
    GU5 0QN Guildford
    Surrey
    Amministratore
    Pillars
    Grantley Avenue, Wonersh
    GU5 0QN Guildford
    Surrey
    EnglandIrish67400530015
    GRIFFIN, Craig
    Halebourne House
    Halebourne Lane
    GU24 8SL Chobham
    Surrey
    Amministratore
    Halebourne House
    Halebourne Lane
    GU24 8SL Chobham
    Surrey
    United KingdomBritish154122490001
    HILL, Peter Martin
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    Amministratore
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    EnglandBritish130983750002
    JEFFERY, Paul Anthony Keith
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    Amministratore
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    United KingdomBritish65609290003
    SCHOFIELD, Nigel Bennett
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    Amministratore
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    United KingdomBritish148139420001
    STREIFF, Mathieu Bernard
    Pollen House
    10 Cork Street
    W1S 3NP London
    2nd Floor
    Amministratore
    Pollen House
    10 Cork Street
    W1S 3NP London
    2nd Floor
    United StatesAmerican200529310001
    WHITE, Ian James
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    Amministratore
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    EnglandBritish133383410003
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Amministratore delegato nominato
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001

    Chi sono le persone con controllo significativo di CLAYDON HOUSE LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building
    England
    06 apr 2016
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleThe Companies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione04258255
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    CLAYDON HOUSE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 28 lug 2010
    Consegnato il 06 ago 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each chargor to the chargee and to all or any of the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details. For details of property charged please refer to form MG01.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC (As Security Agent)
    Transazioni
    • 06 ago 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 18 set 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 16 nov 2007
    Consegnato il 27 nov 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargors to the chargee for the secured finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Ascot house 28 wingrove road fenham,34 and 36 wingrove road newcastle upon tynet/no's TY221509 and TY52154,bradbury house bradbury house new street braintree t/no ESX647090, cheshire house 22 st mary's road ashton on mersey t/no GM54543 (for details of further properties charged. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 27 nov 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 set 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 28 ott 2005
    Consegnato il 03 nov 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All land in england and wales now vested in the chargor, all interests and rights in or relating to land or the proceeds of sale, all plant and machinery, all rental and other income. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee
    Transazioni
    • 03 nov 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 set 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 28 ott 2003
    Consegnato il 31 ott 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property known as claydon house 8 wallands crescent lewes east sussex BN7 2QT t/n ESX57608. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 31 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 set 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 28 ott 2003
    Consegnato il 31 ott 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 31 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 set 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 21 dic 1999
    Consegnato il 07 gen 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The freehold property known as land & buildings claydon house 8 wallands cresent lewes east sussex.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 07 gen 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 ott 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 08 dic 1999
    Consegnato il 15 dic 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 15 dic 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 ott 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0