TRIBAL RESOURCING LIMITED
Panoramica
Nome della società | TRIBAL RESOURCING LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 03765435 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di TRIBAL RESOURCING LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova TRIBAL RESOURCING LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Kings Orchard Queen Street St. Philips BS2 0HQ Bristol |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di TRIBAL RESOURCING LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
TRIBAL GWT GROUP LIMITED | 13 nov 2002 | 13 nov 2002 |
GWT GROUP LIMITED | 15 ago 2000 | 15 ago 2000 |
GREGORY WOOD TOWNES LIMITED | 17 mag 1999 | 17 mag 1999 |
ELLERBAY LIMITED | 06 mag 1999 | 06 mag 1999 |
Quali sono gli ultimi bilanci di TRIBAL RESOURCING LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2016 |
Quali sono le ultime deposizioni per TRIBAL RESOURCING LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2016 | 15 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 06 mag 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2015 | 16 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Mark Pickett come amministratore in data 18 lug 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Stephen Derrick Breach come amministratore in data 18 lug 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 06 mag 2016 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Mr Ian James Bowles come amministratore in data 01 mar 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Robert Charles Garner come amministratore in data 01 mar 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Keith Martin Evans come amministratore in data 30 giu 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Robert Charles Garner come amministratore in data 01 lug 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 06 mag 2015 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2014 | 12 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Stephen Derrick Breach il 05 giu 2014 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 1-4 Portland Square Bristol BS2 8RR a Kings Orchard Queen Street St. Philips Bristol BS2 0HQ in data 04 ago 2014 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 06 mag 2014 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2013 | 13 pagine | AA | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 3 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 4 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 2 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 6 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 5 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2012 | 16 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di TRIBAL RESOURCING LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOWLES, Ian James | Amministratore | Queen Street St. Philips BS2 0HQ Bristol Kings Orchard | United Kingdom | British | Director | 206100790001 | ||||
PICKETT, Mark Jeremy | Amministratore | Queen Street St. Philips BS2 0HQ Bristol Kings Orchard | England | British | Finance Director | 210493320001 | ||||
COLLINS, Richard Hawke | Segretario | 87-91 Newman Street London W1T 3EY | British | 53398040001 | ||||||
DAVID, Andrew Leslie | Segretario | 23 Stonehaven Amington B77 3QX Tamworth Staffordshire | British | 65356430001 | ||||||
DAVIS, Lorraine Anne | Segretario | 87-91 Newman Street London W1T 3EY | 150940270001 | |||||||
DWYER, Daniel John | Segretario nominato | 6 Brimstone Close Chelsfield Park BR6 7ST Chelsfield Kent | British | 900003970001 | ||||||
LAWTON, Simon Marcus | Segretario | Long Ash Woodbridge Lane Withington GL54 4BP Cheltenham Gloucestershire | British | Director | 68807890004 | |||||
WALTERS, Christopher | Segretario | 1 Farthing Court 60 Graham Street B1 3JR Birmingham West Midlands | British | Company Director | 78317350001 | |||||
BREACH, Stephen Derrick | Amministratore | Queen Street St. Philips BS2 0HQ Bristol Kings Orchard England | England | British | Finance Director | 174695940001 | ||||
DOYLE, Betty June | Amministratore delegato nominato | 8 The Bartons Elstree Hill North WD6 3EN Elstree Herts | British | 900003960001 | ||||||
DWYER, Daniel John | Amministratore delegato nominato | 6 Brimstone Close Chelsfield Park BR6 7ST Chelsfield Kent | British | 900003970001 | ||||||
EVANS, Keith Martin, Dr | Amministratore | Queen Street St. Philips BS2 0HQ Bristol Kings Orchard England | England | British | Director | 83582830002 | ||||
GARNER, Robert Charles | Amministratore | Queen Street St. Philips BS2 0HQ Bristol Kings Orchard | United Kingdom | British | Company Director | 53391420003 | ||||
GREGORY, David John | Amministratore | Wood Farm Pledgdon Green Henham CM22 6BN Bishops Stortford Hertfordshire | British | Company Director | 2599880001 | |||||
HALL, John Lezlie | Amministratore | 26 Greenfield Avenue Balsall Common CV7 7UG Coventry West Midlands | British | Accountant | 65356200001 | |||||
LAWTON, Simon Marcus | Amministratore | 87-91 Newman Street London W1T 3EY | England | British | Director | 68807890004 | ||||
MARTIN, Peter John | Amministratore | 87-91 Newman Street London W1T 3EY | England | British | Director | 176044430001 | ||||
PITMAN, Henry John | Amministratore | Pinbury Park Duntisbourne Rouse GL7 7LG Cirencester Gloucestershire | United Kingdom | British | Director | 55231490005 | ||||
STANTON, Jeffrey Peter | Amministratore | 70 Doctors Lane Shenstone WS14 0NT Lichfield Staffordshire | British | Company Director | 65404350001 | |||||
THOMAS, Clive Raymond | Amministratore | 16 Quat Goose Lane Swindon Village GL51 9RX Cheltenham Gloucestershire | England | British | Accountant | 109062350001 | ||||
TOWERS, Julie Ann | Amministratore | Wollaton Street NG1 5FW Nottingham The Atrium United Kingdom | England | English | Director | 39994300001 | ||||
TOWNES, Robert Gilson | Amministratore | 1 Barnetts Grove DY10 3HG Kidderminster Worcestershire | British | Company Director | 65404250001 | |||||
WALTERS, Christopher | Amministratore | 1 Farthing Court 60 Graham Street B1 3JR Birmingham West Midlands | British | Company Director | 78317350001 | |||||
WARD, Stephen Joseph | Amministratore | 56 Chesterton Close B97 5XS Redditch Worcestershire | England | British | Company Director | 65404390001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di TRIBAL RESOURCING LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tribal Group Plc | 01 dic 2016 | Queen Street St. Philips BS2 0HQ Bristol Kings Orchard England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
TRIBAL RESOURCING LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Guarantee & debenture | Creato il 14 giu 2007 Consegnato il 21 giu 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each group company to the chargee and the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Guarantee and debenture made between certain subsidiaries of tribal group PLC and the governor and company of the bank of scotland | Creato il 13 dic 2002 Consegnato il 24 dic 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All present and future obligations and liabilities of each group company to the security trustee and the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Guarantee and debenture | Creato il 17 ott 2002 Consegnato il 23 ott 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 24 apr 2002 Consegnato il 30 apr 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each company to the chargee and the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 17 ago 2001 Consegnato il 21 ago 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 13 ago 1999 Consegnato il 26 ago 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0