TRIBAL RESOURCING LIMITED

TRIBAL RESOURCING LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTRIBAL RESOURCING LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03765435
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TRIBAL RESOURCING LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova TRIBAL RESOURCING LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Kings Orchard Queen Street
    St. Philips
    BS2 0HQ Bristol
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TRIBAL RESOURCING LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    TRIBAL GWT GROUP LIMITED13 nov 200213 nov 2002
    GWT GROUP LIMITED15 ago 200015 ago 2000
    GREGORY WOOD TOWNES LIMITED17 mag 199917 mag 1999
    ELLERBAY LIMITED06 mag 199906 mag 1999

    Quali sono gli ultimi bilanci di TRIBAL RESOURCING LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per TRIBAL RESOURCING LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01
    A6LKL0WP

    Bilancio redatto al 31 dic 2016

    15 pagineAA
    A6A3KZYB

    Dichiarazione di conformità presentata il 06 mag 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01
    X66L8DSR

    Bilancio redatto al 31 dic 2015

    16 pagineAA
    A5C9TNJL

    Nomina di Mr Mark Pickett come amministratore in data 18 lug 2016

    2 pagineAP01
    X5BL3NPE

    Cessazione della carica di Stephen Derrick Breach come amministratore in data 18 lug 2016

    1 pagineTM01
    X5BL3N09

    Bilancio annuale redatto al 06 mag 2016 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital17 mag 2016

    Stato del capitale al 17 mag 2016

    • Capitale: GBP 10,577
    SH01
    X575H3OB

    Nomina di Mr Ian James Bowles come amministratore in data 01 mar 2016

    2 pagineAP01
    X52S3OZ5

    Cessazione della carica di Robert Charles Garner come amministratore in data 01 mar 2016

    1 pagineTM01
    X52S3OKJ

    Cessazione della carica di Keith Martin Evans come amministratore in data 30 giu 2015

    1 pagineTM01
    X4AVX05E

    Nomina di Mr Robert Charles Garner come amministratore in data 01 lug 2015

    2 pagineAP01
    X4AVX0BI

    Bilancio annuale redatto al 06 mag 2015 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital26 mag 2015

    Stato del capitale al 26 mag 2015

    • Capitale: GBP 10,577
    SH01
    X487B0P5

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    12 pagineAA
    A46ES7UA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Stephen Derrick Breach il 05 giu 2014

    2 pagineCH01
    X3DJSALE

    Indirizzo della sede legale modificato da 1-4 Portland Square Bristol BS2 8RR a Kings Orchard Queen Street St. Philips Bristol BS2 0HQ in data 04 ago 2014

    1 pagineAD01
    X3DJSADN

    Bilancio annuale redatto al 06 mag 2014 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital17 giu 2014

    Stato del capitale al 17 giu 2014

    • Capitale: GBP 10,577
    SH01
    X3A8BAUO

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    13 pagineAA
    A370N99D

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    4 pagineMR04
    A32YT1IY

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    4 pagineMR04
    A32YT1J7

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    4 pagineMR04
    A32YT1IQ

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    4 pagineMR04
    A32YT1JN

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    4 pagineMR04
    A32YT1JF

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    16 pagineAA
    A2DIAXA9

    Chi sono gli amministratori di TRIBAL RESOURCING LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BOWLES, Ian James
    Queen Street
    St. Philips
    BS2 0HQ Bristol
    Kings Orchard
    Amministratore
    Queen Street
    St. Philips
    BS2 0HQ Bristol
    Kings Orchard
    United KingdomBritishDirector206100790001
    PICKETT, Mark Jeremy
    Queen Street
    St. Philips
    BS2 0HQ Bristol
    Kings Orchard
    Amministratore
    Queen Street
    St. Philips
    BS2 0HQ Bristol
    Kings Orchard
    EnglandBritishFinance Director210493320001
    COLLINS, Richard Hawke
    87-91 Newman Street
    London
    W1T 3EY
    Segretario
    87-91 Newman Street
    London
    W1T 3EY
    British53398040001
    DAVID, Andrew Leslie
    23 Stonehaven
    Amington
    B77 3QX Tamworth
    Staffordshire
    Segretario
    23 Stonehaven
    Amington
    B77 3QX Tamworth
    Staffordshire
    British65356430001
    DAVIS, Lorraine Anne
    87-91 Newman Street
    London
    W1T 3EY
    Segretario
    87-91 Newman Street
    London
    W1T 3EY
    150940270001
    DWYER, Daniel John
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    Segretario nominato
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    British900003970001
    LAWTON, Simon Marcus
    Long Ash
    Woodbridge Lane Withington
    GL54 4BP Cheltenham
    Gloucestershire
    Segretario
    Long Ash
    Woodbridge Lane Withington
    GL54 4BP Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishDirector68807890004
    WALTERS, Christopher
    1 Farthing Court
    60 Graham Street
    B1 3JR Birmingham
    West Midlands
    Segretario
    1 Farthing Court
    60 Graham Street
    B1 3JR Birmingham
    West Midlands
    BritishCompany Director78317350001
    BREACH, Stephen Derrick
    Queen Street
    St. Philips
    BS2 0HQ Bristol
    Kings Orchard
    England
    Amministratore
    Queen Street
    St. Philips
    BS2 0HQ Bristol
    Kings Orchard
    England
    EnglandBritishFinance Director174695940001
    DOYLE, Betty June
    8 The Bartons
    Elstree Hill North
    WD6 3EN Elstree
    Herts
    Amministratore delegato nominato
    8 The Bartons
    Elstree Hill North
    WD6 3EN Elstree
    Herts
    British900003960001
    DWYER, Daniel John
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    Amministratore delegato nominato
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    British900003970001
    EVANS, Keith Martin, Dr
    Queen Street
    St. Philips
    BS2 0HQ Bristol
    Kings Orchard
    England
    Amministratore
    Queen Street
    St. Philips
    BS2 0HQ Bristol
    Kings Orchard
    England
    EnglandBritishDirector83582830002
    GARNER, Robert Charles
    Queen Street
    St. Philips
    BS2 0HQ Bristol
    Kings Orchard
    Amministratore
    Queen Street
    St. Philips
    BS2 0HQ Bristol
    Kings Orchard
    United KingdomBritishCompany Director53391420003
    GREGORY, David John
    Wood Farm Pledgdon Green
    Henham
    CM22 6BN Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Amministratore
    Wood Farm Pledgdon Green
    Henham
    CM22 6BN Bishops Stortford
    Hertfordshire
    BritishCompany Director2599880001
    HALL, John Lezlie
    26 Greenfield Avenue
    Balsall Common
    CV7 7UG Coventry
    West Midlands
    Amministratore
    26 Greenfield Avenue
    Balsall Common
    CV7 7UG Coventry
    West Midlands
    BritishAccountant65356200001
    LAWTON, Simon Marcus
    87-91 Newman Street
    London
    W1T 3EY
    Amministratore
    87-91 Newman Street
    London
    W1T 3EY
    EnglandBritishDirector68807890004
    MARTIN, Peter John
    87-91 Newman Street
    London
    W1T 3EY
    Amministratore
    87-91 Newman Street
    London
    W1T 3EY
    EnglandBritishDirector176044430001
    PITMAN, Henry John
    Pinbury Park
    Duntisbourne Rouse
    GL7 7LG Cirencester
    Gloucestershire
    Amministratore
    Pinbury Park
    Duntisbourne Rouse
    GL7 7LG Cirencester
    Gloucestershire
    United KingdomBritishDirector55231490005
    STANTON, Jeffrey Peter
    70 Doctors Lane
    Shenstone
    WS14 0NT Lichfield
    Staffordshire
    Amministratore
    70 Doctors Lane
    Shenstone
    WS14 0NT Lichfield
    Staffordshire
    BritishCompany Director65404350001
    THOMAS, Clive Raymond
    16 Quat Goose Lane
    Swindon Village
    GL51 9RX Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    16 Quat Goose Lane
    Swindon Village
    GL51 9RX Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritishAccountant109062350001
    TOWERS, Julie Ann
    Wollaton Street
    NG1 5FW Nottingham
    The Atrium
    United Kingdom
    Amministratore
    Wollaton Street
    NG1 5FW Nottingham
    The Atrium
    United Kingdom
    EnglandEnglishDirector39994300001
    TOWNES, Robert Gilson
    1 Barnetts Grove
    DY10 3HG Kidderminster
    Worcestershire
    Amministratore
    1 Barnetts Grove
    DY10 3HG Kidderminster
    Worcestershire
    BritishCompany Director65404250001
    WALTERS, Christopher
    1 Farthing Court
    60 Graham Street
    B1 3JR Birmingham
    West Midlands
    Amministratore
    1 Farthing Court
    60 Graham Street
    B1 3JR Birmingham
    West Midlands
    BritishCompany Director78317350001
    WARD, Stephen Joseph
    56 Chesterton Close
    B97 5XS Redditch
    Worcestershire
    Amministratore
    56 Chesterton Close
    B97 5XS Redditch
    Worcestershire
    EnglandBritishCompany Director65404390001

    Chi sono le persone con controllo significativo di TRIBAL RESOURCING LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Queen Street
    St. Philips
    BS2 0HQ Bristol
    Kings Orchard
    England
    01 dic 2016
    Queen Street
    St. Philips
    BS2 0HQ Bristol
    Kings Orchard
    England
    No
    Forma giuridicaPlc
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione04128850
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    TRIBAL RESOURCING LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Guarantee & debenture
    Creato il 14 giu 2007
    Consegnato il 21 giu 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each group company to the chargee and the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 21 giu 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 mar 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Guarantee and debenture made between certain subsidiaries of tribal group PLC and the governor and company of the bank of scotland
    Creato il 13 dic 2002
    Consegnato il 24 dic 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities of each group company to the security trustee and the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland Acting as Security Trustee for Itself and Thefinance Parties
    Transazioni
    • 24 dic 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 mar 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Guarantee and debenture
    Creato il 17 ott 2002
    Consegnato il 23 ott 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 23 ott 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 mar 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 24 apr 2002
    Consegnato il 30 apr 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each company to the chargee and the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for Each of the Financeparties (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 30 apr 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 mar 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 17 ago 2001
    Consegnato il 21 ago 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 21 ago 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 mar 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 13 ago 1999
    Consegnato il 26 ago 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 26 ago 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 apr 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0