BNY MELLON CAPITAL MARKETS EMEA LIMITED

BNY MELLON CAPITAL MARKETS EMEA LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBNY MELLON CAPITAL MARKETS EMEA LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03766757
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BNY MELLON CAPITAL MARKETS EMEA LIMITED?

    • Intermediazione finanziaria non classificata altrove (64999) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova BNY MELLON CAPITAL MARKETS EMEA LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BNY MELLON CAPITAL MARKETS EMEA LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BNY MELLON SERVICES LIMITED01 feb 200801 feb 2008
    BNY SECURITIES LIMITED25 gen 200225 gen 2002
    BNY CLEARING SERVICES INTERNATIONAL LIMITED01 ago 200001 ago 2000
    BHF SECURITIES INTERNATIONAL LIMITED04 giu 199904 giu 1999
    FLATWALL LIMITED07 mag 199907 mag 1999

    Quali sono gli ultimi bilanci di BNY MELLON CAPITAL MARKETS EMEA LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per BNY MELLON CAPITAL MARKETS EMEA LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    9 pagineLIQ13

    Indirizzo della sede legale modificato da One Canada Square London E14 5AL a 25 Farringdon Street London EC4A 4AB in data 15 giu 2020

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 26 mag 2020

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    6 pagineLIQ01

    Dichiarazione di conformità presentata il 07 mag 2020 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Stato del capitale al 13 mar 2020

    • Capitale: GBP 1
    • Capitale: USD 1
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    6 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    6 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    8 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    11 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    5 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 037667570008 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    6 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 1 in pieno

    11 pagineMR04

    Nomina di Mr John Charles Tisdall come amministratore in data 06 lug 2017

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di John Charles Tisdall come amministratore in data 11 ott 2019

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 07 mag 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2018

    43 pagineAA

    Cessazione della carica di James Alexander Edwards come amministratore in data 23 mag 2018

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2017

    38 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di BNY MELLON CAPITAL MARKETS EMEA LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BNY MELLON SECRETARIES (UK) LIMITED
    Queen Victoria Street
    EC4V 4LA London
    160
    United Kingdom
    Segretario
    Queen Victoria Street
    EC4V 4LA London
    160
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione04115131
    73421460005
    SAVCHUK, Robin Culver
    Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    25
    Amministratore
    Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    25
    EnglandCanadian180477490001
    TISDALL, John Charles
    Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    25
    Amministratore
    Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    25
    EnglandSouth African263751560001
    WATKINS, Daniel Edward
    Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    25
    Amministratore
    Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    25
    United KingdomBritish235181080001
    BATESON, Anne Rosalind
    High Trees
    Great Holland
    CO13 0HZ Frinton On Sea
    Essex
    Segretario nominato
    High Trees
    Great Holland
    CO13 0HZ Frinton On Sea
    Essex
    British900007490001
    CHOU WO, Patrick
    1996 East 28th Street
    Brooklyn
    New York 11229
    Usa
    Segretario
    1996 East 28th Street
    Brooklyn
    New York 11229
    Usa
    American65094730001
    BERNTSEN, Torry
    22 Linden Lane
    Chatham
    FOREIGN New Jersey Nj 07928
    Usa
    Amministratore
    22 Linden Lane
    Chatham
    FOREIGN New Jersey Nj 07928
    Usa
    United StatesAmerican50100800001
    CAMERON, Angus Kenneth
    1 Canada Square
    E14 5AL London
    Amministratore
    1 Canada Square
    E14 5AL London
    British116129240001
    CHOU WO, Patrick
    1996 East 28th Street
    Brooklyn
    New York 11229
    Usa
    Amministratore
    1996 East 28th Street
    Brooklyn
    New York 11229
    Usa
    American65094730001
    COLEMAN, Nicholas Charles
    Ashdown House East
    Tanyard Lane
    RH17 7JW Danehill
    East Sussex
    Amministratore
    Ashdown House East
    Tanyard Lane
    RH17 7JW Danehill
    East Sussex
    EnglandBritish191831630001
    COMPSON, Douglas William
    7 Downside
    10 St Johns Avenue Putney
    SW15 2AE London
    Amministratore
    7 Downside
    10 St Johns Avenue Putney
    SW15 2AE London
    British92490850002
    EDWARDS, James Alexander
    One Canada Square
    London
    E14 5AL
    Amministratore
    One Canada Square
    London
    E14 5AL
    EnglandBritish164607520001
    FITZPATRICK, Vincent John
    302 Rocky Top Road,
    FOREIGN Morganville
    New Jersey 07751
    United States
    Amministratore
    302 Rocky Top Road,
    FOREIGN Morganville
    New Jersey 07751
    United States
    Us Citizen105094450001
    GASS, Ian Christopher
    One Canada Square
    London
    E14 5AL
    Amministratore
    One Canada Square
    London
    E14 5AL
    United KingdomBritish174643660001
    GILL, Richard John
    One Canada Square
    London
    E14 5AL
    Amministratore
    One Canada Square
    London
    E14 5AL
    United KingdomBritish252911660001
    GRANA, Michael
    15 Rambling Brook Drive
    Holmdel
    Nj 07733
    Usa
    Amministratore
    15 Rambling Brook Drive
    Holmdel
    Nj 07733
    Usa
    American65526350001
    JOHNSTON, John Meikle
    One Canada Square
    London
    E14 5AL
    Amministratore
    One Canada Square
    London
    E14 5AL
    EnglandBritish116070740001
    JOHNSTONE, Alexander George
    Marmion Road
    SW11 5PD London
    15a
    Amministratore
    Marmion Road
    SW11 5PD London
    15a
    British107679870001
    JONES, Gareth Richard
    Garden Flat
    75 Oxford Gardens
    W10 5UL London
    Amministratore
    Garden Flat
    75 Oxford Gardens
    W10 5UL London
    British95819670001
    JONES, Stephen Anthony
    10 Folly Avenue
    AL3 5QD St Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    10 Folly Avenue
    AL3 5QD St Albans
    Hertfordshire
    EnglandBritish71457180001
    KEANEY, Timothy Francis
    2 Wetherby Gardens
    SW5 0JN London
    Amministratore
    2 Wetherby Gardens
    SW5 0JN London
    United KingdomUnited States93962140002
    KERR, William Abercrombie
    One Canada Square
    London
    E14 5AL
    Amministratore
    One Canada Square
    London
    E14 5AL
    EnglandBritish125919810001
    LAI, Poh Lim
    24 Redwood Drive
    LU7 0TA Wing
    Buckinghamshire
    Amministratore delegato nominato
    24 Redwood Drive
    LU7 0TA Wing
    Buckinghamshire
    British900007480001
    LASALLA, Francis Joseph
    1170 Bridge Pointe Lane
    Yorktown Heights
    FOREIGN New York 10598
    Usa
    Amministratore
    1170 Bridge Pointe Lane
    Yorktown Heights
    FOREIGN New York 10598
    Usa
    American65094510001
    LAX, Craig Steven
    425 West End Avenue
    Apartment Pha
    New York
    100024
    United States
    Amministratore
    425 West End Avenue
    Apartment Pha
    New York
    100024
    United States
    American108583790001
    MANUELE, Lisa Ann
    124 Todd Lane
    Briarcliff
    10510 New York
    United States Of America
    Amministratore
    124 Todd Lane
    Briarcliff
    10510 New York
    United States Of America
    American96386590001
    MASTRANGELO, Ralph Michael
    781 Highwoods Drive
    FOREIGN Franklin Lakes
    New Jersey Nj 07417
    United States Of America
    Amministratore
    781 Highwoods Drive
    FOREIGN Franklin Lakes
    New Jersey Nj 07417
    United States Of America
    United States87461580001
    MCELENEY, James C
    One Canada Square
    London
    E14 5AL
    Amministratore
    One Canada Square
    London
    E14 5AL
    United KingdomUs Citizen167461590001
    MESERVE, John Donald
    56 Thomas Street
    4th Floor
    New York
    10013
    United States Of America
    Amministratore
    56 Thomas Street
    4th Floor
    New York
    10013
    United States Of America
    American96226400001
    MILITELLO, Mark Stephen
    One Canada Square
    London
    E14 5AL
    Amministratore
    One Canada Square
    London
    E14 5AL
    Hong KongBritish186920540001
    MOSE, Christopher
    One Canada Square
    London
    E14 5AL
    Amministratore
    One Canada Square
    London
    E14 5AL
    United StatesUs Citizen175134480001
    PACILIO, Vincent Louis
    Flat 1
    89 Holland Park
    W11 3RZ London
    Amministratore
    Flat 1
    89 Holland Park
    W11 3RZ London
    Us Citizen85259220001
    PACK, Carey Steven
    15 Troy Lane
    FOREIGN Short Hills
    New Jersey 07078
    United States Of America
    Amministratore
    15 Troy Lane
    FOREIGN Short Hills
    New Jersey 07078
    United States Of America
    American126374230001
    RAPPOLD, Charles Edward
    1050 Rahway Road
    FOREIGN Plainfield
    New Jersey 07060
    United States Of America
    Amministratore
    1050 Rahway Road
    FOREIGN Plainfield
    New Jersey 07060
    United States Of America
    American94138990001
    ROGAN, Brian Gerard
    9 Plum Beach Point Road
    Sands Point
    New York
    Ny 11050
    Usa
    Amministratore
    9 Plum Beach Point Road
    Sands Point
    New York
    Ny 11050
    Usa
    American86277620001

    Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per BNY MELLON CAPITAL MARKETS EMEA LIMITED?

    Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
    Notificato ilCessato ilDichiarazione
    07 mag 2017La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società.

    BNY MELLON CAPITAL MARKETS EMEA LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 16 ott 2013
    Consegnato il 22 ott 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Bank of New York Mellon
    Transazioni
    • 22 ott 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 10 mar 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A security agreement
    Creato il 05 feb 2003
    Consegnato il 11 feb 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All personal property and fixtures of the company or in which the company has an interest wherever located and whether now or hereafter existing or now owned or hereafter acquired and whether or nor subject to the uniform commercial code as in effect in the state of new york and also including all interest dividends and other distributions thereon paid and payable in cash or I property and all replacements and substitutions for and all accessions and additions to and all products and proceeds of all the foregoing.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Bank of New York
    Transazioni
    • 11 feb 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 mar 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A security agreement
    Creato il 05 feb 2003
    Consegnato il 11 feb 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All personal property and fixtures of the company or in which the company has an interest wherever located and whether now or hereafter existing or now owned or hereafter exisiting or now owned or hereafter acquired and whether or not subject to the uniform commercial code as in effect in the state of new york;. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Bank of New York
    Transazioni
    • 11 feb 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 mar 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Security deed
    Creato il 15 gen 2003
    Consegnato il 05 feb 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed charge over all sums and payments receivable by or for the account of the company by reason or in respect of any transfer or debit,stock from any stock account; all other rights and sums standing to the credit of the controlled accounts and all interest thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Citibank Na
    Transazioni
    • 05 feb 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 mar 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Supplement
    Creato il 15 gen 2003
    Consegnato il 05 feb 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    First priority fixed right over all rights in respect of transactions cleared and all other rights in respect of certain cash accounts of the company with the bank; all sums receivable or agreement to transfer or debit,securities from any account. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Citibank,N.A.and Citibank International PLC
    Transazioni
    • 05 feb 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 mar 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Collateral agreement governing secured borrowings by participants in the euroclear system
    Creato il 20 ago 2001
    Consegnato il 24 ago 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All amounts due or to become due from the company to the chargee referred to in section 2 of the collateral agreement being all borrowings (as defined) and other obligations in whatever form that relate t oor result from the company'' use of the euroclear system now outstanding or which may be outstanding at any time in the future to the chargee and to any other office of the chargee
    Brevi particolari
    All "collateral". See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Euroclear Bank N.V./S.A.
    Transazioni
    • 24 ago 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 mar 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A supplement to a main clearing agreement
    Creato il 22 feb 2001
    Consegnato il 02 mar 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to citibank international PLC and/or citibank, N.a pursuant to or in connection with (a) a master clearing agreement between the company and the bank (b) a tri-partite agreement between the company, cip and the london clearing house (c) the supplement (d) the crest settlement arrangements made between the company, cip or the bank (e) the rules of crest, the london stock exchange and the london clearing house in connection with the service (f) the bank's or cip's obligations to the london clearing house in connection with the service (g) any transactions effected by the company from time to time pursuant to the service (all terms as defined)
    Brevi particolari
    The company granted a security interest by way of first priority fixed right of security over (a) all rights it has or may now or in the future have against cip in respect of transactions cleared or to be cleared by cip for the company (b) all rights it has or may have now or in the future in respect of certain cash accounts of the company with the bank (all terms as defined). See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Citibank, N.a and Citibank International PLC
    Transazioni
    • 02 mar 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 mar 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Security deed
    Creato il 22 feb 2001
    Consegnato il 02 mar 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or any group company to the chargee under the facility agreement and/or the security deed or the making of any assured payment by the bank for the account of the company; or any transfer of stock to the company by means of crest; or any transfer of stock to the company by means of crest, whether the company is acting for itself or on behalf of a system-beneficiary (all terms as defined)
    Brevi particolari
    By way of fixed charge all sums and payments at the date of the security deed and from time to time thereafter receivable by or for the account of the company by reason or in respect of any transfer or debit of, or agreement to transfer or debit, stock from any (eligible) stock account of or in the name of or otherwise referable to the company in crest or of any transfer by the company of its right title, or interest to or in stock represented or to be represented by any credit balance for the time being on any such stock account in crest, together with all rights and interests in such sums and payments (all terms as defined). See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Citibank N.A.
    Transazioni
    • 02 mar 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 mar 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    BNY MELLON CAPITAL MARKETS EMEA LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    26 mag 2020Inizio della liquidazione
    02 nov 2021Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Matthew Robert Haw
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    Praticante
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    Karen Ann Spears
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    Praticante
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0