SURFACE TRANSFORMS PLC
Panoramica
Nome della società | SURFACE TRANSFORMS PLC |
---|---|
Stato della società | Attiva |
Forma giuridica | Società per azioni |
Numero di società | 03769702 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di SURFACE TRANSFORMS PLC?
- fabbricazione di altre parti e accessori per veicoli a motore (29320) / Industrie manifatturiere
- Altre ricerche e sviluppo sperimentale in scienze naturali e ingegneria (72190) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova SURFACE TRANSFORMS PLC?
Indirizzo della sede legale | Image Business Park Acornfield Road Knowsley Industrial Park L33 7UF Liverpool England |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di SURFACE TRANSFORMS PLC?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
AVONPATH LTD | 13 mag 1999 | 13 mag 1999 |
Quali sono gli ultimi bilanci di SURFACE TRANSFORMS PLC?
Scaduto | No |
---|---|
Prossimi bilanci | |
Fine del prossimo esercizio al | 31 dic 2024 |
Scadenza dei prossimi bilanci il | 30 giu 2025 |
Ultimi bilanci | |
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2023 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per SURFACE TRANSFORMS PLC?
Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 11 lug 2025 |
---|---|
Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 25 lug 2025 |
Ultima dichiarazione di conferma | |
Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 11 lug 2024 |
Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per SURFACE TRANSFORMS PLC?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cessazione della carica di Andrew James Kitchingman come amministratore in data 05 nov 2024 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||||||||||||||
Cessazione della carica di David George Bundred come amministratore in data 16 set 2024 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||||||||||||||
Nomina di Mr Andrew James Kitchingman come amministratore in data 16 set 2024 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 lug 2024 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||||||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2023 | 90 pagine | AA | ||||||||||||||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 24 mag 2024
| 3 pagine | SH01 | ||||||||||||||||||||||||||
Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 07 mag 2024
| 3 pagine | SH01 | ||||||||||||||||||||||||||
Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 18 dic 2023
| 3 pagine | SH01 | ||||||||||||||||||||||||||
Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 14 nov 2023
| 3 pagine | SH01 | ||||||||||||||||||||||||||
Iscrizione dell'ipoteca 037697020011, creata il 24 gen 2024 | 20 pagine | MR01 | ||||||||||||||||||||||||||
Iscrizione dell'ipoteca 037697020009, creata il 08 dic 2023 | 20 pagine | MR01 | ||||||||||||||||||||||||||
Iscrizione dell'ipoteca 037697020010, creata il 08 dic 2023 | 47 pagine | MR01 | ||||||||||||||||||||||||||
Nomina di Mrs Isabelle Marguerite Maddock come amministratore in data 04 set 2023 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 lug 2023 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||||||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2022 | 68 pagine | AA | ||||||||||||||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Nomina di Mr Richard Nathan Hattersley come segretario in data 31 mag 2023 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||||||||||||||||||
Cessazione della carica di Michael Cunningham come amministratore in data 31 mag 2023 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||||||||||||||
Cessazione della carica di Michael Cunningham come segretario in data 31 mag 2023 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||||||||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 037697020007 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||||||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Kevin Johnson il 23 feb 2023 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||||||||||||||
Cessazione della carica di Richard Douglas Gledhill come amministratore in data 31 ott 2022 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 lug 2022 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||||||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di SURFACE TRANSFORMS PLC?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HATTERSLEY, Richard Nathan | Segretario | Acornfield Road Knowsley Industrial Park L33 7UF Liverpool Image Business Park England | 309651300001 | |||||||
CLEMINSON, Ian Philip | Amministratore | Acornfield Road Knowsley Industrial Park L33 7UF Liverpool Surface Transforms Plc England | United Kingdom | British | Company Director | 95278280002 | ||||
JOHNSON, Kevin | Amministratore | Acornfield Road Knowsley Industrial Park L33 7UF Liverpool Image Business Park England | England | British | Operations Director | 102635690002 | ||||
MADDOCK, Isabelle Marguerite | Amministratore | Acornfield Road Knowsley Industrial Park L33 7UF Liverpool Image Business Park England | England | British | Chief Financial Officer | 278786920001 | ||||
TAYLOR, Matthew Gordon Robert | Amministratore | Acornfield Road Knowsley Industrial Park L33 7UF Liverpool Image Business Park England | Belgium | British | Director | 288633240001 | ||||
WOODHOUSE, Julia | Amministratore | Acornfield Road Knowsley Industrial Park L33 7UF Liverpool Image Business Park England | England | British | Director | 281488220001 | ||||
ALLEN, David Charles | Segretario | Acornfield Road Knowsley Industrial Park L33 7UF Liverpool Image Business Park England | 187179420001 | |||||||
CUNNINGHAM, Michael | Segretario | Acornfield Road Knowsley Industrial Park L33 7UF Liverpool Image Business Park England | 250259810001 | |||||||
FARIA, Julio Joseph | Segretario | 25 Bramley Court Chester Road CW6 0RF Kelsall Cheshire | British | Chemical Engineer | 65384370001 | |||||
HALL, Geoffrey Vernon | Segretario | 110 Higher Lane Lymm WA13 0BY Warrington Cheshire | British | Chartered Accountant | 99152690001 | |||||
STEEL, Sarah | Segretario | Braken Road West Timperley WA14 5UD Altrincham 1 Cheshire United Kingdom | 165434820001 | |||||||
STRETTON, Johannah Jane | Segretario | Broadstones Farm Mill Brow SK6 5DG Marple Bridge The Barn Cheshire | British | Chartered Accountant | 138872060001 | |||||
FORM 10 SECRETARIES FD LTD | Segretario nominato | 39a Leicester Road Salford M7 4AS Manchester Lancashire | 900014000001 | |||||||
HL SECRETARIES LIMITED | Segretario | St James's Court Brown Street M2 2JF Manchester Lancashire | 66785830001 | |||||||
HSE SECRETARIES LIMITED | Segretario | 7 Devonshire Square Cutlers Gardens EC2M 4YH London | 67382580006 | |||||||
BAKER, Kenneth Michael | Amministratore | The Dalehouse Dalehouse Lane CV8 2JZ Kenilworth Warwickshire | England | British | Director | 2389500001 | ||||
BUNDRED, David George | Amministratore | South Ferry Quay L3 4EL Liverpool 400 United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 70291370001 | ||||
CLARK, David Thomas, Professor | Amministratore | Springwell Holme 28 Field House Lane DH1 4LP Durham County Durham | British | Scientific Director | 30923380001 | |||||
CUNNINGHAM, Michael | Amministratore | Acornfield Road Knowsley Industrial Park L33 7UF Liverpool Image Business Park England | England | British | Finance Director | 161188070001 | ||||
DSILVA, Kevin Alphonso | Amministratore | The Old Rectory MK18 4LU Preston Bissett Buckinghamshire | United Kingdom | British | Director | 85251220001 | ||||
FARIA, Julio Joseph | Amministratore | 25 Bramley Court Chester Road CW6 0RF Kelsall Cheshire | United Kingdom | British | Chemical Engineer | 65384370001 | ||||
GLEDHILL, Richard Douglas | Amministratore | Law Lane Clint HG3 3HN Harrogate Beckside Farm North Yorkshire | England | British | Company Director | 45748000002 | ||||
GOULD, Geoffrey | Amministratore | Mews Cottage 56 Kenilworth Road CV32 6JW Leamington Spa Warwickshire | British | Company Director | 83309550001 | |||||
HOLLAND, Peter John | Amministratore | 3 The Greenwood Brook Road CW6 9HE Tarporley Cheshire | British | Advisor | 89404440001 | |||||
KITCHINGMAN, Andrew James | Amministratore | Burton Leonard HG3 3RS Harrogate Prospect House England | England | British | Non-Executive Director | 141188470001 | ||||
LEVIS, David Edward | Amministratore | 16 Buckfast Close Poynton SK12 1ER Stockport Cheshire | British | Director | 6699910001 | |||||
STEEL, Margaret Lilian, Dr | Amministratore | 21 Bunbury Drive WA7 4AL Runcorn Cheshire | British | Research Scientist | 30018920001 | |||||
WHITNEY, Derek Martin | Amministratore | Lakeside House Brighton Road, Sway SO41 6EB Lymington Hampshire | British | Consultant | 68115770001 | |||||
WILLIAMS, David | Amministratore | 1 Church End Sherington MK16 9PD Newport Pagnell Buckinghamshire | British | Chartered Engineer | 73778570001 | |||||
FORM 10 DIRECTORS FD LTD | Amministratore delegato nominato | 39a Leicester Road Salford M7 4AS Manchester Lancashire | 900013990001 |
Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per SURFACE TRANSFORMS PLC?
Notificato il | Cessato il | Dichiarazione |
---|---|---|
25 feb 2019 | La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società. |
SURFACE TRANSFORMS PLC ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Creato il 24 gen 2024 Consegnato il 24 gen 2024 | In corso | ||
Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 08 dic 2023 Consegnato il 12 dic 2023 | In corso | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 08 dic 2023 Consegnato il 12 dic 2023 | In corso | ||
Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 09 nov 2021 Consegnato il 10 nov 2021 | In corso | ||
Breve descrizione Contains fixed charge. Contains floating charge. Floating charge covers all the property or undertaking of the company. Contains negative pledge. L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 25 ott 2021 Consegnato il 28 ott 2021 | Soddisfatta integralmente | ||
Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 25 mag 2017 Consegnato il 02 giu 2017 | Soddisfatta integralmente | ||
Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 25 ott 2016 Consegnato il 15 nov 2016 | Soddisfatta integralmente | ||
Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 28 mar 2014 Consegnato il 04 apr 2014 | Soddisfatta integralmente | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Chattel mortgage | Creato il 18 ott 2011 Consegnato il 04 nov 2011 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The plant machinery chattels or other equipment being cvi vacuum finance, the benefit of any guarantee warranty or other obligation in relation to the mortgaged chattels , all logbooks maintenance records, the benefit of agreements, copyrights patents trademarks and the benefit in and to all insurance. See image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 18 ott 2011 Consegnato il 25 ott 2011 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the security trustee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Lease | Creato il 01 feb 2007 Consegnato il 20 feb 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £5450.97 due or to become due from the company to | |
Brevi particolari Lease over a sum of money (£5450.97). see the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0