STREAMFOODS LTD

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSTREAMFOODS LTD
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03771000
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di STREAMFOODS LTD?

    • Produzione di altri prodotti alimentari n.c.a. (10890) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova STREAMFOODS LTD?

    Indirizzo della sede legale
    40 Bradfield Road
    Finedon Road Industrial Estate
    NN8 4HB Wellingborough
    Northamptonshire
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di STREAMFOODS LTD?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2021

    Quali sono le ultime deposizioni per STREAMFOODS LTD?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Nomina di Mr Deon Joubert come segretario in data 03 feb 2023

    2 pagineAP03

    Nomina di Mr Deon Joubert come amministratore in data 03 feb 2023

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Steven Daniel Goodes come amministratore in data 03 feb 2023

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Felix Lombard come amministratore in data 03 feb 2023

    1 pagineTM01

    Soddisfazione dell'onere 037710000013 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    1 pagineMR04

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2021

    11 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 mag 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2020

    22 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 mag 2021 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Stato del capitale al 21 apr 2021

    • Capitale: GBP 1
    5 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    2 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    capital

    Risoluzioni

    Reduce share prem a/c 24/12/2020
    RES13

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 30 set 2020 al 31 dic 2020

    1 pagineAA01

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 mag 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Thushen Agambaram Govender come amministratore in data 30 apr 2020

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 30 set 2019

    35 pagineAA

    Bilancio redatto al 30 set 2018

    34 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di STREAMFOODS LTD?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GOODES, Steven Daniel
    Bradfield Road
    Finedon Road Industrial Estate
    NN8 4HB Wellingborough
    40
    Northamptonshire
    England
    Segretario
    Bradfield Road
    Finedon Road Industrial Estate
    NN8 4HB Wellingborough
    40
    Northamptonshire
    England
    236744200001
    JOUBERT, Deon
    Sanitarium Drive
    Berkeley Vale
    1
    New South Wales 2261
    Australia
    Segretario
    Sanitarium Drive
    Berkeley Vale
    1
    New South Wales 2261
    Australia
    305129160001
    JOUBERT, Deon
    Sanitarium Drive
    Berkeley Vale
    1
    New South Wales 2261
    Australia
    Amministratore
    Sanitarium Drive
    Berkeley Vale
    1
    New South Wales 2261
    Australia
    AustraliaAustralian305129060001
    THORN, Jonathon Wilhelm
    Bradfield Road
    Finedon Road Industrial Estate
    NN8 4HB Wellingborough
    40
    Northamptonshire
    England
    Amministratore
    Bradfield Road
    Finedon Road Industrial Estate
    NN8 4HB Wellingborough
    40
    Northamptonshire
    England
    EnglandBritish211294420001
    CRAIG, Andrea Harvey, Ms.
    Noak 4 Brow Of The Hill
    Leziate
    PE32 1EN Kings Lynn
    Norfolk
    Segretario
    Noak 4 Brow Of The Hill
    Leziate
    PE32 1EN Kings Lynn
    Norfolk
    British59469810001
    DING, Alison
    Westfield Rise Wormegay Road
    Blackborough End
    PE32 1SG Kings Lynn
    Norfolk
    Segretario
    Westfield Rise Wormegay Road
    Blackborough End
    PE32 1SG Kings Lynn
    Norfolk
    British58359950001
    HATHER, Jon
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Segretario
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    British68848420004
    LANE, Mark John
    Bradfield Road
    Finedon Road Industrial Estate
    NN8 4HB Wellingborough
    40
    Northamptonshire
    England
    Segretario
    Bradfield Road
    Finedon Road Industrial Estate
    NN8 4HB Wellingborough
    40
    Northamptonshire
    England
    British151305720001
    THORN, Jonathon Wilhelm
    Bradfield Road
    Finedon Road Industrial Estate
    NN8 4HB Wellingborough
    40
    Northamptonshire
    England
    Segretario
    Bradfield Road
    Finedon Road Industrial Estate
    NN8 4HB Wellingborough
    40
    Northamptonshire
    England
    211303240001
    RM REGISTRARS LIMITED
    Second Floor
    80 Great Eastern Street
    EC2A 3RX London
    Segretario nominato
    Second Floor
    80 Great Eastern Street
    EC2A 3RX London
    900000760001
    CHARLES, Gavin
    Westfield
    Gipsy Lane
    RG40 2HP Wokingham
    Berkshire
    Amministratore
    Westfield
    Gipsy Lane
    RG40 2HP Wokingham
    Berkshire
    EnglandBritish120029860002
    DING, Ian Charles
    West Field Rise Wormegay Road
    Blackborough End
    PE32 1SG Kings Lynn
    Norfolk
    Amministratore
    West Field Rise Wormegay Road
    Blackborough End
    PE32 1SG Kings Lynn
    Norfolk
    EnglandBritish58359910001
    GLEN, Frederick Nairn
    The Well House
    RG7 2DJ Stratfield Saye
    Berkshire
    Amministratore
    The Well House
    RG7 2DJ Stratfield Saye
    Berkshire
    United KingdomBritish72400610001
    GOODES, Steven Daniel
    Bradfield Road
    Finedon Road Industrial Estate
    NN8 4HB Wellingborough
    40
    Northamptonshire
    England
    Amministratore
    Bradfield Road
    Finedon Road Industrial Estate
    NN8 4HB Wellingborough
    40
    Northamptonshire
    England
    EnglandBritish236743890001
    GOODING, Belinda
    16 Boxgrove Avenue
    GU1 1XG Guildford
    Surrey
    Amministratore
    16 Boxgrove Avenue
    GU1 1XG Guildford
    Surrey
    United KingdomBritish109456400002
    GORDON, Alan George
    26 Wiverton Road
    SE26 5HY London
    Amministratore
    26 Wiverton Road
    SE26 5HY London
    British42882550001
    GOVENDER, Thushen Agambaram
    Building 1, Sliver Stream Business Park
    10 Muswell Road
    Bryanston
    Ground Floor
    South Africa
    Amministratore
    Building 1, Sliver Stream Business Park
    10 Muswell Road
    Bryanston
    Ground Floor
    South Africa
    South AfricaSouth African186889770001
    GUEST, Christopher Robert
    The Manor House
    Thorpe By Water
    LE15 9JQ Uppingham
    Leicestershire
    Amministratore
    The Manor House
    Thorpe By Water
    LE15 9JQ Uppingham
    Leicestershire
    British31438630001
    HILES, John Matthews
    Bradfield Road
    Finedon Road Industrial Estate
    NN8 4HB Wellingborough
    40
    Northamptonshire
    England
    Amministratore
    Bradfield Road
    Finedon Road Industrial Estate
    NN8 4HB Wellingborough
    40
    Northamptonshire
    England
    EnglandBritish173954820001
    LANE, Mark John
    Bradfield Road
    Finedon Road Industrial Estate
    NN8 4HB Wellingborough
    40
    Northamptonshire
    England
    Amministratore
    Bradfield Road
    Finedon Road Industrial Estate
    NN8 4HB Wellingborough
    40
    Northamptonshire
    England
    EnglandBritish132183700002
    LOMBARD, Felix
    Glacier Place
    1 Sportica Cresent
    Tygervalley 7530
    Pioneer Foods
    South Africa
    Amministratore
    Glacier Place
    1 Sportica Cresent
    Tygervalley 7530
    Pioneer Foods
    South Africa
    South AfricaSouth African238998300001
    MAGEE, Gerard Vincent
    Bradfield Road
    Finedon Road Industrial Estate
    NN8 4HB Wellingborough
    40
    Northamptonshire
    England
    Amministratore
    Bradfield Road
    Finedon Road Industrial Estate
    NN8 4HB Wellingborough
    40
    Northamptonshire
    England
    IrelandIrish151272980001
    MCGILL, John
    Tiefields
    New Drove
    PE14 4UA Northbrink
    Cambs
    Amministratore
    Tiefields
    New Drove
    PE14 4UA Northbrink
    Cambs
    British72400780001
    MYBURGH, Corni
    Bradfield Road
    Finedon Road Industrial Estate
    NN8 4HB Wellingborough
    40
    Northamptonshire
    England
    Amministratore
    Bradfield Road
    Finedon Road Industrial Estate
    NN8 4HB Wellingborough
    40
    Northamptonshire
    England
    South AfricaSouth African236784340001
    NEWBERRY, Paul David
    White Lodge
    Maywood Drive, Portsmouth Road
    GU15 1LH Camberley
    Surrey
    Amministratore
    White Lodge
    Maywood Drive, Portsmouth Road
    GU15 1LH Camberley
    Surrey
    EnglandBritish69243720001
    O'CONNOR, Philip Stephen
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Amministratore
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    EnglandIrish107745290001
    TOOMEY, John Francis
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Amministratore
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    EnglandIrish164624980001
    RM NOMINEES LIMITED
    Second Floor
    80 Great Eastern Street
    EC2A 3RX London
    Amministratore delegato nominato
    Second Floor
    80 Great Eastern Street
    EC2A 3RX London
    900009140001

    Chi sono le persone con controllo significativo di STREAMFOODS LTD?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Bradfield Road
    Finedon Road Industrial Estate
    NN8 4HB Wellingborough
    40
    England
    29 lug 2016
    Bradfield Road
    Finedon Road Industrial Estate
    NN8 4HB Wellingborough
    40
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione04080435
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    STREAMFOODS LTD ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 12 ago 2016
    Consegnato il 18 ago 2016
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    1) registered trademark: aneeq, registration number 2543822, filing date 31/03/2010, classes 29 and 30. 2) registered trademark: aroi, registration number 2543826, filing date 31/03/2010, classes 29 and 30. any additional intellectual property - see deed for further details.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transazioni
    • 18 ago 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 25 gen 2023Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A supplemental deed
    Creato il 13 gen 2010
    Consegnato il 14 gen 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor & Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 14 gen 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 20 ott 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Composite debenture
    Creato il 24 dic 2009
    Consegnato il 08 gen 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations and liabilities due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed charge over any right title or interest in any land and all shareas related rights and all distribution rights thereon; all investments and related rights all book debts benefits and security thereon; all non trading debts and all benefits rights and security thereunder; fixed charge over all amounts standing to the credit of each account and any other amount; all property rights all fees royalties and other rights thereon; the goodwill and uncalled capital and benefit of all authorisations held in relation to any security interest; all insurances and floating charge over all undertaking and assets see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor & Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 08 gen 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 20 ott 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Security accession deed
    Creato il 14 gen 2009
    Consegnato il 27 gen 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Units a,b and c broadend industrial estate (also known as unit 5) t/no NK328879; fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland (As Agent and Trustee for Itself and the Finance Parties)
    Transazioni
    • 27 gen 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 ott 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Supplemental deed
    Creato il 14 mar 2008
    Consegnato il 31 mar 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland (As Trustee for the Finance Parties) (the Security Trustee)
    Transazioni
    • 31 mar 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 ott 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Security accession deed to a debenture dated 7 september 2006 and
    Creato il 28 feb 2007
    Consegnato il 08 mar 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland (As Trustee for the Finance Parties) (Securitytrustee)
    Transazioni
    • 08 mar 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 ott 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 20 dic 2005
    Consegnato il 29 dic 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 29 dic 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 23 set 2005
    Consegnato il 29 set 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £9,693.75 due or to become due from the company to
    Brevi particolari
    All of its right and entitlement to the funds held in the deposit account. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Beverley Patricia Emden
    Transazioni
    • 29 set 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 gen 2023Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Rent deposit deed
    Creato il 14 giu 2005
    Consegnato il 27 giu 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £8,812.50 due or to become due from the company to
    Brevi particolari
    By way of first fixed legal charge all its right and entitlement to the deposit account from time to time and all interest cerdited to the deposit account.
    Persone aventi diritto
    • Beverley Patricia Emden
    Transazioni
    • 27 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 gen 2023Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 20 apr 2005
    Consegnato il 05 mag 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The property k/a units a b & c broadend road industrial estate walsoken wisbech cambs. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 05 mag 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creato il 27 ago 2004
    Consegnato il 03 set 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the plant, machinery, chattels or other equipment being, make line 3 fruit paste bar, model extruding machine, make cartoner, serial no 03-193's, make checkweighter, serial no B2319. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 03 set 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 ott 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 13 dic 2000
    Consegnato il 15 dic 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 15 dic 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 04 ott 2000
    Consegnato il 11 ott 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 11 ott 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 mar 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0