PENNANT SOFTWARE SERVICES LIMITED

PENNANT SOFTWARE SERVICES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPENNANT SOFTWARE SERVICES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03772667
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PENNANT SOFTWARE SERVICES LIMITED?

    • Sviluppo di software per le imprese e per uso domestico (62012) / Informazione e comunicazione

    Dove si trova PENNANT SOFTWARE SERVICES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Pennant Court
    Staverton Technology Park
    GL51 6TL Cheltenham
    Gloucestershire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PENNANT SOFTWARE SERVICES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PENNANT INFORMATION SERVICES LIMITED21 gen 200021 gen 2000
    SOLVERA INFORMATION SERVICES (DOCUMENTATION) LIMITED28 lug 199928 lug 1999
    PRECIS (1761) LIMITED18 mag 199918 mag 1999

    Quali sono gli ultimi bilanci di PENNANT SOFTWARE SERVICES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per PENNANT SOFTWARE SERVICES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Cessazione della carica di Gary Robert Barnes come amministratore in data 21 nov 2019

    1 pagineTM01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 18 mag 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Christopher Charles Powell come amministratore in data 03 mag 2019

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Timothy Julian Rice come amministratore in data 24 set 2018

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 18 mag 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mr Gary Robert Barnes come amministratore in data 01 apr 2018

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 31 dic 2017

    26 pagineAA

    Nomina di Mr David Joseph Clements come amministratore in data 12 ott 2017

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr David Joseph Clements come segretario in data 15 giu 2017

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Philip Henry Walker come segretario in data 15 giu 2017

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Timothy Julian Rice come amministratore in data 05 giu 2017

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Simon Alick Moore come amministratore in data 05 giu 2017

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 18 mag 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Cessazione della carica di Christopher Snook come amministratore in data 29 mar 2017

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2016

    25 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 18 mag 2016 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital18 mag 2016

    Stato del capitale al 18 mag 2016

    • Capitale: GBP 1,000,000
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2015

    25 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 18 mag 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital18 mag 2015

    Stato del capitale al 18 mag 2015

    • Capitale: GBP 1,000,000
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    27 pagineAA

    Nomina di Mr Philip Henry Walker come segretario in data 03 nov 2014

    2 pagineAP03

    Nomina di Mr Philip Henry Walker come amministratore in data 03 nov 2014

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di John Mark Waller come amministratore in data 03 nov 2014

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di PENNANT SOFTWARE SERVICES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CLEMENTS, David Joseph
    Pennant Court
    Staverton Technology Park
    GL51 6TL Cheltenham
    Gloucestershire
    Segretario
    Pennant Court
    Staverton Technology Park
    GL51 6TL Cheltenham
    Gloucestershire
    233687120001
    CLEMENTS, David Joseph
    Pennant Court
    Staverton Technology Park
    GL51 6TL Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    Pennant Court
    Staverton Technology Park
    GL51 6TL Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritish200768970001
    MOORE, Simon Alick
    Pennant Court
    Staverton Technology Park
    GL51 6TL Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    Pennant Court
    Staverton Technology Park
    GL51 6TL Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritish169812620001
    WALKER, Philip Henry
    Pennant Court
    Staverton Technology Park
    GL51 6TL Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    Pennant Court
    Staverton Technology Park
    GL51 6TL Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritish192548770001
    WALKER, Philip Henry
    Pennant Court
    Staverton Technology Park
    GL51 6TL Cheltenham
    Gloucestershire
    Segretario
    Pennant Court
    Staverton Technology Park
    GL51 6TL Cheltenham
    Gloucestershire
    192552730001
    WALLER, John Mark
    Pennant Court
    Staverton Technology Park
    GL51 6TL Cheltenham
    Gloucestershire
    Segretario
    Pennant Court
    Staverton Technology Park
    GL51 6TL Cheltenham
    Gloucestershire
    British8778550002
    WEST, James Crawshaw
    103 Lower Road
    SL9 8JZ Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Segretario
    103 Lower Road
    SL9 8JZ Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British29331030001
    OFFICE ORGANIZATION & SERVICES LIMITED
    Level 1 Exchange House
    Primrose Street
    EC2A 2HS London
    Segretario
    Level 1 Exchange House
    Primrose Street
    EC2A 2HS London
    2519400001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BARNES, Gary Robert
    Pennant Court
    Staverton Technology Park
    GL51 6TL Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    Pennant Court
    Staverton Technology Park
    GL51 6TL Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritish244815210001
    BARNETT, Calvin Stuart
    3 The Firs
    Stockbridge Road
    SO20 5BD Winchester
    Hampshire
    Amministratore
    3 The Firs
    Stockbridge Road
    SO20 5BD Winchester
    Hampshire
    EnglandBritish65673400001
    DENHOLM, Ian Thomas
    4 Sunset Road
    Totton
    SO40 3JU Southampton
    Hampshire
    Amministratore
    4 Sunset Road
    Totton
    SO40 3JU Southampton
    Hampshire
    British68340880002
    DENHOLM, Ian Thomas
    The Old School Hemp Lane
    Wigginton
    HP23 6HF Tring
    Hertfordshire
    Amministratore
    The Old School Hemp Lane
    Wigginton
    HP23 6HF Tring
    Hertfordshire
    British68340880001
    JEROME, David Leslie
    34 Collington Crescent
    PO6 4BH Portsmouth
    Hampshire
    Amministratore
    34 Collington Crescent
    PO6 4BH Portsmouth
    Hampshire
    British61080770001
    JEROME, David Leslie
    34 Collington Crescent
    PO6 4BH Portsmouth
    Hampshire
    Amministratore
    34 Collington Crescent
    PO6 4BH Portsmouth
    Hampshire
    British61080770001
    PENFOLD, Diane June
    43 Eagle Court
    Hermon Hill
    E11 1PD London
    Amministratore
    43 Eagle Court
    Hermon Hill
    E11 1PD London
    United KingdomBritish59962430002
    POWELL, Christopher Charles
    Pennant Court
    Staverton Technology Park
    GL51 6TL Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    Pennant Court
    Staverton Technology Park
    GL51 6TL Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritish264658290001
    RICE, Timothy Julian
    Pennant Court
    Staverton Technology Park
    GL51 6TL Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    Pennant Court
    Staverton Technology Park
    GL51 6TL Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritish219666070001
    SNOOK, Christopher
    Avalon 14 Whiteway View
    Stratton
    GL7 2HY Cirencester
    Gloucestershire
    Amministratore
    Avalon 14 Whiteway View
    Stratton
    GL7 2HY Cirencester
    Gloucestershire
    EnglandBritish81547090001
    THOMPSON, Joseph John James
    Underhill House
    Gretton
    GL54 5DA Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    Underhill House
    Gretton
    GL54 5DA Cheltenham
    Gloucestershire
    British43146240001
    WALLER, John Mark
    Farriers House Naseby Road
    Thornby
    NN6 8SW Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    Farriers House Naseby Road
    Thornby
    NN6 8SW Northampton
    Northamptonshire
    EnglandBritish8778550002
    WILSON, Clare Alice
    75 Ifield Road
    SW10 9AU London
    Amministratore
    75 Ifield Road
    SW10 9AU London
    British47611200001

    Chi sono le persone con controllo significativo di PENNANT SOFTWARE SERVICES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Herrick Close
    Staverton Technology Park, Staverton
    GL51 6TL Cheltenham
    Pennant Court
    England
    06 apr 2016
    Herrick Close
    Staverton Technology Park, Staverton
    GL51 6TL Cheltenham
    Pennant Court
    England
    No
    Forma giuridicaPlc
    Paese di registrazioneUk
    Autorità legaleCompanies Act
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione03187528
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    PENNANT SOFTWARE SERVICES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Charge of intellectual property
    Creato il 26 mar 2003
    Consegnato il 04 apr 2003
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All rights,title and interest in and to the intellectual property rights excluding third party rights and all materials; the right to commence proceedings and/or receive and recover damages and all plant,machinery and equipment thereon; all book and other debts from time to time due to the company; first floating charge over the remaining undertaking,assets and business and all other rights,assets and property; see form 395 for details. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 04 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 13 feb 2002
    Consegnato il 19 feb 2002
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H properties 2-10 cawte road 210-214 shirley road 1, 3, 5, 7 and 9 paynes road and land adjoining t/nos: HP154515 HP586655 HP518278 HP111751 HP428299 HP397993 HP238161 HP320808.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 feb 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 21 dic 1999
    Consegnato il 23 dic 1999
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 23 dic 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 10 ago 1999
    Consegnato il 14 ago 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Gmac Commercial Credit Limited
    Transazioni
    • 14 ago 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 gen 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 06 ago 1999
    Consegnato il 23 ago 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 3 of the hive down agreement dated 6 august 1999
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Solvera Information Services Limited
    Transazioni
    • 23 ago 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 gen 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 06 ago 1999
    Consegnato il 14 ago 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Solvera PLC(In Administration)
    Transazioni
    • 14 ago 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 gen 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0