PENNANT SOFTWARE SERVICES LIMITED
Panoramica
| Nome della società | PENNANT SOFTWARE SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03772667 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di PENNANT SOFTWARE SERVICES LIMITED?
- Sviluppo di software per le imprese e per uso domestico (62012) / Informazione e comunicazione
Dove si trova PENNANT SOFTWARE SERVICES LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Pennant Court Staverton Technology Park GL51 6TL Cheltenham Gloucestershire |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di PENNANT SOFTWARE SERVICES LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| PENNANT INFORMATION SERVICES LIMITED | 21 gen 2000 | 21 gen 2000 |
| SOLVERA INFORMATION SERVICES (DOCUMENTATION) LIMITED | 28 lug 1999 | 28 lug 1999 |
| PRECIS (1761) LIMITED | 18 mag 1999 | 18 mag 1999 |
Quali sono gli ultimi bilanci di PENNANT SOFTWARE SERVICES LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2017 |
Quali sono le ultime deposizioni per PENNANT SOFTWARE SERVICES LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Cessazione della carica di Gary Robert Barnes come amministratore in data 21 nov 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 18 mag 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Christopher Charles Powell come amministratore in data 03 mag 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Timothy Julian Rice come amministratore in data 24 set 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 18 mag 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Mr Gary Robert Barnes come amministratore in data 01 apr 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2017 | 26 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr David Joseph Clements come amministratore in data 12 ott 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr David Joseph Clements come segretario in data 15 giu 2017 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Philip Henry Walker come segretario in data 15 giu 2017 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di Mr Timothy Julian Rice come amministratore in data 05 giu 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Simon Alick Moore come amministratore in data 05 giu 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 18 mag 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Christopher Snook come amministratore in data 29 mar 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2016 | 25 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 18 mag 2016 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2015 | 25 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 18 mag 2015 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2014 | 27 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Philip Henry Walker come segretario in data 03 nov 2014 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Nomina di Mr Philip Henry Walker come amministratore in data 03 nov 2014 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di John Mark Waller come amministratore in data 03 nov 2014 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di PENNANT SOFTWARE SERVICES LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLEMENTS, David Joseph | Segretario | Pennant Court Staverton Technology Park GL51 6TL Cheltenham Gloucestershire | 233687120001 | |||||||
| CLEMENTS, David Joseph | Amministratore | Pennant Court Staverton Technology Park GL51 6TL Cheltenham Gloucestershire | England | British | 200768970001 | |||||
| MOORE, Simon Alick | Amministratore | Pennant Court Staverton Technology Park GL51 6TL Cheltenham Gloucestershire | England | British | 169812620001 | |||||
| WALKER, Philip Henry | Amministratore | Pennant Court Staverton Technology Park GL51 6TL Cheltenham Gloucestershire | England | British | 192548770001 | |||||
| WALKER, Philip Henry | Segretario | Pennant Court Staverton Technology Park GL51 6TL Cheltenham Gloucestershire | 192552730001 | |||||||
| WALLER, John Mark | Segretario | Pennant Court Staverton Technology Park GL51 6TL Cheltenham Gloucestershire | British | 8778550002 | ||||||
| WEST, James Crawshaw | Segretario | 103 Lower Road SL9 8JZ Gerrards Cross Buckinghamshire | British | 29331030001 | ||||||
| OFFICE ORGANIZATION & SERVICES LIMITED | Segretario | Level 1 Exchange House Primrose Street EC2A 2HS London | 2519400001 | |||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Segretario nominato | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| BARNES, Gary Robert | Amministratore | Pennant Court Staverton Technology Park GL51 6TL Cheltenham Gloucestershire | England | British | 244815210001 | |||||
| BARNETT, Calvin Stuart | Amministratore | 3 The Firs Stockbridge Road SO20 5BD Winchester Hampshire | England | British | 65673400001 | |||||
| DENHOLM, Ian Thomas | Amministratore | 4 Sunset Road Totton SO40 3JU Southampton Hampshire | British | 68340880002 | ||||||
| DENHOLM, Ian Thomas | Amministratore | The Old School Hemp Lane Wigginton HP23 6HF Tring Hertfordshire | British | 68340880001 | ||||||
| JEROME, David Leslie | Amministratore | 34 Collington Crescent PO6 4BH Portsmouth Hampshire | British | 61080770001 | ||||||
| JEROME, David Leslie | Amministratore | 34 Collington Crescent PO6 4BH Portsmouth Hampshire | British | 61080770001 | ||||||
| PENFOLD, Diane June | Amministratore | 43 Eagle Court Hermon Hill E11 1PD London | United Kingdom | British | 59962430002 | |||||
| POWELL, Christopher Charles | Amministratore | Pennant Court Staverton Technology Park GL51 6TL Cheltenham Gloucestershire | England | British | 264658290001 | |||||
| RICE, Timothy Julian | Amministratore | Pennant Court Staverton Technology Park GL51 6TL Cheltenham Gloucestershire | England | British | 219666070001 | |||||
| SNOOK, Christopher | Amministratore | Avalon 14 Whiteway View Stratton GL7 2HY Cirencester Gloucestershire | England | British | 81547090001 | |||||
| THOMPSON, Joseph John James | Amministratore | Underhill House Gretton GL54 5DA Cheltenham Gloucestershire | British | 43146240001 | ||||||
| WALLER, John Mark | Amministratore | Farriers House Naseby Road Thornby NN6 8SW Northampton Northamptonshire | England | British | 8778550002 | |||||
| WILSON, Clare Alice | Amministratore | 75 Ifield Road SW10 9AU London | British | 47611200001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di PENNANT SOFTWARE SERVICES LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pennant International Group Plc | 06 apr 2016 | Herrick Close Staverton Technology Park, Staverton GL51 6TL Cheltenham Pennant Court England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
PENNANT SOFTWARE SERVICES LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Charge of intellectual property | Creato il 26 mar 2003 Consegnato il 04 apr 2003 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All rights,title and interest in and to the intellectual property rights excluding third party rights and all materials; the right to commence proceedings and/or receive and recover damages and all plant,machinery and equipment thereon; all book and other debts from time to time due to the company; first floating charge over the remaining undertaking,assets and business and all other rights,assets and property; see form 395 for details. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 13 feb 2002 Consegnato il 19 feb 2002 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H properties 2-10 cawte road 210-214 shirley road 1, 3, 5, 7 and 9 paynes road and land adjoining t/nos: HP154515 HP586655 HP518278 HP111751 HP428299 HP397993 HP238161 HP320808. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 21 dic 1999 Consegnato il 23 dic 1999 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 10 ago 1999 Consegnato il 14 ago 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 06 ago 1999 Consegnato il 23 ago 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 3 of the hive down agreement dated 6 august 1999 | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 06 ago 1999 Consegnato il 14 ago 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0