IDEMIA UK PROPERTY LIMITED
Panoramica
| Nome della società | IDEMIA UK PROPERTY LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03773524 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di IDEMIA UK PROPERTY LIMITED?
- Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari
Dove si trova IDEMIA UK PROPERTY LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Alexandra Way Ashchurch Business Centre GL20 8GA Tewkesbury Gloucestershire |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di IDEMIA UK PROPERTY LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| OBERTHUR TECHNOLOGIES UK PROPERTY LIMITED | 10 dic 2008 | 10 dic 2008 |
| OBERTHUR CARD SYSTEMS PROPERTY LIMITED | 04 ott 1999 | 04 ott 1999 |
| DE LA RUE PROPERTY LIMITED | 17 giu 1999 | 17 giu 1999 |
| PRECIS (1744) LIMITED | 19 mag 1999 | 19 mag 1999 |
Quali sono gli ultimi bilanci di IDEMIA UK PROPERTY LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2019 |
Quali sono le ultime deposizioni per IDEMIA UK PROPERTY LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2019 | 25 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 19 mag 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2018 | 17 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Laura Jane Cassey come amministratore in data 28 giu 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Eric Robert Quinlan come amministratore in data 28 giu 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Hugues Ghislain Mallet come amministratore in data 22 feb 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Eric Albert Andre Duforest come amministratore in data 22 feb 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 19 mag 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2017 | 17 pagine | AA | ||||||||||
I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato 100 New Bridge Street London EC4V 6JA | 1 pagine | AD03 | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Oberthur Technologies Uk Limited come persona con controllo significativo il 13 apr 2018 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 19 mag 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 3 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2016 | 14 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 19 mag 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2015 | 16 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 19 mag 2016 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da C/O Harrison Clark Rickerbys Limited Ellenborough House Wellington Street Cheltenham Gloucestershire GL50 1YD England a 100 New Bridge Street London EC4V 6JA | 1 pagine | AD02 | ||||||||||
I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato 100 New Bridge Street London EC4V 6JA | 1 pagine | AD03 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2014 | 13 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 19 mag 2015 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Harrison Clark Rickerbys Limited come segretario in data 06 mar 2015 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di IDEMIA UK PROPERTY LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASSEY, Laura Jayne | Amministratore | Alexandra Way Ashchurch Business Centre GL20 8GA Tewkesbury Gloucestershire | England | British | 259964040001 | |||||||||
| MALLET, Hugues Ghislain | Amministratore | Ashchurch Business Centre GL20 8GA Tewkesbury Alexandra Way Gloucestershire England | France | French | 256932510001 | |||||||||
| HERMANS, Jean-Francois | Segretario | 21 Queens Walk Ealing W5 1TP London | British | 63615870001 | ||||||||||
| MORLEY, Jonathan Nigel | Segretario | c/o Rickerbys Llp Wellington Street GL50 1YD Cheltenham Ellenborough House Gloucestershire England | British | 123713720001 | ||||||||||
| DEWEY & LEBOEUF CORPORATE SERVICES LIMITED | Segretario | No 1 Minister Court Mincing Lane EC3R 7YL London | 125820880001 | |||||||||||
| HARRISON CLARK RICKERBYS LIMITED | Segretario | Wellington Street GL50 1YD Cheltenham Ellenborough House Gloucestershire England |
| 147649830003 | ||||||||||
| OFFICE ORGANIZATION & SERVICES LIMITED | Segretario | Level 1 Exchange House Primrose Street EC2A 2HS London | 2519400001 | |||||||||||
| RICKERBYS LLP | Segretario | Wellington Street GL50 1YD Cheltenham Ellenborough House Gloucestershire United Kingdom |
| 169839200001 | ||||||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Segretario nominato | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||||||
| AIME, Michel | Amministratore | 2 Rue De L'Amiral De Joinville Nevilly 92200 France | French | 66464490001 | ||||||||||
| BARBERIS, Pierre | Amministratore | 3 Avenue Bosquet FOREIGN Paris 75007 France | French | 90058500001 | ||||||||||
| DRILHON, Xavier Yves Paul Pierre Marie | Amministratore | Alexandra Way Ashchurch Business Centre GL20 8GA Tewkesbury Gloucestershire | France | French | 114126360001 | |||||||||
| DUFOREST, Eric Albert Andre | Amministratore | Alexandra Way Ashchurch Business Centre GL20 8GA Tewkesbury Gloucestershire | France | French | 165171830001 | |||||||||
| FLUKER, Christine Louise | Amministratore | Hayburn Lodge 2 Walpole Avenue TW9 2DJ Richmond Surrey | United Kingdom | British | 56880870001 | |||||||||
| GEYRES, Philippe Louis Marie | Amministratore | 63, Rue Des Saints Peres, FOREIGN Paris 75006 France | French | 120021380001 | ||||||||||
| HOLLINGWORTH, Paul Robert | Amministratore | 62 Galveston Road SW15 2SA London | British | 41135110002 | ||||||||||
| LAING, Richard George | Amministratore | Great Lywood Farm House Lindfield Road Ardingly RH17 6SW Haywards Heath West Sussex | England | British | 1415680003 | |||||||||
| MCGOWAN, Robert Graeme | Amministratore | 6 Dower Close Knotty Green HP9 1XZ Beaconsfield Buckinghamshire | United Kingdom | British | 19920920001 | |||||||||
| PENFOLD, Diane June | Amministratore | 43 Eagle Court Hermon Hill E11 1PD London | United Kingdom | British | 59962430002 | |||||||||
| QUINLAN, Eric Robert | Amministratore | Alexandra Way Ashchurch Business Centre GL20 8GA Tewkesbury Gloucestershire | England | British | 69206540001 | |||||||||
| ROBSON, Ian Digby | Amministratore | Home Farm Foxgote GL54 4LP Andoversford Gloucestershire | United Kingdom | British | 116436680001 | |||||||||
| SAVARE, Jean-Pierre | Amministratore | 13 Boulevard D'Auteuil Boulogne Billancourt 92100 France | French | 66464280002 | ||||||||||
| SAVARE, Thomas Charles Toussaint | Amministratore | Alexandra Way Ashchurch Business Centre GL20 8GA Tewkesbury Gloucestershire | France | French | 160720150005 | |||||||||
| SAVARE, Thomas Charles Toussaint | Amministratore | 17 Avenue Robert Schuman Boulogne 92100 Billancourt France | France | French | 160720150005 | |||||||||
| WILSON, Clare Alice | Amministratore | 75 Ifield Road SW10 9AU London | British | 47611200001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di IDEMIA UK PROPERTY LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idemia Uk Limited | 06 apr 2016 | Ashchurch Business Centre Ashchurch GL20 8GA Tewkesbury Alexandra Way England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
IDEMIA UK PROPERTY LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creato il 15 nov 1999 Consegnato il 01 dic 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or in connection with the guarantee and debenture | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 12 nov 1999 Consegnato il 30 nov 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All money's due or to become due from the company to the beneficiaries on any account whatsoever under the guarantee and the debenture | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0