TAVISTOCK TYRE AND EXHAUST SERVICES LTD.

TAVISTOCK TYRE AND EXHAUST SERVICES LTD.

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTAVISTOCK TYRE AND EXHAUST SERVICES LTD.
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03776028
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TAVISTOCK TYRE AND EXHAUST SERVICES LTD.?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova TAVISTOCK TYRE AND EXHAUST SERVICES LTD.?

    Indirizzo della sede legale
    Micheldever Station
    Winchester
    SO21 3AP Hampshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di TAVISTOCK TYRE AND EXHAUST SERVICES LTD.?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2012

    Quali sono le ultime deposizioni per TAVISTOCK TYRE AND EXHAUST SERVICES LTD.?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 24 mag 2013 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital24 mag 2013

    Stato del capitale al 24 mag 2013

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2012

    7 pagineAA

    Cessazione della carica di Richard Murray Sawney come segretario in data 05 lug 2012

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Jonathan Cowles come segretario in data 05 lug 2012

    1 pagineAP03

    Bilancio annuale redatto al 24 mag 2012 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Esercizio contabile in corso abbreviato dal 01 apr 2012 al 31 mar 2012

    1 pagineAA01

    Conto per una società dormiente redatto al 01 apr 2011

    7 pagineAA

    Risoluzioni

    Resolutions
    6 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Senior facilities agreement 04/10/2011
    RES13

    legacy

    25 pagineMG01

    legacy

    21 pagineMG01

    Bilancio annuale redatto al 24 mag 2011 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Jonathan Robert Cowles il 24 mag 2011

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Richard Murray Sawney il 24 mag 2011

    1 pagineCH03

    Conto per una società dormiente redatto al 01 apr 2010

    7 pagineAA

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio annuale redatto al 24 mag 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 01 apr 2009

    6 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine353

    legacy

    1 pagine225

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 01 ott 2007

    6 pagineAA

    legacy

    1 pagine225

    Chi sono gli amministratori di TAVISTOCK TYRE AND EXHAUST SERVICES LTD.?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    COWLES, Jonathan
    Micheldever Station
    Winchester
    SO21 3AP Hampshire
    Segretario
    Micheldever Station
    Winchester
    SO21 3AP Hampshire
    170396470001
    COWLES, Jonathan Robert
    Micheldever Station
    Winchester
    SO21 3AP Hampshire
    Amministratore
    Micheldever Station
    Winchester
    SO21 3AP Hampshire
    United KingdomBritish122658610001
    ALLEN, Simon John
    Roundhouse Barn
    Broadwell Farm
    PL19 8JW Tavistock
    Devon
    Segretario
    Roundhouse Barn
    Broadwell Farm
    PL19 8JW Tavistock
    Devon
    British64172490001
    SAWNEY, Richard Murray
    Micheldever Station
    Winchester
    SO21 3AP Hampshire
    Segretario
    Micheldever Station
    Winchester
    SO21 3AP Hampshire
    British64848360001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ALLEN, Derek Hasleden
    4 Walreddon Close
    PL19 8DW Tavistock
    Devon
    Amministratore
    4 Walreddon Close
    PL19 8DW Tavistock
    Devon
    British64172480002
    ALLEN, Simon John
    Roundhouse Barn
    Broadwell Farm
    PL19 8JW Tavistock
    Devon
    Amministratore
    Roundhouse Barn
    Broadwell Farm
    PL19 8JW Tavistock
    Devon
    British64172490001

    TAVISTOCK TYRE AND EXHAUST SERVICES LTD. ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Group debenture
    Creato il 05 ott 2011
    Consegnato il 14 ott 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each present and future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Rbs Invoice Finance Limited (Security Agent)
    Transazioni
    • 14 ott 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Group debenture
    Creato il 05 ott 2011
    Consegnato il 14 ott 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The "Security Agent")
    Transazioni
    • 14 ott 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Fixed and floating charge
    Creato il 01 dic 2004
    Consegnato il 02 dic 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transazioni
    • 02 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 10 set 1999
    Consegnato il 24 set 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 24 set 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ago 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0