CPI BOOKMARQUE LTD
Panoramica
| Nome della società | CPI BOOKMARQUE LTD |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03780595 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di CPI BOOKMARQUE LTD?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova CPI BOOKMARQUE LTD?
| Indirizzo della sede legale | 15 Canada Square Canary Wharf E14 5GL London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di CPI BOOKMARQUE LTD?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| BOOKMARQUE LIMITED | 02 ago 1999 | 02 ago 1999 |
| HAGATRADE LIMITED | 01 giu 1999 | 01 giu 1999 |
Quali sono gli ultimi bilanci di CPI BOOKMARQUE LTD?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2013 |
Quali sono le ultime deposizioni per CPI BOOKMARQUE LTD?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Domanda di insolvenza Insolvency:secretary of state's release of liquidator | 1 pagine | LIQ MISC | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 4 pagine | 4.71 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 08 set 2016 | 4 pagine | 4.68 | ||||||||||
Ordinanza giudiziaria in materia di insolvenza Court order insolvency:c/o replacement of liquidator | 30 pagine | LIQ MISC OC | ||||||||||
Avviso di cessazione di funzioni come liquidatore volontario | 1 pagine | 4.40 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 2 pagine | 600 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 08 set 2015 | 4 pagine | 4.68 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 8 Salisbury Square London EC4Y 8BB a 15 Canada Square Canary Wharf London E14 5GL in data 28 apr 2015 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 8 Springfield Close Ovington Prudhoe Northumberland NE42 6WZ a 8 Salisbury Square London EC4Y 8BB in data 01 ott 2014 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 3 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 3 pagine | 4.70 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 giu 2014 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Francois Golicheff come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da * Cox & Wyman House Cardiff Road Reading RG1 8EX England* in data 13 mar 2014 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 2 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 3 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2013 | 18 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 giu 2013 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2012 | 17 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 giu 2012 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da * C/O Cpi Group Legal Department Cox & Wyman House Cardiff Road Reading RG1 8EX England* in data 18 lug 2012 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2011 | 17 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Matthew William Robson come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di CPI BOOKMARQUE LTD?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBSON, Matthew William | Segretario | Reivers Springfield Close NE42 6EL Ovington Northumberland | British | 93423100001 | ||||||
| ROBSON, Matthew William | Amministratore | Springfield Close Ovington NE42 6EL Prudhoe Reivers Northumberland England | England | British | 93423100001 | |||||
| HARRIS, Derek John | Segretario | 35 Furze Lane CR8 3EJ Purley Surrey | British | 14483180001 | ||||||
| RILEY, Anthony Stephen | Segretario | 133 Thetford Road KT3 5DS New Malden Surrey | British | 55495290001 | ||||||
| NORTON ROSE LIMITED | Segretario nominato | Kempson House P.O. Box 570, Camomile Street EC3A 7AN London | 900006420001 | |||||||
| AUSTIN, Michael Anthony | Amministratore | 5 Old Oak Avenue CR5 3PG Chipstead Surrey | England | British | 46324150001 | |||||
| BOVARD, Timothy Landon | Amministratore | 7 Boulevard Anatole France FOREIGN Boulogne 92100 France | British | 101457350001 | ||||||
| CATTE, Pierre Francois | Amministratore | Bis Rue De La Tour 75016 Paris 62 France | France | French | 165234830001 | |||||
| GOLICHEFF, Francois Jacques Pierre | Amministratore | Cardiff Road RG1 8EX Reading Cox & Wyman House Berkshire | France | French | 146651780001 | |||||
| GUILLIER TUAL, Natalie | Amministratore | 43 Bis Rue Henri Cloppet Le Vesinet 78100 France | French | 103508190001 | ||||||
| HARRIS, Derek John | Amministratore | 35 Furze Lane CR8 3EJ Purley Surrey | United Kingdom | British | 14483180001 | |||||
| MARTIN, Kevin | Amministratore | 1 Collingtree Road Sydenham SE26 4QG London | British | 72715130003 | ||||||
| MULCAIRN, Martin | Amministratore | 7 The Cottages Outwood Lane CR5 3NJ Chipstead Surrey | British | 89418880001 | ||||||
| RANDALL, Christopher | Amministratore | Flat 2 Mount View Road N4 4JT London | British | 65280910002 | ||||||
| RILEY, Anthony Stephen | Amministratore | 133 Thetford Road KT3 5DS New Malden Surrey | British | 55495290001 | ||||||
| ROBSON, Matthew William | Amministratore | Reivers Springfield Close NE42 6EL Ovington Northumberland | England | British | 93423100001 | |||||
| TAYLOR, Michael Edward | Amministratore | Forest Hall Springwood Park TN11 9LZ Tonbridge Kent | England | British | 10315310003 | |||||
| WILLIAMS, Michael Owen | Amministratore | Fisher Green Binfield RG42 4EQ Bracknell 1 Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 198947630001 | |||||
| NOROSE LIMITED | Amministratore delegato nominato | Kempson House P.O. Box 570, Camomile Street EC3A 7AN London | 900006410001 | |||||||
| NORTON ROSE LIMITED | Amministratore delegato nominato | Kempson House P.O. Box 570, Camomile Street EC3A 7AN London | 900006420001 |
CPI BOOKMARQUE LTD ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Confirmatory guarantee & debenture | Creato il 10 dic 2009 Consegnato il 19 dic 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Security accession deed | Creato il 26 lug 2006 Consegnato il 02 ago 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Chattels mortgage | Creato il 20 lug 2000 Consegnato il 20 lug 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari One barco fastlane server platinum with accessories and ancillary equipment s/n HSBCAF3333001 for further details please refer to 395 and all and singular the chattels plant machinery and things described. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
CPI BOOKMARQUE LTD ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0