TTS SOHO LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTTS SOHO LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03782567
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TTS SOHO LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova TTS SOHO LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    16-19 Canada Square
    E14 5ER London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TTS SOHO LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    LONGSHOT HEALTH & FITNESS LIMITED01 giu 199901 giu 1999

    Quali sono gli ultimi bilanci di TTS SOHO LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per TTS SOHO LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Bilancio di micro-entità redatto al 31 dic 2020

    3 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 03 ago 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Iscrizione dell'ipoteca 037825670018, creata il 23 lug 2021

    22 pagineMR01

    Soddisfazione dell'onere 037825670016 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 037825670017 in pieno

    1 pagineMR04

    Cessazione della carica di Ian Charles Mahoney come amministratore in data 23 lug 2021

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 giu 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Modifica dei dettagli di Third Space Holdings Limited come persona con controllo significativo il 26 apr 2021

    2 paginePSC05

    Iscrizione dell'ipoteca 037825670017, creata il 02 ott 2020

    48 pagineMR01

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 giu 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di micro-entità redatto al 31 dic 2019

    3 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Third Space 16-19 Canada Square London E14 5ER England a 16-19 Canada Square London E14 5ER in data 04 lug 2019

    1 pagineAD01

    Bilancio di micro-entità redatto al 31 dic 2018

    2 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 giu 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    10 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 giu 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2016

    16 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 giu 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2015

    15 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da 16-19 Canada Square London E14 5ER England a C/O Third Space 16-19 Canada Square London E14 5ER in data 20 set 2016

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 01 giu 2016 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital06 giu 2016

    Stato del capitale al 06 giu 2016

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Cessazione della carica di Shirin Gandhi come amministratore in data 04 dic 2015

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di TTS SOHO LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PENNY, John
    Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5ER London
    16-19
    United Kingdom
    Amministratore
    Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5ER London
    16-19
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector192271210001
    SHAH, Samir
    Canada Square
    E14 5ER London
    16-19
    England
    Amministratore
    Canada Square
    E14 5ER London
    16-19
    England
    United KingdomBritishDirector106937280001
    WAGGETT, Colin Douglas
    Canada Square
    E14 5ER London
    16-19
    England
    Amministratore
    Canada Square
    E14 5ER London
    16-19
    England
    EnglandBritishDirector104154090003
    DUNMORE, Eric Maurice
    21 Golden Square
    W1F 9JN London
    Segretario
    21 Golden Square
    W1F 9JN London
    BritishChartered Accountant65297300003
    VIGORS, Oliver Richard
    20 Cranley Place
    SW7 3NH London
    Segretario
    20 Cranley Place
    SW7 3NH London
    BritishDirector21902980005
    ASHCROFT CAMERON SECRETARIES LIMITED
    4 Rivers House
    Fentiman Walk
    SG14 1DB Hertford
    Hertfordshire
    Segretario
    4 Rivers House
    Fentiman Walk
    SG14 1DB Hertford
    Hertfordshire
    62720590002
    OLSWANG COSEC LIMITED
    90 High Holborn
    WC1V 6XX London
    Seventh Floor
    Segretario
    90 High Holborn
    WC1V 6XX London
    Seventh Floor
    83864780002
    CADBURY, Joel Michael
    35 Lower Belgrave Street
    SW1W 0LS London
    Amministratore
    35 Lower Belgrave Street
    SW1W 0LS London
    EnglandBritishDirector21253350005
    DUNMORE, Eric Maurice
    Golden Square
    W1F 9JG London
    13
    Amministratore
    Golden Square
    W1F 9JG London
    13
    United KingdomBritishChartered Accountant65297300004
    FREUD, Matthew Rupert
    China Corner
    Blenheim Park
    OX20 1PR Woodstock
    Oxfordshire
    Amministratore
    China Corner
    Blenheim Park
    OX20 1PR Woodstock
    Oxfordshire
    EnglandBritishCompany Chairman64960840001
    GANDHI, Shirin
    Third Floor, Berners House, Berners Street
    W1T 3NF London
    47-48
    England
    Amministratore
    Third Floor, Berners House, Berners Street
    W1T 3NF London
    47-48
    England
    EnglandBritishAccoutant98443230002
    HAMBRO, Rupert Nicholas
    186 Ebury Street
    SW1W 8UP London
    Amministratore
    186 Ebury Street
    SW1W 8UP London
    EnglandBritishBanker74481160001
    MAHONEY, Ian Charles
    Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5ER London
    16-19
    United Kingdom
    Amministratore
    Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5ER London
    16-19
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector95388000002
    MALIN, Howard David
    2 Ladbroke Walk
    W11 3PW London
    Amministratore
    2 Ladbroke Walk
    W11 3PW London
    United KingdomBritishRestaurateur3777490001
    OMANA, Leslie Alexandra Iselin
    17 Woodsford Square
    W14 8DP London
    Amministratore
    17 Woodsford Square
    W14 8DP London
    BritishDirector69053720001
    ST GEORGE, Christopher Henry
    32 Davies Street
    W1K 4ND London
    Amministratore
    32 Davies Street
    W1K 4ND London
    BritishCompany Director85526130001
    VIGORS, Oliver Richard
    20 Cranley Place
    SW7 3NH London
    Amministratore
    20 Cranley Place
    SW7 3NH London
    BritishSales Director21902980005
    WISZOWATY, Nicholas Jan
    Parrocke Lodge
    West Drive
    GU25 4NA Virginia Water
    Surrey
    Amministratore
    Parrocke Lodge
    West Drive
    GU25 4NA Virginia Water
    Surrey
    EnglandBritishChief Executive53631880003
    ASHCROFT CAMERON NOMINEES LIMITED
    4 Rivers House
    Fentiman Walk
    SG14 1DB Hertford
    Hertfordshire
    Amministratore
    4 Rivers House
    Fentiman Walk
    SG14 1DB Hertford
    Hertfordshire
    64216970002

    Chi sono le persone con controllo significativo di TTS SOHO LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Third Space Group Limited
    Canada Square
    E14 5ER London
    16-19
    England
    06 apr 2016
    Canada Square
    E14 5ER London
    16-19
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneUk
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland
    Numero di registrazione02973240
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    TTS SOHO LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 23 lug 2021
    Consegnato il 02 ago 2021
    In corso
    Breve descrizione
    N/A.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • GRM2786 Limited (As Security Agent for the Secured Parties (as Defined in the Instrument))
    Transazioni
    • 02 ago 2021Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 02 ott 2020
    Consegnato il 09 ott 2020
    Soddisfatta integralmente
    Debitore che agisce come trustee nudo:
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 09 ott 2020Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 30 lug 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 24 ott 2014
    Consegnato il 05 nov 2014
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 05 nov 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 30 lug 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A deed of confirmation
    Creato il 29 gen 2009
    Consegnato il 10 feb 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from tts loans limited and any chargor to the trustees and the stockholders on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Graphite Capital Management LLP
    Transazioni
    • 10 feb 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 nov 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 1 august 2007
    Creato il 18 gen 2008
    Consegnato il 25 gen 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 25 gen 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 giu 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 18 gen 2008
    Consegnato il 31 gen 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from tts loans limited to the stockholder under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including bookdebts buildings fixtures fixed plant and machinery,. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Graphite Capital Management LLP as Trustee for Each Stockholder
    Transazioni
    • 31 gen 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 nov 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage of a life policy
    Creato il 18 gen 2008
    Consegnato il 25 gen 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All money including bonuses that has accrued or may become payable under the policy. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 25 gen 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 giu 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage of stocks and shares to secure own liabilities of a company
    Creato il 18 gen 2008
    Consegnato il 25 gen 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed security all those stocks shares bonds certificates of deposit bills of exchange depository receipts loan capital derivatives and other securities of any kind the benefit of all arrangements agreements undertakings or accounts all the rights and interests of the mortgagor in such securities and all allotments offers dividends and other distributions interest rights benefits and advantages arising at any time in relation to any such securities. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 25 gen 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 giu 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 18 gen 2008
    Consegnato il 25 gen 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 25 gen 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 giu 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 27 lug 2007
    Consegnato il 31 lug 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Longshot Limited
    Transazioni
    • 31 lug 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 ott 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Insurance assignment
    Creato il 21 mag 2004
    Consegnato il 05 giu 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Canada life p/no 3448917 (joel cadbury £250,000) term 5 years comm date 19 nov 1999; canada life p/no 3448915 (oliver vigors £250,000) term 5 years comm date 19 nov 1999.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 05 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 21 mag 2004
    Consegnato il 05 giu 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 05 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 29 nov 2002
    Consegnato il 04 dic 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The property - underlease dated 5/11/99 and supplemental underlease 5/11/99 as varied by a deed of variation dated 5/02/01 and a deed of variation dated 29/11/02, to the extent of the mortgagor's interest in the property or its proceeds of sale. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Longshot Hotles Limited
    Transazioni
    • 04 dic 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 gen 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 29 nov 2002
    Consegnato il 04 dic 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Longshot Hotels Limited
    Transazioni
    • 04 dic 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 gen 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 07 ago 2001
    Consegnato il 28 ago 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The l/h property k/a premises at the regent palace hotel annexe sherwood street and brewer street london W1.. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 28 ago 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 giu 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 22 dic 1999
    Consegnato il 11 gen 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Leasehold property k/a regent palace hotel annexe sherwood street and brewer street london W1. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 11 gen 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 giu 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 22 dic 1999
    Consegnato il 05 gen 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 05 gen 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 giu 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 05 nov 1999
    Consegnato il 12 nov 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under an underlease dated 5TH november 1999
    Brevi particolari
    Rent deposit of £660,000 and all other sums paid into the rent deposit account.
    Persone aventi diritto
    • Posthouse Hotels Limited
    Transazioni
    • 12 nov 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 lug 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0