FOUR SEASONS HEALTH CARE INVESTMENTS LIMITED

FOUR SEASONS HEALTH CARE INVESTMENTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàFOUR SEASONS HEALTH CARE INVESTMENTS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03782943
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di FOUR SEASONS HEALTH CARE INVESTMENTS LIMITED?

    • Altre attività di assistenza sanitaria (86900) / Attività sanitarie e di assistenza sociale

    Dove si trova FOUR SEASONS HEALTH CARE INVESTMENTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Norcliffe House
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di FOUR SEASONS HEALTH CARE INVESTMENTS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CAREER CAST LIMITED07 lug 199907 lug 1999
    SHELFCO (NO.1680) LIMITED04 giu 199904 giu 1999

    Quali sono gli ultimi bilanci di FOUR SEASONS HEALTH CARE INVESTMENTS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per FOUR SEASONS HEALTH CARE INVESTMENTS LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per FOUR SEASONS HEALTH CARE INVESTMENTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    14 pagineAA

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 05 ott 2015

    • Capitale: GBP 300
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio annuale redatto al 04 giu 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital15 giu 2015

    Stato del capitale al 15 giu 2015

    • Capitale: GBP 3,000,001
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Ian Richard Smith il 19 feb 2015

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Benjamin Robert Taberner il 18 feb 2015

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di Dominic Jude Kay come amministratore in data 28 ott 2014

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    15 pagineAA

    Cessazione della carica di Dominic Kay come segretario

    1 pagineTM02

    Nomina di Mrs Abigail Mattison come segretario

    2 pagineAP03

    Bilancio annuale redatto al 04 giu 2014 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital12 giu 2014

    Stato del capitale al 12 giu 2014

    • Capitale: GBP 3,000,001
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Maureen Claire Royston il 22 mag 2014

    2 pagineCH01

    Indirizzo della sede legale modificato da * Emerson Court Alderley Road Wilmslow Cheshire SK9 1NX* in data 21 feb 2014

    1 pagineAD01

    Nomina di Maureen Claire Royston come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Peter Calveley come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Ian Richard Smith come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    15 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 04 giu 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    15 pagineAA

    legacy

    14 pagineMG01

    Chi sono gli amministratori di FOUR SEASONS HEALTH CARE INVESTMENTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MATTISON, Abigail
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    United Kingdom
    Segretario
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    United Kingdom
    188573060001
    ROYSTON, Maureen Claire, Dr
    Alderley Road
    Wilmslow
    SK9 1NX Cheshire
    Emerson Court
    England
    England
    Amministratore
    Alderley Road
    Wilmslow
    SK9 1NX Cheshire
    Emerson Court
    England
    England
    United KingdomBritishCompany Director184190020002
    SMITH, Ian Richard
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    Amministratore
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    United KingdomBritishCompany Director181082310001
    TABERNER, Benjamin Robert
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    Amministratore
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    United KingdomBritishChartered Accountant150511890001
    BOLLAND, Martin Keith
    Flat 18 45 Marlborough Place
    St Johns Wood
    NW8 0PX London
    Segretario
    Flat 18 45 Marlborough Place
    St Johns Wood
    NW8 0PX London
    BritishPartner54898960001
    KAY, Dominic Jude
    4 Glyn Avenue
    WA15 9DG Hale
    Cheshire
    Segretario
    4 Glyn Avenue
    WA15 9DG Hale
    Cheshire
    BritishSolicitor145920530001
    MITCHELL, Nicholas John
    Lymbrook
    53 Dore Road Dore
    S17 3NA Sheffield
    South Yorkshire
    Segretario
    Lymbrook
    53 Dore Road Dore
    S17 3NA Sheffield
    South Yorkshire
    BritishDirector145102120001
    WILLIS, Graeme
    4 Woodbank
    Lynton Lane
    SK9 7NP Alderley Edge
    Cheshire
    Segretario
    4 Woodbank
    Lynton Lane
    SK9 7NP Alderley Edge
    Cheshire
    British71527500004
    E P S SECRETARIES LIMITED
    50 Stratton Street
    W1X 6NX London
    Segretario nominato
    50 Stratton Street
    W1X 6NX London
    900004930001
    ANSTEAD, Hamilton Douglas
    5 Heald Court
    34 Hawthorn Lane
    SK9 5DG Wilmslow
    Cheshire
    Amministratore
    5 Heald Court
    34 Hawthorn Lane
    SK9 5DG Wilmslow
    Cheshire
    BritishDirector107751890001
    BARNES, Robert Bruce
    19 Lewisham High Street
    Lewisham
    SE13 5AF London
    Amministratore
    19 Lewisham High Street
    Lewisham
    SE13 5AF London
    BritishPartner38841560002
    BOLLAND, Martin Keith
    Flat 18 45 Marlborough Place
    St Johns Wood
    NW8 0PX London
    Amministratore
    Flat 18 45 Marlborough Place
    St Johns Wood
    NW8 0PX London
    BritishPartner54898960001
    CALVELEY, Peter, Dr
    Canwick Hill
    Canwick
    LN4 2RF Lincoln
    The Old Vicarage
    Lincolnshire
    Amministratore
    Canwick Hill
    Canwick
    LN4 2RF Lincoln
    The Old Vicarage
    Lincolnshire
    United KingdomBritishCeo131468590001
    CROWE, Geoffrey Michael
    51 Oakwood Lane
    Bowdon
    WA14 3DL Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    51 Oakwood Lane
    Bowdon
    WA14 3DL Altrincham
    Cheshire
    BritishGroup Commercial Director38256680007
    HEYWOOD, Anthony George
    Harborough Hall Lane
    CO5 9UA Messing
    Harborough Hall
    Essex
    Amministratore
    Harborough Hall Lane
    CO5 9UA Messing
    Harborough Hall
    Essex
    EnglandBritishChief Executive131288260001
    KAY, Dominic Jude
    4 Glyn Avenue
    WA15 9DG Hale
    Cheshire
    Amministratore
    4 Glyn Avenue
    WA15 9DG Hale
    Cheshire
    United KingdomBritishSolicitor145920530001
    MITCHELL, Nicholas John
    Lymbrook
    53 Dore Road Dore
    S17 3NA Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    Lymbrook
    53 Dore Road Dore
    S17 3NA Sheffield
    South Yorkshire
    Great BritainBritishDirector145102120001
    WILLIS, Graeme
    4 Woodbank
    Lynton Lane
    SK9 7NP Alderley Edge
    Cheshire
    Amministratore
    4 Woodbank
    Lynton Lane
    SK9 7NP Alderley Edge
    Cheshire
    BritishFinancial Director71527500004
    MIKJON LIMITED
    50 Stratton Street
    W1X 5FL London
    Amministratore delegato nominato
    50 Stratton Street
    W1X 5FL London
    900004920001

    FOUR SEASONS HEALTH CARE INVESTMENTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 10 ago 2012
    Consegnato il 20 ago 2012
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due at any time of any member of the group to any creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 20 ago 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    A security deed
    Creato il 30 ott 2006
    Consegnato il 17 nov 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Credit Suisse London Branch
    Transazioni
    • 17 nov 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 lug 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Charge
    Creato il 16 set 2004
    Consegnato il 06 ott 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Its whole right, title, interest and benefit in and to the charged assets being the shares and all stocks, shares, warrants, securities, rights, moneys or property (including the dividends, interest or income thereon or therefrom) which may at any time accrue or be offered or arise by way of redemption, purchase, bonus, preference, option or otherwise in respect of or derived from any of the shares. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Scarlet Finance Limited
    Transazioni
    • 06 ott 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 16 set 2004
    Consegnato il 06 ott 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Its whole right, title, interest and benefit in and to the charged assets being the shares and all stocks, shares, warrants, securities, rights, moneys or property (including the dividends, interest or income thereon or therefrom) which may at any time accrue or be offered or arise by way of redemption, purchase, bonus, preference, option or otherwise in respect of or derived from any of the shares. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Scarlet Finance Limited
    Transazioni
    • 06 ott 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 16 set 2004
    Consegnato il 04 ott 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Scarlet Finance Limited
    Transazioni
    • 04 ott 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Share charge
    Creato il 01 ott 2002
    Consegnato il 16 ott 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of pledge all the subsidiary shares and investments and all corresponding distribution rights, both present and future, from time to time owned by it or in which it has an interest.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclay Bank PLC as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties
    Transazioni
    • 16 ott 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 ott 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 01 ago 2002
    Consegnato il 14 ago 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies or liabilities due or to become due from any charging company or any other obligor to the chargee as security trustee for itself and the other secured parties (the "security agent") on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 14 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 ott 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Am assignment agreement
    Creato il 16 lug 1999
    Consegnato il 21 lug 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities of carat secre PLC to the beneficiaries (as defined) under the finance documents (as defined) or any of them
    Brevi particolari
    All its rights,title and interest,present and future,in and to,and the benefit of the loan agreement and its right to receive sums thereunder.
    Persone aventi diritto
    • Morgan Stanley Mortgage Servicing LTD.as Security Trustee for the Beneficiaries
    Transazioni
    • 21 lug 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 lug 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0