CEDAR 2019 LIMITED
Panoramica
Nome della società | CEDAR 2019 LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 03783015 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | Sì |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di CEDAR 2019 LIMITED?
- Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni
Dove si trova CEDAR 2019 LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Frp Advisory Llp 2nd Floor 170 Edmund Street B3 2HB Birmingham |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di CEDAR 2019 LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
CARILLION CR LIMITED | 18 giu 2003 | 18 giu 2003 |
CARILLION (CHELVERTON) LIMITED | 08 dic 2000 | 08 dic 2000 |
CARILLION GROUP LIMITED | 01 giu 1999 | 01 giu 1999 |
Quali sono gli ultimi bilanci di CEDAR 2019 LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2016 |
Quali sono le ultime deposizioni per CEDAR 2019 LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 11 pagine | LIQ13 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 10 lug 2020 | 10 pagine | LIQ03 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 100 Dudley Road East Oldbury, Warley West Midlands B69 3DY United Kingdom a Frp Advisory Llp 2nd Floor 170 Edmund Street Birmingham B3 2HB in data 29 lug 2019 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 5 pagine | LIQ01 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 3 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 3 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Mr Lee Scott Richardson come amministratore in data 12 dic 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Martyn Ford Richardson come amministratore in data 12 dic 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Notifica di Crp Acquisitions Limited come persona con controllo significativo il 12 dic 2018 | 2 pagine | PSC02 | ||||||||||
Cessazione di Carillion Holdings Limited come persona con controllo significativo il 12 dic 2018 | 1 pagine | PSC07 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Crown House Birch Street Wolverhampton WV1 4JX United Kingdom a 100 Dudley Road East Oldbury, Warley West Midlands B69 3DY in data 14 dic 2018 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Lee James Mills come amministratore in data 12 dic 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Mark William Orriss come amministratore in data 12 dic 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Simon Paul Eastwood come amministratore in data 12 dic 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Simon Paul Eastwood il 01 ott 2018 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Lee James Mills il 01 ott 2018 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Carillion Holdings Limited come persona con controllo significativo il 01 ott 2018 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Carillion House 84 Salop Street Wolverhampton WV3 0SR a Crown House Birch Street Wolverhampton WV1 4JX in data 01 ott 2018 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Westley Maffei come segretario in data 11 set 2018 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Mark William Orriss il 25 giu 2018 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 giu 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Mark William Orriss il 08 gen 2018 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2016 | 12 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di CEDAR 2019 LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICHARDSON, Lee Scott | Amministratore | 2nd Floor 170 Edmund Street B3 2HB Birmingham Frp Advisory Llp | England | British | Company Director | 252168560001 | ||||
RICHARDSON, Martyn Ford | Amministratore | 2nd Floor 170 Edmund Street B3 2HB Birmingham Frp Advisory Llp | England | British | Company Director | 254167770001 | ||||
FITZHUGH, Dirk Olaf | Segretario | Beesdau House Mount Road Tettenhall Wood WV6 8HT Wolverhampton | British | 612090001 | ||||||
GEORGE, Timothy Francis | Segretario | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | British | 24075160004 | ||||||
MAFFEI, Westley | Segretario | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | 235181840001 | |||||||
CARILLION CONSTRUCTION NOMINEES LIMITED | Segretario | Birch Street WV1 4HY Wolverhampton | 79704800001 | |||||||
HACKWOOD SECRETARIES LIMITED | Segretario nominato | One Silk Street EC2Y 8HQ London | 900004790001 | |||||||
ADAM, Richard John | Amministratore | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | United Kingdom | British | Finance Director | 67133560004 | ||||
EASTWOOD, Simon Paul | Amministratore | Birch Street WV1 4JX Wolverhampton Crown House United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 35184590004 | ||||
GIRLING, Christopher Francis | Amministratore | 12 Spithead Close PO34 5AZ Seaview Isle Of Wight | British | Finance Director | 67125270002 | |||||
GREEN, Adam Richard | Amministratore | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | England | British | National Operations Director | 129918780001 | ||||
KHAN, Zafar Iqbal | Amministratore | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | England | British | Group Finance Director | 195408780001 | ||||
MCEWAN, Euan | Amministratore | 2 Bradshaw Close The Fairways PE28 4UZ Brampton Cambridgeshire | British | Chartered Accountant | 110597480001 | |||||
MILLS, Lee James | Amministratore | Birch Street WV1 4JX Wolverhampton Crown House United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 53951880001 | ||||
ORRISS, Mark William | Amministratore | 7-12 Tavistock Street WC1H 9LT London Lynton House, 2nd Floor United Kingdom | England | British | Development Director | 77169180001 | ||||
ROBINSON, Roger William | Amministratore | Applewood Barn Bank Road Little Witley WR6 6LS Worcester Worcestershire | British | Civil Engineer | 33421810001 | |||||
SHARPLES, Bernard John | Amministratore | Old Meadow Stockton Road WR6 6AT Abberley Worcestershire | United Kingdom | British | Chartered Engineer | 36242390003 | ||||
HACKWOOD DIRECTORS LIMITED | Amministratore delegato nominato | One Silk Street EC2Y 8HQ London | 900004840001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di CEDAR 2019 LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crp Acquisitions Limited | 12 dic 2018 | Dudley Road East B69 3DY Oldbury, Warley 100 West Midlands United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Carillion Holdings Limited | 06 apr 2016 | Birch Street WV1 4JX Wolverhampton Crown House United Kingdom | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
CEDAR 2019 LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Creato il 02 feb 2016 Consegnato il 20 feb 2016 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione Part of the land k/a nash farm nash road margate t/no. K944990FOR further details please refer to the instrument. L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Transfer deed | Creato il 07 mag 2010 Consegnato il 19 mag 2010 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Land on the north west side of haine road t/no:K258016. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 07 mag 2010 Consegnato il 17 mag 2010 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the borrower to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Land on the north west side of haine road haine t/no K258016. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 09 nov 2001 Consegnato il 16 nov 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever whether arising from an agreement in respect of regeneration investment grant dated 25TH june 2001 | |
Brevi particolari Property k/a land at high street blackwood together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery from time to time thereon. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Partnership debenture (the "debenture") between carillion (chelverton) limited, foxborough developments limited and richmond land UK limited together trading as the partnership known as cr chelverton properties (1) and the security trustee (as defined) (2) | Creato il 03 ago 2001 Consegnato il 17 ago 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The actual, contingent, present and/or future obligations and liabilities of the borrower under or pursuant to the financing documents (all terms as defined) | |
Brevi particolari By way of fixed charge all estates or interests in the property being the land and premises which are to be k/a the hambledon retail park, waterlooville and being the whole of the property comprised within t/ns HP257400, HP239776, HP425748, HP345639 and HP345395 and including also the bed of the part of the existing hambledon road which will revert to the company as frontager to the said road... See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
CEDAR 2019 LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0