OCTOBER PROPERTY INVESTMENTS LIMITED

OCTOBER PROPERTY INVESTMENTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàOCTOBER PROPERTY INVESTMENTS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03784813
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di OCTOBER PROPERTY INVESTMENTS LIMITED?

    • Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari

    Dove si trova OCTOBER PROPERTY INVESTMENTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di OCTOBER PROPERTY INVESTMENTS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BIRKBY INVESTMENTS LIMITED04 giu 199904 giu 1999

    Quali sono gli ultimi bilanci di OCTOBER PROPERTY INVESTMENTS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per OCTOBER PROPERTY INVESTMENTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Avviso di passaggio da amministrazione a dissoluzione in data 07 nov 2013

    20 pagine2.35B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 19 mag 2013

    19 pagine2.24B

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    1 pagineF2.18

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B

    6 pagine2.16B

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    27 pagine2.17B

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O King Loose St John's Parade 5 South Parade Summertown Oxford OX2 7JL in data 30 nov 2012

    2 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    legacy

    6 pagineLQ01

    Bilancio annuale redatto al 31 mar 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital26 apr 2012

    Stato del capitale al 26 apr 2012

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 giu 2011

    8 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Noel Martin Smyth il 04 nov 2011

    2 pagineCH01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 giu 2010

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 mar 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Nomina di Alannah Smyth come segretario

    2 pagineAP03

    Nomina di Bryan Lawlor come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Bryan Lawlor come segretario

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di John Mckenna come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 31 mar 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 giu 2009

    7 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine288c

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 giu 2008

    9 pagineAA

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    4 pagine363a

    Chi sono gli amministratori di OCTOBER PROPERTY INVESTMENTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SMYTH, Alannah
    Portobello Road
    Dublin 8
    29
    Ireland
    Segretario
    Portobello Road
    Dublin 8
    29
    Ireland
    154679490001
    KINNAIRD, Nigel John
    14 Magheraconluce Lane
    BT26 6PT Hillsborough
    County Down
    Amministratore
    14 Magheraconluce Lane
    BT26 6PT Hillsborough
    County Down
    Northern IrelandBritish83042830001
    LAWLOR, Bryan
    Coolamber Court
    Knocklyon Road
    Dublin 16
    17
    Ireland
    Amministratore
    Coolamber Court
    Knocklyon Road
    Dublin 16
    17
    Ireland
    IrelandIrish154652750001
    SMYTH, Noel Martin
    25 Tooting Bec Road
    SW17 8BY London
    Flat 7
    England
    Amministratore
    25 Tooting Bec Road
    SW17 8BY London
    Flat 7
    England
    IrelandIrish91238420002
    DIGHTON, Simon Gerald
    28 Lightwoods Hill
    Bearwood
    B67 5EA Warley
    West Midlands
    Segretario
    28 Lightwoods Hill
    Bearwood
    B67 5EA Warley
    West Midlands
    British78151560001
    DRYSDALE, Clive Douglas
    22 Laburnham Road
    SL6 4DB Maidenhead
    Berkshire
    Segretario
    22 Laburnham Road
    SL6 4DB Maidenhead
    Berkshire
    British45345090002
    DUDLEY, Martin Paul
    Horsebrook House
    51 Old Farm Drive
    WV8 1GF Codsall
    Wolverhampton
    Segretario
    Horsebrook House
    51 Old Farm Drive
    WV8 1GF Codsall
    Wolverhampton
    British93516350001
    GIBSON, Jacqueline
    7 Manor Court
    Beech Road Headington
    OX3 7SD Oxford
    Oxfordshire
    Segretario
    7 Manor Court
    Beech Road Headington
    OX3 7SD Oxford
    Oxfordshire
    British84250850001
    GRADUS, Vicki Doreen
    99 Deacons Hill Road
    Elstree
    WD6 3JF Borehamwood
    Hertfordshire
    Segretario
    99 Deacons Hill Road
    Elstree
    WD6 3JF Borehamwood
    Hertfordshire
    British60427810001
    LAWLOR, Bryan William
    Coolamber Court
    Knocklyon Road
    21
    Dublin 16
    Republic Of Ireland
    Segretario
    Coolamber Court
    Knocklyon Road
    21
    Dublin 16
    Republic Of Ireland
    Irish154652750014
    BEER, Paul Allan
    Oaklands 14 Sandy Lodge Way
    HA6 2AJ Northwood
    Middlesex
    Amministratore
    Oaklands 14 Sandy Lodge Way
    HA6 2AJ Northwood
    Middlesex
    British6436770001
    CRAN, William Michael
    16 Colne Valley Business Park
    Linthwaite
    HD7 5QG Huddersfield
    West Yorkshire
    Amministratore
    16 Colne Valley Business Park
    Linthwaite
    HD7 5QG Huddersfield
    West Yorkshire
    British64725130001
    DIGHTON, Simon Gerald
    28 Lightwoods Hill
    Bearwood
    B67 5EA Warley
    West Midlands
    Amministratore
    28 Lightwoods Hill
    Bearwood
    B67 5EA Warley
    West Midlands
    United KingdomBritish78151560001
    DRYSDALE, Clive Douglas
    22 Laburnham Road
    SL6 4DB Maidenhead
    Berkshire
    Amministratore
    22 Laburnham Road
    SL6 4DB Maidenhead
    Berkshire
    British45345090002
    DUDLEY, Martin Paul
    Horsebrook House
    51 Old Farm Drive
    WV8 1GF Codsall
    Wolverhampton
    Amministratore
    Horsebrook House
    51 Old Farm Drive
    WV8 1GF Codsall
    Wolverhampton
    United KingdomBritish93516350001
    GWYN JONES, Henry Alexander
    4 Rue Desaix
    Paris
    75008
    France
    Amministratore
    4 Rue Desaix
    Paris
    75008
    France
    British69720680007
    KIRKWOOD, Stuart Watson
    The Granary Malthouse Farm
    Evesham Road Cookhill
    B49 5LJ Alcester
    Warwickshire
    Amministratore
    The Granary Malthouse Farm
    Evesham Road Cookhill
    B49 5LJ Alcester
    Warwickshire
    British76937270002
    KUELSHEIMER, Leslie Claude
    55 Foscote Road
    Hendon
    NW4 3SE London
    Amministratore
    55 Foscote Road
    Hendon
    NW4 3SE London
    British7163440001
    MCKENNA, John
    34 Brighton Square Rathgar
    IRISH Dublin 6
    Republic Of Ireland
    Amministratore
    34 Brighton Square Rathgar
    IRISH Dublin 6
    Republic Of Ireland
    IrelandIrish116525480001
    MELVILLE, Stephen
    31 West Hill Way
    N20 8QX London
    Amministratore
    31 West Hill Way
    N20 8QX London
    SpainBritish50085870002
    SMITH, Nicholas Paul
    Scrag Oak
    TN5 6NP Wadhurst
    Sussex
    Amministratore
    Scrag Oak
    TN5 6NP Wadhurst
    Sussex
    United KnigdomBritish32981540001
    STOCK, Maurice David John
    Weymouth Avenue
    Mill Hill
    NW7 3JD London
    11
    Amministratore
    Weymouth Avenue
    Mill Hill
    NW7 3JD London
    11
    EnglandBritish42738500001
    TAYLOR-SMITH, Kim David Spencer
    White Lodge
    338 Upper Richmond Road
    SW15 6TL London
    Amministratore
    White Lodge
    338 Upper Richmond Road
    SW15 6TL London
    British78391680002

    OCTOBER PROPERTY INVESTMENTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 28 set 2007
    Consegnato il 06 ott 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and each borrower to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property known as lonsdale house 52 blucher street birmingham t/n WK162153, fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled share capital buildings and fixtures,. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nm Rothschild & Sons Limited
    Transazioni
    • 06 ott 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 22 feb 2007
    Consegnato il 08 mar 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The mortgaged property being lonsdale house, 52 blucher st, birmingham t/no WK162153. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Abn Amro Trustees Limited, as Security Trustee for Each of the Finance Parties
    Transazioni
    • 08 mar 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Subordination agreement
    Creato il 22 feb 2007
    Consegnato il 08 mar 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Under the subordination agreement, if: any obligor makes any payment in cash or in kind on account of, or for the purchase or other acquisition of, all or any part of the junior liabilities; or the company receives all or any amount in cash or in kind of the junior liabilities:. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • N M Rothschild & Sons Limited as Agent for the Finance Parties
    Transazioni
    • 08 mar 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture with floating charge
    Creato il 22 feb 2007
    Consegnato il 08 mar 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first legal mortgage the mortgaged property, assignment any rental income, insurance policies, the hedge documents, fixed charges the real property, the property account, the gic account, book and other debts, goodwill and uncalled share capital, scottish property, scottish shares, jersey shares, floating charge all assets and undertaking. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Abn Amro Trustees Limited as Security Trustee for Each of the Finance Parties
    Transazioni
    • 08 mar 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 117 mag 2012Nomina di un amministratore o gestore (LQ01)
      • Numero di pratica 1
    Debenture with floating charge
    Creato il 29 set 2005
    Consegnato il 10 ott 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the lender on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a lonsdale house 52 blucher street birmingham t/n wk 162153 the shares and all its present and future investments rental income insurace policies goodwill by way of floating charge all present and future assets and undertaking. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nm Rothschild & Sons Limited
    Transazioni
    • 10 ott 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture with floating charge
    Creato il 29 set 2005
    Consegnato il 10 ott 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the lender and/or the security trustee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a lonsdale house 52 blucher street birmingham t/n WK162153 right title and interest to, in and under all agreements contracts deeds licences undertakings guarantees covenants warranties rental income insurance policies. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Capita Trust Company Limited (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 10 ott 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 05 nov 1999
    Consegnato il 17 nov 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the company's undertaking property and other assets of whatever nature. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transazioni
    • 17 nov 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 ott 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    OCTOBER PROPERTY INVESTMENTS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1Ricevitore/gestore nominato
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Kevin Peter Mersh
    20 Grosvenor Hill
    Berkeley Square
    W1K 3HQ London
    United Kingdom
    Ricevitore/gestore
    20 Grosvenor Hill
    Berkeley Square
    W1K 3HQ London
    United Kingdom
    Julian Marshal Clarke
    20 Grosvenor Hill
    Berkeley Square
    W1K 3HQ London
    Ricevitore/gestore
    20 Grosvenor Hill
    Berkeley Square
    W1K 3HQ London
    2
    DataTipo
    20 nov 2012Inizio dell'amministrazione
    07 nov 2013Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Simon Robert Thomas
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    Praticante
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    Shelley Bullman
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    Praticante
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0