HAYLING ISLAND HOLIDAY PARK LIMITED

HAYLING ISLAND HOLIDAY PARK LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHAYLING ISLAND HOLIDAY PARK LIMITED
    Stato della societàIn amministrazione
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03788057
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di HAYLING ISLAND HOLIDAY PARK LIMITED?

    • Campeggi e aree di sosta per veicoli ricreativi (55300) / Attività di alloggio e di ristorazione

    Dove si trova HAYLING ISLAND HOLIDAY PARK LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    11th Floor Landmark St Peter's Square
    M1 4PB 1 Oxford St
    Manchester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HAYLING ISLAND HOLIDAY PARK LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HIGWORTH CARAVAN PARK LIMITED11 giu 199911 giu 1999

    Quali sono gli ultimi bilanci di HAYLING ISLAND HOLIDAY PARK LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 mar 2023
    Scadenza dei prossimi bilanci il31 dic 2023
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2021

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per HAYLING ISLAND HOLIDAY PARK LIMITED?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al25 mar 2024
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma08 apr 2024
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al25 mar 2023
    Scaduto

    Quali sono le ultime deposizioni per HAYLING ISLAND HOLIDAY PARK LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    31 pagineAM10
    YDX6P0MQ

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    49 pagineAM10
    YDB1MDE8

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    3 pagineAM19
    YD340XSA

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    49 pagineAM10
    YCXXD5O0

    Dichiarazione delle attività con il modulo AM02SOA

    10 pagineAM02
    YCGZ6T2Z

    Cessazione della carica di Stephen Charles Broome come amministratore in data 19 set 2023

    1 pagineTM01
    ACCXN9SX

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    3 pagineAM06
    YCC3WJPK

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    165 pagineAM03
    YCAWVZJD

    Indirizzo della sede legale modificato da Royale House 1550 Parkway Whiteley Fareham PO15 7AG England a 11th Floor Landmark St Peter's Square 1 Oxford Street Manchester M1 4PB in data 19 ago 2023

    2 pagineAD01
    YC9NQ4MH

    Nomina di un amministratore

    3 pagineAM01
    YC9NS4OI

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Memorandum e Statuto

    25 pagineMA
    AC7Q00P6

    Cessazione della carica di Robert Lee Jack Bull come amministratore in data 07 lug 2023

    1 pagineTM01
    AC7Q00U1

    Cessazione della carica di Jason Mark Williams come amministratore in data 07 lug 2023

    1 pagineTM01
    AC7Q00SH

    Nomina di Mr Stephen Charles Broome come amministratore in data 07 lug 2023

    2 pagineAP01
    AC7Q00OY

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 gen 2023 al 31 mar 2023

    1 pagineAA01
    XC5JEFK8

    Dichiarazione di conformità presentata il 25 mar 2023 con aggiornamenti

    4 pagineCS01
    XC0PAC41

    Nomina di Mr Jason Mark Williams come amministratore in data 11 lug 2022

    2 pagineAP01
    XB8ASOY0

    Iscrizione dell'ipoteca 037880570011, creata il 14 lug 2022

    63 pagineMR01
    XB888EKB

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 dic 2022 al 31 gen 2023

    1 pagineAA01
    XB73MWPE

    Dichiarazione di conformità presentata il 25 mar 2022 con aggiornamenti

    5 pagineCS01
    XB0JF717

    I registri sono stati trasferiti all'indirizzo della sede legale registrata Royale House 1550 Parkway Whiteley Fareham PO15 7AG

    1 pagineAD04
    XB0E2L17

    Modifica dei dettagli di Royale Resorts 2 Limited come persona con controllo significativo il 22 mar 2022

    2 paginePSC05
    XB0B67YX

    Soddisfazione dell'onere 037880570009 in pieno

    1 pagineMR04
    XAZ9LMBD

    Indirizzo della sede legale modificato da 2nd Floor One Gosforth Park Way Gosforth Business Park Newcastle upon Tyne NE12 8ET a Royale House 1550 Parkway Whiteley Fareham PO15 7AG in data 02 mar 2022

    1 pagineAD01
    XAYYV3GY

    Chi sono gli amministratori di HAYLING ISLAND HOLIDAY PARK LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ARCHIBOLD, Judith Ann
    2nd Floor One Gosforth Park Way
    Gosforth Business Park
    NE12 8ET Newcastle Upon Tyne
    Segretario
    2nd Floor One Gosforth Park Way
    Gosforth Business Park
    NE12 8ET Newcastle Upon Tyne
    BritishCompany Secretary85878920001
    CAMERON, Rachel
    37a Blatchington Road
    BN3 3YL Hove
    East Sussex
    Segretario
    37a Blatchington Road
    BN3 3YL Hove
    East Sussex
    British55897150002
    EDWARDS, Dorothy Jean
    19 Victoria Avenue
    PO11 9AJ Hayling Island
    Hampshire
    Segretario
    19 Victoria Avenue
    PO11 9AJ Hayling Island
    Hampshire
    British70695820001
    PARSONS, Robert John
    10 Mannings Meadow
    TQ13 9SA Bovey Tracey
    Devon
    Segretario
    10 Mannings Meadow
    TQ13 9SA Bovey Tracey
    Devon
    BritishAccountant113210820001
    TYE, David Grant
    Westways Coombeshead Cross
    Chudleigh
    TQ13 0NF Newton Abbot
    Devon
    Segretario
    Westways Coombeshead Cross
    Chudleigh
    TQ13 0NF Newton Abbot
    Devon
    BritishFinance Director2666640001
    THEYDON SECRETARIES LIMITED
    25 Hill Road
    Theydon Bois
    CM16 7LX Epping
    Essex
    Segretario nominato
    25 Hill Road
    Theydon Bois
    CM16 7LX Epping
    Essex
    900011300001
    BAMSEY, Darrin
    2nd Floor One Gosforth Park Way
    Gosforth Business Park
    NE12 8ET Newcastle Upon Tyne
    Amministratore
    2nd Floor One Gosforth Park Way
    Gosforth Business Park
    NE12 8ET Newcastle Upon Tyne
    United KingdomBritishDirector123369200006
    BROOME, Stephen Charles
    Great Portland Street
    1st Floor
    W1W 7LT London
    85
    United Kingdom
    Amministratore
    Great Portland Street
    1st Floor
    W1W 7LT London
    85
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director35775280005
    BULL, Ian Alan
    One Gosforth Park Way
    Gosforth Business Park
    NE12 8ET Newcastle Upon Tyne
    2nd Floor
    England
    Amministratore
    One Gosforth Park Way
    Gosforth Business Park
    NE12 8ET Newcastle Upon Tyne
    2nd Floor
    England
    EnglandBritishDirector210299090001
    BULL, Robert Lee Jack
    1550 Parkway
    PO15 7AG Whiteley
    Royale House
    Fareham
    England
    Amministratore
    1550 Parkway
    PO15 7AG Whiteley
    Royale House
    Fareham
    England
    EnglandBritishDirector240346910002
    EDWARDS, Dennis
    19 Victoria Avenue
    PO11 9AJ Hayling Island
    Hampshire
    Amministratore
    19 Victoria Avenue
    PO11 9AJ Hayling Island
    Hampshire
    BritishDirector70695810001
    EDWARDS, Dorothy Jean
    Apple Tree Lodge
    19 Victoria Avenue
    PO11 9AJ Hayling Island
    Hampshire
    Amministratore
    Apple Tree Lodge
    19 Victoria Avenue
    PO11 9AJ Hayling Island
    Hampshire
    BritishDirector73321330001
    EDWARDS, Martin John
    34 South Road
    PO11 9AE Hayling Island
    Hampshire
    Amministratore
    34 South Road
    PO11 9AE Hayling Island
    Hampshire
    BritishHoliday Park Man68029090001
    EDWARDS, Martin John
    34 South Road
    PO11 9AE Hayling Island
    Hampshire
    Amministratore
    34 South Road
    PO11 9AE Hayling Island
    Hampshire
    BritishHoliday Park68029090001
    KELLETT, Ian
    2nd Floor One Gosforth Park Way
    Gosforth Business Park
    NE12 8ET Newcastle Upon Tyne
    Amministratore
    2nd Floor One Gosforth Park Way
    Gosforth Business Park
    NE12 8ET Newcastle Upon Tyne
    United KingdomBritishDirector248308000001
    MCDONNELL, Bernard Neillus
    16 Malone Valley Park
    BT9 5PZ Belfast
    County Antrim
    Amministratore
    16 Malone Valley Park
    BT9 5PZ Belfast
    County Antrim
    Northern IrelandIrishDirector123369120001
    PARSONS, Robert John
    10 Mannings Meadow
    TQ13 9SA Bovey Tracey
    Devon
    Amministratore
    10 Mannings Meadow
    TQ13 9SA Bovey Tracey
    Devon
    BritishAccountant113210820001
    RICHARDS, Stephen
    2nd Floor One Gosforth Park Way
    Gosforth Business Park
    NE12 8ET Newcastle Upon Tyne
    Amministratore
    2nd Floor One Gosforth Park Way
    Gosforth Business Park
    NE12 8ET Newcastle Upon Tyne
    EnglandBritishCompany Director187618040002
    TAAFFE, Rachael Claire
    Rise Two
    Harris Lane Abbots Leigh
    BS8 3QX Bristol
    Amministratore
    Rise Two
    Harris Lane Abbots Leigh
    BS8 3QX Bristol
    EnglandBritishManaging Director103945340002
    TYE, David Grant
    Westways Coombeshead Cross
    Chudleigh
    TQ13 0NF Newton Abbot
    Devon
    Amministratore
    Westways Coombeshead Cross
    Chudleigh
    TQ13 0NF Newton Abbot
    Devon
    EnglandBritishFinance Director2666640001
    WATERWORTH, John Anthony
    2nd Floor One Gosforth Park Way
    Gosforth Business Park
    NE12 8ET Newcastle Upon Tyne
    Amministratore
    2nd Floor One Gosforth Park Way
    Gosforth Business Park
    NE12 8ET Newcastle Upon Tyne
    United KingdomBritishDirector203710900001
    WILLIAMS, Jason Mark
    1550 Parkway
    PO15 7AG Whiteley
    Royale House
    Fareham
    England
    Amministratore
    1550 Parkway
    PO15 7AG Whiteley
    Royale House
    Fareham
    England
    EnglandBritishDirector194866870003
    WILMOT, Michael John
    2nd Floor One Gosforth Park Way
    Gosforth Business Park
    NE12 8ET Newcastle Upon Tyne
    Amministratore
    2nd Floor One Gosforth Park Way
    Gosforth Business Park
    NE12 8ET Newcastle Upon Tyne
    United KingdomBritishAccountant91108150004
    THEYDON NOMINEES LIMITED
    25 Hill Road
    Theydon Bois
    CM16 7LX Epping
    Essex
    Amministratore delegato nominato
    25 Hill Road
    Theydon Bois
    CM16 7LX Epping
    Essex
    900010330001

    Chi sono le persone con controllo significativo di HAYLING ISLAND HOLIDAY PARK LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Royale Resorts 2 Limited
    1550 Parkway
    PO15 7AG Whiteley
    Royale House
    Fareham
    England
    01 mar 2022
    1550 Parkway
    PO15 7AG Whiteley
    Royale House
    Fareham
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneRegistrar Of Companies (England And Wales)
    Numero di registrazione13722033
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    One Gosforth Park Way
    Gosforth Business Park
    NE12 8ET Newcastle Upon Tyne
    2nd Floor
    United Kingdom
    21 dic 2017
    One Gosforth Park Way
    Gosforth Business Park
    NE12 8ET Newcastle Upon Tyne
    2nd Floor
    United Kingdom
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione05729731
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    One Gosforth Park Way
    Gosforth Business Park
    NE12 8ET Newcastle Upon Tyne
    2nd Floor
    United Kingdom
    06 apr 2016
    One Gosforth Park Way
    Gosforth Business Park
    NE12 8ET Newcastle Upon Tyne
    2nd Floor
    United Kingdom
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland & Wales
    Autorità legaleEnglish Law
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione05333927
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    HAYLING ISLAND HOLIDAY PARK LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 14 lug 2022
    Consegnato il 14 lug 2022
    In corso
    Breve descrizione
    The land and buildings known as hayling island holiday park, manor road, hayling island which comprises the following properties: (a) higworth caravan park, manor road, hayling island PO11 0QS and registered at hm land registry with title number HP455398 and (b) higworth farm, hayling island and registered at hm land registry with title number HP455397 and other properties as listed in the instrument.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Glas Trust Corporation Limited
    Transazioni
    • 14 lug 2022Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 01 mar 2022
    Consegnato il 02 mar 2022
    In corso
    Breve descrizione
    The land and buildings known as hayling island holiday park, manor road, hayling island which comprises several properties as listed in schedule 1 of the instrument.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Glas Trust Corporation Limited
    Transazioni
    • 02 mar 2022Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 01 giu 2017
    Consegnato il 07 giu 2017
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Real estate in the form of hayling island holiday park, hayling island hampshire PO11 0QS with title number SH17565. For more details please refer to the instrument.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (And Its Successors in Title and Permitted Transferees)
    Transazioni
    • 07 giu 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 07 mar 2022Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 13 nov 2015
    Consegnato il 16 nov 2015
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Hayling island holiday park hayling island t/no HP455398 please see image for details of further land (including buildings), ship, aircraft or intellectual property charged.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (And Its Successors in Title and Permitted Transferees)
    Transazioni
    • 16 nov 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 24 apr 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 28 mar 2014
    Consegnato il 04 apr 2014
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Land being hayling island holiday park hayling island hayling island t/nos HP455398, HP455397, SH10768, SH11578, SH12236 & SH17565 intellectual property including tm 2392814, tm 2603583, tm 2604489 & tm 2604490 please see image for details of further land (including buildings), ship, aircraft or intellectual property charged.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Ares Management Limited (In Its Capacity as Security Trustee for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 04 apr 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 13 nov 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 21 ago 2007
    Consegnato il 22 ago 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    For details of property`s charged please. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 22 ago 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 nov 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 07 nov 2005
    Consegnato il 22 nov 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC, as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties(The Security Trustee)
    Transazioni
    • 22 nov 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 ago 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 22 dic 2004
    Consegnato il 29 dic 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a higworth caravan park, manor road, hayling island, havant t/n HP455398. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 29 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 22 dic 2004
    Consegnato il 29 dic 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 29 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 07 dic 2000
    Consegnato il 11 dic 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 11 dic 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 ott 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 07 dic 2000
    Consegnato il 11 dic 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a higworth caravan park manor road hayling island hampshire t/no HP455397 HP455398. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 11 dic 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 ott 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    HAYLING ISLAND HOLIDAY PARK LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    09 ago 2023Inizio dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Daniel Robert Whiteley Smith
    30 Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    Praticante
    30 Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    Oliver Haunch
    30 Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    Praticante
    30 Finsbury Square
    EC2A 1AG London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0