CASTLEGATE 796 LIMITED
Panoramica
Nome della società | CASTLEGATE 796 LIMITED |
---|---|
Stato della società | Liquidazione |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 03792812 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | Sì |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di CASTLEGATE 796 LIMITED?
- Altre attività di costruzione specializzate n.c.a. (43999) / Costruzioni
Dove si trova CASTLEGATE 796 LIMITED?
Indirizzo della sede legale | 4th Floor Abbey House 32 Booth Street M2 4AB Manchester |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di CASTLEGATE 796 LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
ANSA UTILITIES LIMITED | 23 giu 2006 | 23 giu 2006 |
ACTIVE SERVICES GROUP LIMITED | 21 giu 1999 | 21 giu 1999 |
Quali sono gli ultimi bilanci di CASTLEGATE 796 LIMITED?
Scaduto | Sì |
---|---|
Prossimi bilanci | |
Fine del prossimo esercizio al | 30 apr 2021 |
Scadenza dei prossimi bilanci il | 30 apr 2022 |
Ultimi bilanci | |
Ultimi bilanci redatti al | 30 apr 2020 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per CASTLEGATE 796 LIMITED?
Scaduto | Sì |
---|---|
Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 21 giu 2023 |
Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 05 lug 2023 |
Ultima dichiarazione di conferma | |
Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 21 giu 2022 |
Scaduto | Sì |
Quali sono le ultime deposizioni per CASTLEGATE 796 LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 12 dic 2024 | 19 pagine | LIQ03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Gold Round Limited come amministratore in data 26 set 2024 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 12 dic 2023 | 21 pagine | LIQ03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Stuart Pace come amministratore in data 14 dic 2022 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 3 pagine | 600 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 4th Floor 24 Old Bond Street Mayfair London W1S 4AW United Kingdom a 4th Floor Abbey House 32 Booth Street Manchester M2 4AB in data 09 gen 2023 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione delle attività | 8 pagine | LIQ02 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Ground Floor, Egerton House 68 Baker Street Weybridge Surrey KT13 8AL United Kingdom a 4th Floor 24 Old Bond Street Mayfair London W1S 4AW in data 06 gen 2023 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 21 giu 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Gold Round Limited come persona con controllo significativo il 25 lug 2022 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Gold Round Limited il 25 lug 2022 | 1 pagine | CH02 | ||||||||||
Parte della proprietà o attività è stata liberata e non fa più parte dell'onere 037928120009 | 5 pagine | MR05 | ||||||||||
Parte della proprietà o attività è stata liberata e non fa più parte dell'onere 037928120013 | 5 pagine | MR05 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 037928120011 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 037928120012 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Certificato di cambio di nome Company name changed ansa utilities LIMITED\certificate issued on 10/06/22 | 3 pagine | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Stuart Pace il 21 lug 2021 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 21 giu 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 apr 2020 | 28 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Alan Albert Horton come amministratore in data 30 giu 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Stuart Pace il 29 giu 2020 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 21 giu 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Gold Round Limited come persona con controllo significativo il 18 apr 2016 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 apr 2019 | 28 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di CASTLEGATE 796 LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RJP SECRETARIES LIMITED | Segretario | 68 Baker Street KT13 8AL Weybridge Ground Floor, Egerton House Surrey United Kingdom |
| 61999120002 | ||||||||||
BOYES, Stephen | Segretario | Grassdale Cottage Valley Road, Houghton Bottoms PR5 0SD Preston Lancashire | British | Accouantant | 78387220001 | |||||||||
DAVIS, Peter Nicholas | Segretario | 35 Chatsworth Road Eccles M30 9DZ Manchester Lancashire | British | Director | 29902470001 | |||||||||
DICKINSON, Louise | Segretario | Fulwood Park Caxton Road Fulwood PR2 9NZ Preston 6 Lancashire United Kingdom | British | Company Director | 139480580001 | |||||||||
GRAEME, Dorothy May | Segretario nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | 900001330001 | ||||||||||
MCINNES, Timothy Ian | Segretario | 34 Cumberland Drive Bowdon WA14 3QP Altrincham Cheshire | British | Chartered Accountant | 108973030002 | |||||||||
WATKINS, Steven James | Segretario | Roscownans Old Kea TR3 6AX Truro Cornwall | British | Director | 127928260001 | |||||||||
BARRETT, John | Amministratore | Fulwood Park Caxton Road Fulwood PR2 9NZ Preston 6 Lancashire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 118475070001 | ||||||||
BROOK, Philip John | Amministratore | 8 Hillside Drive BH23 2RU Christchurch Dorset | British | Director | 64789650001 | |||||||||
DAVIS, Peter Nicholas | Amministratore | 35 Chatsworth Road Eccles M30 9DZ Manchester Lancashire | England | British | Director | 29902470001 | ||||||||
DICKINSON, Louise | Amministratore | Fulwood Park Caxton Road Fulwood PR2 9NZ Preston 6 Lancashire United Kingdom | England | British | Company Director | 139480580001 | ||||||||
GRAEME, Lesley Joyce | Amministratore delegato nominato | 61 Fairview Avenue ME8 0QP Gillingham Kent | British | 900001320001 | ||||||||||
HORTON, Alan Albert | Amministratore | 68 Baker Street KT13 8AL Weybridge Ground Floor, Egerton House Surrey United Kingdom | England | British | Director | 182208240001 | ||||||||
LEE, Peter Francis | Amministratore | Fulwood Park Caxton Road Fulwood PR2 9NZ Preston 6 Lancashire United Kingdom | United Kingdom | British | Finance Director | 207608120001 | ||||||||
LEES, Stuart | Amministratore | Fulwood Park Caxton Road Fulwood PR2 9NZ Preston 6 Lancashire United Kingdom | England | British | Director | 70032700001 | ||||||||
LLOYD JONES, Andrew Mark | Amministratore | Fulwood Park Caxton Road Fulwood PR2 9NZ Preston 6 Lancashire United Kingdom | England | British | Company Director | 180809810001 | ||||||||
MAHONEY, Kevin David | Amministratore | 6 Ferrymans Quay William Morris Way SW6 2UT London | United Kingdom | British | Company Director | 63238350002 | ||||||||
MAUDE, Simon David | Amministratore | The Main Hall Rufford Park Lane Rufford L40 1XE Ormskirk 1 Lancashire | United Kingdom | British | Director | 89719660003 | ||||||||
MCINNES, Timothy Ian | Amministratore | 34 Cumberland Drive Bowdon WA14 3QP Altrincham Cheshire | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 108973030002 | ||||||||
PACE, Stuart | Amministratore | Abbey House 32 Booth Street M2 4AB Manchester 4th Floor | England | British | Director | 207506130003 | ||||||||
POLLARD, Niall Mackinlay | Amministratore | Fulwood Park Caxton Road Fulwood PR2 9NZ Preston 6 Lancashire United Kingdom | England | British | Director | 176786520001 | ||||||||
SMITH, Andrew John | Amministratore | High Street KT7 0SR Thames Ditton 2 A C Court Surrey England | England | British | Director | 207506140001 | ||||||||
TURNER, Paul Leslie | Amministratore | Netherlaw Greendale Lane SK10 4AY Mottram St Andrew Cheshire | British | Director | 72964390004 | |||||||||
VINCENT, Michael | Amministratore | 23 Saint Aubyns's Avenue SW19 7BL London | England | British | Finance Director | 99258270001 | ||||||||
WATKINS, Steven James | Amministratore | Park Crescent TR11 2DL Falmouth 1 Cornwall United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 127928260002 | ||||||||
WATKINS, Steven James | Amministratore | Roscownans Old Kea TR3 6AX Truro Cornwall | British | Director | 127928260001 | |||||||||
GOLD ROUND LIMITED | Amministratore | 24 Old Bond Street Mayfair W1S 4AW London 4th Floor United Kingdom |
| 149588400001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di CASTLEGATE 796 LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold Round Limited | 18 apr 2016 | 24 Old Bond Street Mayfair W1S 4AW London 4th Floor United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Gold Round Limited | 06 apr 2016 | 24 Old Bond Street Mayfair W1S 4AW London 5th Floor United Kingdom | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Iguk Support Services Limited | 06 apr 2016 | 68 Baker Street KT13 8AL Weybridge Ground Floor, Egerton House Surrey United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
CASTLEGATE 796 LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Creato il 01 set 2016 Consegnato il 13 set 2016 | In corso | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 03 giu 2016 Consegnato il 20 giu 2016 | Soddisfatta integralmente | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 03 giu 2016 Consegnato il 17 giu 2016 | Soddisfatta integralmente | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 18 apr 2016 Consegnato il 21 apr 2016 | In corso | ||
Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 18 apr 2016 Consegnato il 21 apr 2016 | In corso | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A composite guarantee and debenture | Creato il 31 gen 2011 Consegnato il 08 feb 2011 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Composite gaurantee and debenture | Creato il 26 giu 2009 Consegnato il 02 lug 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 26 giu 2009 Consegnato il 30 giu 2009 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Accession deed | Creato il 30 giu 2005 Consegnato il 06 lug 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due of any chargor to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The payment of the secured liabilities,any f/h or l/h property,its interest in present and future licences,fixed charge all othe present and future fittings,plant,equipment,machinery,tools,vehicles,furniture and other tangible movable property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 29 giu 2004 Consegnato il 02 lug 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 12 set 2002 Consegnato il 13 set 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 21 set 2001 Consegnato il 27 set 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage debenture | Creato il 27 lug 2000 Consegnato il 02 ago 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
CASTLEGATE 796 LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidazione volontaria dei creditori |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0