CASTLEGATE 796 LIMITED

CASTLEGATE 796 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCASTLEGATE 796 LIMITED
    Stato della societàLiquidazione
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03792812
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di CASTLEGATE 796 LIMITED?

    • Altre attività di costruzione specializzate n.c.a. (43999) / Costruzioni

    Dove si trova CASTLEGATE 796 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    4th Floor Abbey House
    32 Booth Street
    M2 4AB Manchester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CASTLEGATE 796 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ANSA UTILITIES LIMITED23 giu 200623 giu 2006
    ACTIVE SERVICES GROUP LIMITED21 giu 199921 giu 1999

    Quali sono gli ultimi bilanci di CASTLEGATE 796 LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al30 apr 2021
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 apr 2022
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 apr 2020

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per CASTLEGATE 796 LIMITED?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al21 giu 2023
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma05 lug 2023
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al21 giu 2022
    Scaduto

    Quali sono le ultime deposizioni per CASTLEGATE 796 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 12 dic 2024

    19 pagineLIQ03
    YDW7OF00

    Cessazione della carica di Gold Round Limited come amministratore in data 26 set 2024

    1 pagineTM01
    XDCGNMG2

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 12 dic 2023

    21 pagineLIQ03
    YCWI39QU

    Cessazione della carica di Stuart Pace come amministratore in data 14 dic 2022

    1 pagineTM01
    XCFS2QVS

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600
    YBUEY1LN

    Indirizzo della sede legale modificato da 4th Floor 24 Old Bond Street Mayfair London W1S 4AW United Kingdom a 4th Floor Abbey House 32 Booth Street Manchester M2 4AB in data 09 gen 2023

    2 pagineAD01
    YBUEXZ08

    Dichiarazione delle attività

    8 pagineLIQ02
    YBUEXZ20

    Indirizzo della sede legale modificato da Ground Floor, Egerton House 68 Baker Street Weybridge Surrey KT13 8AL United Kingdom a 4th Floor 24 Old Bond Street Mayfair London W1S 4AW in data 06 gen 2023

    1 pagineAD01
    XBUN3Q3V

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione al 13 dic 2022

    LRESEX

    Dichiarazione di conformità presentata il 21 giu 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01
    XBA8FNN4

    Modifica dei dettagli di Gold Round Limited come persona con controllo significativo il 25 lug 2022

    2 paginePSC05
    XB9PTJUQ

    Dettagli del direttore cambiati per Gold Round Limited il 25 lug 2022

    1 pagineCH02
    XB9PTKMA

    Parte della proprietà o attività è stata liberata e non fa più parte dell'onere 037928120009

    5 pagineMR05
    AB6G888X

    Parte della proprietà o attività è stata liberata e non fa più parte dell'onere 037928120013

    5 pagineMR05
    AB6G88BM

    Soddisfazione dell'onere 037928120011 in pieno

    4 pagineMR04
    AB6G889L

    Soddisfazione dell'onere 037928120012 in pieno

    4 pagineMR04
    AB6G889D

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed ansa utilities LIMITED\certificate issued on 10/06/22
    3 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name10 giu 2022

    Cambio di nome" per delibera

    NM01
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 09 giu 2022

    RES15
    XB5WLHYH

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Stuart Pace il 21 lug 2021

    2 pagineCH01
    XA97ZE0P

    Dichiarazione di conformità presentata il 21 giu 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01
    XA7L348H

    Bilancio redatto al 30 apr 2020

    28 pagineAA
    AA3JCWQQ

    Cessazione della carica di Alan Albert Horton come amministratore in data 30 giu 2020

    1 pagineTM01
    X9JD9GCW

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Stuart Pace il 29 giu 2020

    2 pagineCH01
    X98ARBOW

    Dichiarazione di conformità presentata il 21 giu 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01
    X980403U

    Modifica dei dettagli di Gold Round Limited come persona con controllo significativo il 18 apr 2016

    2 paginePSC05
    X97UI0FS

    Bilancio redatto al 30 apr 2019

    28 pagineAA
    A8HO7GNK

    Chi sono gli amministratori di CASTLEGATE 796 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    RJP SECRETARIES LIMITED
    68 Baker Street
    KT13 8AL Weybridge
    Ground Floor, Egerton House
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    68 Baker Street
    KT13 8AL Weybridge
    Ground Floor, Egerton House
    Surrey
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione02989995
    61999120002
    BOYES, Stephen
    Grassdale Cottage
    Valley Road, Houghton Bottoms
    PR5 0SD Preston
    Lancashire
    Segretario
    Grassdale Cottage
    Valley Road, Houghton Bottoms
    PR5 0SD Preston
    Lancashire
    BritishAccouantant78387220001
    DAVIS, Peter Nicholas
    35 Chatsworth Road
    Eccles
    M30 9DZ Manchester
    Lancashire
    Segretario
    35 Chatsworth Road
    Eccles
    M30 9DZ Manchester
    Lancashire
    BritishDirector29902470001
    DICKINSON, Louise
    Fulwood Park
    Caxton Road Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6
    Lancashire
    United Kingdom
    Segretario
    Fulwood Park
    Caxton Road Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6
    Lancashire
    United Kingdom
    BritishCompany Director139480580001
    GRAEME, Dorothy May
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    Segretario nominato
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British900001330001
    MCINNES, Timothy Ian
    34 Cumberland Drive
    Bowdon
    WA14 3QP Altrincham
    Cheshire
    Segretario
    34 Cumberland Drive
    Bowdon
    WA14 3QP Altrincham
    Cheshire
    BritishChartered Accountant108973030002
    WATKINS, Steven James
    Roscownans
    Old Kea
    TR3 6AX Truro
    Cornwall
    Segretario
    Roscownans
    Old Kea
    TR3 6AX Truro
    Cornwall
    BritishDirector127928260001
    BARRETT, John
    Fulwood Park
    Caxton Road Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6
    Lancashire
    United Kingdom
    Amministratore
    Fulwood Park
    Caxton Road Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6
    Lancashire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector118475070001
    BROOK, Philip John
    8 Hillside Drive
    BH23 2RU Christchurch
    Dorset
    Amministratore
    8 Hillside Drive
    BH23 2RU Christchurch
    Dorset
    BritishDirector64789650001
    DAVIS, Peter Nicholas
    35 Chatsworth Road
    Eccles
    M30 9DZ Manchester
    Lancashire
    Amministratore
    35 Chatsworth Road
    Eccles
    M30 9DZ Manchester
    Lancashire
    EnglandBritishDirector29902470001
    DICKINSON, Louise
    Fulwood Park
    Caxton Road Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6
    Lancashire
    United Kingdom
    Amministratore
    Fulwood Park
    Caxton Road Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6
    Lancashire
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director139480580001
    GRAEME, Lesley Joyce
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    Amministratore delegato nominato
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British900001320001
    HORTON, Alan Albert
    68 Baker Street
    KT13 8AL Weybridge
    Ground Floor, Egerton House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    68 Baker Street
    KT13 8AL Weybridge
    Ground Floor, Egerton House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector182208240001
    LEE, Peter Francis
    Fulwood Park
    Caxton Road Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6
    Lancashire
    United Kingdom
    Amministratore
    Fulwood Park
    Caxton Road Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6
    Lancashire
    United Kingdom
    United KingdomBritishFinance Director207608120001
    LEES, Stuart
    Fulwood Park
    Caxton Road Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6
    Lancashire
    United Kingdom
    Amministratore
    Fulwood Park
    Caxton Road Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6
    Lancashire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector70032700001
    LLOYD JONES, Andrew Mark
    Fulwood Park
    Caxton Road Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6
    Lancashire
    United Kingdom
    Amministratore
    Fulwood Park
    Caxton Road Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6
    Lancashire
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director180809810001
    MAHONEY, Kevin David
    6 Ferrymans Quay
    William Morris Way
    SW6 2UT London
    Amministratore
    6 Ferrymans Quay
    William Morris Way
    SW6 2UT London
    United KingdomBritishCompany Director63238350002
    MAUDE, Simon David
    The Main Hall
    Rufford Park Lane Rufford
    L40 1XE Ormskirk
    1
    Lancashire
    Amministratore
    The Main Hall
    Rufford Park Lane Rufford
    L40 1XE Ormskirk
    1
    Lancashire
    United KingdomBritishDirector89719660003
    MCINNES, Timothy Ian
    34 Cumberland Drive
    Bowdon
    WA14 3QP Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    34 Cumberland Drive
    Bowdon
    WA14 3QP Altrincham
    Cheshire
    United KingdomBritishChartered Accountant108973030002
    PACE, Stuart
    Abbey House
    32 Booth Street
    M2 4AB Manchester
    4th Floor
    Amministratore
    Abbey House
    32 Booth Street
    M2 4AB Manchester
    4th Floor
    EnglandBritishDirector207506130003
    POLLARD, Niall Mackinlay
    Fulwood Park
    Caxton Road Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6
    Lancashire
    United Kingdom
    Amministratore
    Fulwood Park
    Caxton Road Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6
    Lancashire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector176786520001
    SMITH, Andrew John
    High Street
    KT7 0SR Thames Ditton
    2 A C Court
    Surrey
    England
    Amministratore
    High Street
    KT7 0SR Thames Ditton
    2 A C Court
    Surrey
    England
    EnglandBritishDirector207506140001
    TURNER, Paul Leslie
    Netherlaw
    Greendale Lane
    SK10 4AY Mottram St Andrew
    Cheshire
    Amministratore
    Netherlaw
    Greendale Lane
    SK10 4AY Mottram St Andrew
    Cheshire
    BritishDirector72964390004
    VINCENT, Michael
    23 Saint Aubyns's Avenue
    SW19 7BL London
    Amministratore
    23 Saint Aubyns's Avenue
    SW19 7BL London
    EnglandBritishFinance Director99258270001
    WATKINS, Steven James
    Park Crescent
    TR11 2DL Falmouth
    1
    Cornwall
    United Kingdom
    Amministratore
    Park Crescent
    TR11 2DL Falmouth
    1
    Cornwall
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector127928260002
    WATKINS, Steven James
    Roscownans
    Old Kea
    TR3 6AX Truro
    Cornwall
    Amministratore
    Roscownans
    Old Kea
    TR3 6AX Truro
    Cornwall
    BritishDirector127928260001
    GOLD ROUND LIMITED
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    4th Floor
    United Kingdom
    Amministratore
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    4th Floor
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione05687325
    149588400001

    Chi sono le persone con controllo significativo di CASTLEGATE 796 LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    4th Floor
    United Kingdom
    18 apr 2016
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    4th Floor
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleUnited Kingdom
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione05687325
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    5th Floor
    United Kingdom
    06 apr 2016
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    5th Floor
    United Kingdom
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleUnited Kingdom
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione05687325
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.
    68 Baker Street
    KT13 8AL Weybridge
    Ground Floor, Egerton House
    Surrey
    United Kingdom
    06 apr 2016
    68 Baker Street
    KT13 8AL Weybridge
    Ground Floor, Egerton House
    Surrey
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione04275760
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    CASTLEGATE 796 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 01 set 2016
    Consegnato il 13 set 2016
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Blackstar 2016 Limited
    Transazioni
    • 13 set 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 18 giu 2022Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    A registered charge
    Creato il 03 giu 2016
    Consegnato il 20 giu 2016
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Secure Trust Bank PLC
    Transazioni
    • 20 giu 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 18 giu 2022Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 03 giu 2016
    Consegnato il 17 giu 2016
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Secure Trust Bank PLC
    Transazioni
    • 17 giu 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 18 giu 2022Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 18 apr 2016
    Consegnato il 21 apr 2016
    In corso
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank PLC (Trading as Both Clydesdale Bank and Yorkshire Bank)
    Transazioni
    • 21 apr 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 18 apr 2016
    Consegnato il 21 apr 2016
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Fcap Six Limited
    Transazioni
    • 21 apr 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 18 giu 2022Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    A composite guarantee and debenture
    Creato il 31 gen 2011
    Consegnato il 08 feb 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Andrew Lloyd-Jones
    Transazioni
    • 08 feb 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 28 mar 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Composite gaurantee and debenture
    Creato il 26 giu 2009
    Consegnato il 02 lug 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Development Capital Limited (Investor)
    Transazioni
    • 02 lug 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 mag 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 26 giu 2009
    Consegnato il 30 giu 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank PLC (Trading as Yorkshire Bank)
    Transazioni
    • 30 giu 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Accession deed
    Creato il 30 giu 2005
    Consegnato il 06 lug 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due of any chargor to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The payment of the secured liabilities,any f/h or l/h property,its interest in present and future licences,fixed charge all othe present and future fittings,plant,equipment,machinery,tools,vehicles,furniture and other tangible movable property. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Allied Irish Banks PLC ("the Security Trustee")
    Transazioni
    • 06 lug 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 lug 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 29 giu 2004
    Consegnato il 02 lug 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barrington House Nominees Limited (Customer B) (the Security Trustee)
    Transazioni
    • 02 lug 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 12 set 2002
    Consegnato il 13 set 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Fortis Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 13 set 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 apr 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 21 set 2001
    Consegnato il 27 set 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Fortis Bank Sa-Nv
    Transazioni
    • 27 set 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 27 lug 2000
    Consegnato il 02 ago 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 02 ago 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 dic 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    CASTLEGATE 796 LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    13 dic 2022Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Anthony Collier
    4th Floor Abbey House
    32 Booth Street
    M2 4AB Manchester
    Praticante
    4th Floor Abbey House
    32 Booth Street
    M2 4AB Manchester
    Richard Goodall
    4th Floor Abbey House Booth Street
    M2 4AB Manchester
    Praticante
    4th Floor Abbey House Booth Street
    M2 4AB Manchester

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0