CHESTERFIELD INVESTMENTS (NO.1) LIMITED

CHESTERFIELD INVESTMENTS (NO.1) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCHESTERFIELD INVESTMENTS (NO.1) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03797015
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CHESTERFIELD INVESTMENTS (NO.1) LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni
    • Acquisto e vendita di immobili propri (68100) / Attività immobiliari
    • Locazione e gestione di immobili di società di edilizia residenziale (68201) / Attività immobiliari

    Dove si trova CHESTERFIELD INVESTMENTS (NO.1) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    43-45 Portman Square
    W1H 6LY London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CHESTERFIELD INVESTMENTS (NO.1) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    IBIS (496) LIMITED28 giu 199928 giu 1999

    Quali sono gli ultimi bilanci di CHESTERFIELD INVESTMENTS (NO.1) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per CHESTERFIELD INVESTMENTS (NO.1) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Cessazione della carica di un amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Alexander Edward Compton Hare come amministratore in data 05 ott 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Sandra Judith Odell come segretario in data 05 ott 2016

    1 pagineTM02

    Esercizio contabile in corso abbreviato dal 31 mar 2017 al 31 dic 2016

    1 pagineAA01

    Bilancio annuale redatto al 28 giu 2016 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital13 lug 2016

    Stato del capitale al 13 lug 2016

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2015

    9 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 28 giu 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital29 giu 2015

    Stato del capitale al 29 giu 2015

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Nomina di Mr Daniel Mark Greenslade come amministratore in data 31 mar 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Richard James Stearn come amministratore in data 31 mar 2015

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2014

    9 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Maxwell David Shaw James il 04 ago 2014

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Richard James Stearn il 10 set 2014

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Sandra Judith Odell il 04 ago 2014

    1 pagineCH03

    Soddisfazione dell'onere 12 in pieno

    4 pagineMR04

    Indirizzo della sede legale modificato da 16 Grosvenor Street London W1K 4QF a 43-45 Portman Square London W1H 6LY in data 05 ago 2014

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 28 giu 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital14 lug 2014

    Stato del capitale al 14 lug 2014

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Bilancio redatto al 31 mar 2013

    13 pagineAA

    Varie

    Section 519
    4 pagineMISC

    Varie

    Sect 519 aud
    4 pagineMISC

    Bilancio annuale redatto al 28 giu 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital09 lug 2013

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 09 lug 2013

    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Maxwell David Shaw James il 01 lug 2013

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di CHESTERFIELD INVESTMENTS (NO.1) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GREENSLADE, Daniel Mark
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    Amministratore
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Accountant196504990001
    HARE, Alexander Edward Compton
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    Amministratore
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant215786330001
    JAMES, Maxwell David Shaw
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    Amministratore
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director164108510002
    DIXON, Susan Elizabeth
    Flat 1 29-31 Dingley Place
    EC1 8BR London
    Segretario
    Flat 1 29-31 Dingley Place
    EC1 8BR London
    British90007990001
    EASTWOOD, Charlotte Ind
    16 Edna Street
    SW11 3DP London
    Segretario
    16 Edna Street
    SW11 3DP London
    British50099790003
    HUGHES, Paul
    Lark Rise
    5 Greville Park Avenue
    KT21 2QS Ashtead
    Surrey
    Segretario
    Lark Rise
    5 Greville Park Avenue
    KT21 2QS Ashtead
    Surrey
    British23950030001
    LINDSELL, Philip Edmund
    Southside Cottage
    Stone Lane Axford
    SN8 2EY Marlborough
    Wiltshire
    Segretario
    Southside Cottage
    Stone Lane Axford
    SN8 2EY Marlborough
    Wiltshire
    BritishAccountant101775640001
    ODELL, Sandra Judith
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    Segretario
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    174832650001
    ROBSON SKEETE, Gail
    22a Woodpecker Copse
    Locks Heath
    SO31 6WS Southampton
    Hampshire
    Segretario
    22a Woodpecker Copse
    Locks Heath
    SO31 6WS Southampton
    Hampshire
    British66939460001
    WORTHINGTON, Rebecca Jane
    The Old Cottage 97 The High Street
    RG10 8DD Wargrave
    Berkshire
    Segretario
    The Old Cottage 97 The High Street
    RG10 8DD Wargrave
    Berkshire
    British130493170001
    TSD SECRETARIES LIMITED
    2 Serjeants Inn
    EC4Y 1LT London
    Segretario nominato
    2 Serjeants Inn
    EC4Y 1LT London
    900007450001
    COSSEY, Robert Duncan
    24 Makepeace Avenue
    N6 6EJ London
    Amministratore
    24 Makepeace Avenue
    N6 6EJ London
    BritishChartered Surveyor14907240001
    DUGDALE, Edward Stratford
    Tickwood Hall
    TF13 6NZ Much Wenlock
    Shropshire
    Amministratore
    Tickwood Hall
    TF13 6NZ Much Wenlock
    Shropshire
    EnglandBritishCompany Director35942980003
    DWYER, Tonianne
    170 Bishops Road
    Fulham
    SW6 7JG London
    Amministratore
    170 Bishops Road
    Fulham
    SW6 7JG London
    United KingdomAustralianProperty Fund Manager94124780001
    ELLIS, Nigel George
    Willmead Farm
    Bovey Tracey
    TQ13 9NP Newton Abbot
    Devon
    Amministratore
    Willmead Farm
    Bovey Tracey
    TQ13 9NP Newton Abbot
    Devon
    BritishChartered Accountant14185110002
    GAVAGHAN, David Nicholas
    Grosvenor Street
    W1K 4QF London
    16
    Amministratore
    Grosvenor Street
    W1K 4QF London
    16
    United KingdomBritishFund Manager151855940001
    HAMILTON STUBBER, James Robert
    1 The Regency
    Hide Place
    SW1P 4HD London
    Amministratore
    1 The Regency
    Hide Place
    SW1P 4HD London
    United KingdomBritishDirector84913850002
    HENDERSON WILLIAMS, David Andrew
    Glade
    Earleydene
    SL5 9JY Sunninghill
    Berkshire
    Amministratore
    Glade
    Earleydene
    SL5 9JY Sunninghill
    Berkshire
    United KingdomBritishChartered Surveyor117166560001
    LINDSELL, Philip Edmund
    Southside Cottage
    Stone Lane Axford
    SN8 2EY Marlborough
    Wiltshire
    Amministratore
    Southside Cottage
    Stone Lane Axford
    SN8 2EY Marlborough
    Wiltshire
    BritishAccountant101775640001
    RILEY, Michael Edward
    Tylers Barn
    Tylers Green Broad Street
    RH17 5DX Cuckfield
    West Sussex
    Amministratore
    Tylers Barn
    Tylers Green Broad Street
    RH17 5DX Cuckfield
    West Sussex
    BritishChartered Surveyor94724020002
    SHATTOCK, Nicholas Simon Keith
    1 Court Lane
    Dulwich
    SE21 7DH London
    Amministratore
    1 Court Lane
    Dulwich
    SE21 7DH London
    EnglandBritishSolicitor43632680001
    STEARN, Richard James
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    Amministratore
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant94050800002
    WINGATE, Roger Christopher
    Residence Port Blanc
    Place De Trainant, 2
    1223 Cologny
    Switzerland
    Amministratore
    Residence Port Blanc
    Place De Trainant, 2
    1223 Cologny
    Switzerland
    SwitzerlandBritishChartered Surveyor112630420001
    WORTHINGTON, Rebecca Jane
    The Old Cottage 97 The High Street
    RG10 8DD Wargrave
    Berkshire
    Amministratore
    The Old Cottage 97 The High Street
    RG10 8DD Wargrave
    Berkshire
    EnglandBritishAccountant130493170001
    WYATT, Adrian Roger
    Broom Manor
    Cottered
    SG9 9QE Buntingford
    Hertfordshire
    Amministratore
    Broom Manor
    Cottered
    SG9 9QE Buntingford
    Hertfordshire
    EnglandBritishCompany Director42858810002
    TSD NOMINEES LIMITED
    2 Serjeants Inn
    EC4Y 1LT London
    Amministratore delegato nominato
    2 Serjeants Inn
    EC4Y 1LT London
    900007440001

    CHESTERFIELD INVESTMENTS (NO.1) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Floating charge security agreement
    Creato il 14 mar 2008
    Consegnato il 17 mar 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and each other chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    First floating charge all its assets see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC (The "Security Agent")
    Transazioni
    • 17 mar 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 ago 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A security agreement
    Creato il 04 feb 2008
    Consegnato il 15 feb 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Assigns all rights under any hedging arrangements. By way of first floating charge all assets not otherwise ffectively mortgages charged or assigned by way of fixed mortgage charge or assignment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Facility Agent)
    Transazioni
    • 15 feb 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A security agreement
    Creato il 29 gen 2008
    Consegnato il 07 feb 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Assigns all rights under any hedging arrangements. By way of first floating charge all assets not otherwise effectively mortgages charged or assigned by way of fixed mortgage charge or assignment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Facility Agent)
    Transazioni
    • 07 feb 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A security agreement
    Creato il 29 gen 2008
    Consegnato il 01 feb 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All rights under any hedging arrangements. By way of floating charge all assets not effectively mortgaged charged or assigned by way of fixed mortgage charge or assignment under the charge. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Capital as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Facility Agent)
    Transazioni
    • 01 feb 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security agreement
    Creato il 22 ott 2007
    Consegnato il 25 ott 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The company assigns all of its rights under any hedging arrangements; a first floating charge all its assets not at any time otherwise effectively mortgaged charged or assigned by way of fixed mortgage. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Facility Agent)
    Transazioni
    • 25 ott 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security agreement
    Creato il 09 giu 2004
    Consegnato il 15 giu 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each chargor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All rights under any hedging arrangements. By way of first floating charge all assets not effectively mortgaged, charged or assigned by way of fixed mortgage, charge or assignment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 15 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security agreement
    Creato il 02 giu 2004
    Consegnato il 04 giu 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Floating charge all assets not effectively mortgaged, charged or assigned by way of fixed mortgage, charge or assignment under clause 2 of the deed.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (Facility Agent)
    Transazioni
    • 04 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 23 dic 1999
    Consegnato il 10 gen 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from listed offices limited and the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Newlands hall care home high street heckmondwike west yorkshire. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 10 gen 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 23 dic 1999
    Consegnato il 10 gen 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from listed offices limited and the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Soothill manor residential home soothill lane batley west yorkshire. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 10 gen 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 23 dic 1999
    Consegnato il 10 gen 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from listed offices limited and the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Linson court nursing home dark lane wellington street batley west yorkshire. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 10 gen 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 23 dic 1999
    Consegnato il 10 gen 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from listed offices limited and the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Manor croft nursing home old bank road dewsbury west yorkshire. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 10 gen 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 23 dic 1999
    Consegnato il 10 gen 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 10 gen 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 set 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0