COUNTRY RETIREMENT LIMITED

COUNTRY RETIREMENT LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCOUNTRY RETIREMENT LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03798558
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di COUNTRY RETIREMENT LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni

    Dove si trova COUNTRY RETIREMENT LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Rydon House
    Station Road
    RH18 5DW Forest Row
    East Sussex
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di COUNTRY RETIREMENT LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SOUTHWOLD COMPUTING LIMITED30 giu 199930 giu 1999

    Quali sono gli ultimi bilanci di COUNTRY RETIREMENT LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per COUNTRY RETIREMENT LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 17 giu 2016 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital20 giu 2016

    Stato del capitale al 20 giu 2016

    • Capitale: GBP 3
    SH01

    Bilancio redatto al 30 set 2015

    14 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 30 giu 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital08 lug 2015

    Stato del capitale al 08 lug 2015

    • Capitale: GBP 3
    SH01

    Bilancio redatto al 30 set 2014

    13 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Warwick James Barnes il 02 mar 2015

    2 pagineCH01

    Soddisfazione dell'onere 037985580003 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    2 pagineMR04

    Bilancio annuale redatto al 30 giu 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital03 lug 2014

    Stato del capitale al 03 lug 2014

    • Capitale: GBP 3
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Robert Bond il 29 giu 2014

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Warwick James Barnes il 29 giu 2014

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 30 set 2013

    13 pagineAA

    Iscrizione dell'ipoteca 037985580005

    37 pagineMR01

    Risoluzioni

    Resolutions
    23 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Facility agreement/deliver finance documents/directors conflict of interest 27/11/2013
    RES13
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum di Associazione

    RES01

    Iscrizione dell'ipoteca 037985580004

    26 pagineMR01

    Nomina di Mr Antony David Wilkinson come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Paul Wright come amministratore

    1 pagineTM01

    Iscrizione dell'ipoteca 037985580003

    7 pagineMR01

    Bilancio annuale redatto al 30 giu 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Cessazione della carica di John Kitchin come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Peter Masters come segretario

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Paul Wright come segretario

    1 pagineTM02

    Bilancio redatto al 30 set 2012

    13 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di COUNTRY RETIREMENT LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MASTERS, Peter
    Station Road
    RH18 5DW Forest Row
    Rydon House
    East Sussex
    England
    Segretario
    Station Road
    RH18 5DW Forest Row
    Rydon House
    East Sussex
    England
    175253230001
    BARNES, Warwick James
    Station Road
    RH18 5DW Forest Row
    Rydon House
    East Sussex
    United Kingdom
    Amministratore
    Station Road
    RH18 5DW Forest Row
    Rydon House
    East Sussex
    United Kingdom
    United KingdomBritish194511260001
    BOND, Robert
    Station Road
    RH18 5DW Forest Row
    Rydon House
    East Sussex
    United Kingdom
    Amministratore
    Station Road
    RH18 5DW Forest Row
    Rydon House
    East Sussex
    United Kingdom
    EnglandBritish110448850001
    CHASE, James
    Station Road
    RH18 5DW Forest Row
    Rydon House
    East Sussex
    United Kingdom
    Amministratore
    Station Road
    RH18 5DW Forest Row
    Rydon House
    East Sussex
    United Kingdom
    United KingdomBritish158456450001
    WILKINSON, Antony David
    Station Road
    RH18 5DW Forest Row
    Rydon House
    East Sussex
    England
    Amministratore
    Station Road
    RH18 5DW Forest Row
    Rydon House
    East Sussex
    England
    EnglandBritish173832310002
    DENNARD, Gwendoline
    Fairlawn
    Wildernesse Avenue
    TN15 0EA Sevenoaks
    Kent
    Segretario
    Fairlawn
    Wildernesse Avenue
    TN15 0EA Sevenoaks
    Kent
    British71705100002
    WRIGHT, Paul Timothy
    Stonescot
    83 Janes Lane
    RH15 0QP Burgess Hill
    West Sussex
    Segretario
    Stonescot
    83 Janes Lane
    RH15 0QP Burgess Hill
    West Sussex
    British18853840003
    STARTCO LIMITED
    18 The Steyne
    PO21 1TP Bognor Regis
    West Sussex
    Segretario nominato
    18 The Steyne
    PO21 1TP Bognor Regis
    West Sussex
    900009720001
    DENNARD, Gwendoline
    Fairlawn
    Wildernesse Avenue
    TN15 0EA Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    Fairlawn
    Wildernesse Avenue
    TN15 0EA Sevenoaks
    Kent
    British71705100002
    KITCHIN, John Edward
    Westbury
    Old Lane St Johns
    TN6 1RX Crowborough
    East Sussex
    Amministratore
    Westbury
    Old Lane St Johns
    TN6 1RX Crowborough
    East Sussex
    United KingdomBritish78449180001
    NELSON, Hilary
    8-9 Ship Street
    BN1 1AZ Brighton
    East Sussex
    Amministratore
    8-9 Ship Street
    BN1 1AZ Brighton
    East Sussex
    British67888950001
    TURNER, Gary Marshall
    42 Havelock Road
    BN1 6GF Brighton
    East Sussex
    Amministratore
    42 Havelock Road
    BN1 6GF Brighton
    East Sussex
    British72224550001
    WRIGHT, Paul Timothy
    Stonescot
    83 Janes Lane
    RH15 0QP Burgess Hill
    West Sussex
    Amministratore
    Stonescot
    83 Janes Lane
    RH15 0QP Burgess Hill
    West Sussex
    United KingdomBritish18853840003
    NEWCO LIMITED
    18 The Steyne
    PO21 1TP Bognor Regis
    Sussex
    Amministratore delegato nominato
    18 The Steyne
    PO21 1TP Bognor Regis
    Sussex
    900009710001

    COUNTRY RETIREMENT LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 29 nov 2013
    Consegnato il 09 dic 2013
    In corso
    Breve descrizione
    1. all registered or unregistered estates and interests in freehold and leasehold properties at or after the date of the charge owned by country retirement limited (the “company”) or in which the company has an interest from time to time (the “real property”); and. 2. the following assets (wherever located) at or after the date of the charge vested in or belonging to the company or in which the company has an interest from time to time:. (A) all other real property not effectively mortgaged or charged by paragraph 1 above; and. (B) any present or future interests (whether legal or equitable, and including the benefit of all licences) relating to any registered or unregistered trade marks, patents, copyrights, design rights, domain names, business names, confidential information, know-how and other intellectual property rights together with the rights to use any of the foregoing.. Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Robert Bond
    Transazioni
    • 09 dic 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 29 nov 2013
    Consegnato il 03 dic 2013
    In corso
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 03 dic 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 06 nov 2013
    Consegnato il 12 nov 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Charges. 1) by way of legal mortgage the freehold property known as 42 the hill, littlebourne, canterbury CT3 1TA and registered at hm land registry under title number K802134 (“the property” together with all present and future buildings, fixtures (including trade and tenant’s fixtures) which are at any time on or attached to the property.. 2) by way of fixed charge over goodwill relating to the property or in the business or undertaking conducted at the property. 3) by way of a fixed charge all plant, machinery and other items attached to and forming part of the property on or at any time after the date of the legal charge. 4) by way of assignment the rental sums together with the benefit of all rights and remedies of the borrower relating to them to hold bos absolutely subject to the redemption upon repayment of the secured liabilities,. 5) by way of fixed charge all rights and interests in and claims made under any insurance policy relating to any of the property charge under the charge; and. 6) by way of a floating charge all unattached plant, machinery, chattels and goods now or at any time after the date of the legal charge on or in or used in connection with the property or the business or undertaking conducted at the property. Where –. “rental sums” means all rents profits income fees and other sums at any time payable by the lessees underlessees tenant or licensees of the property to the company pursuant to the terms of any agreements for lease leases underleases tenancies or licences to which all or any part of the property is subject but not any sums payable in respect of services provided by lessees underlessees tenants or licensees or payable in respect of insurance premiums or reasonable professional fees or expenses. Restriction on charges and disposal. 1) the company may not create or attempt to create or allow to be created or to exist any charge (whether fixed or floating) or lien or any king over the property (except in favour of bos without the prior written consent of bos. 2) the company may not sell transfer lease or otherwise dispose of all or any part of the property to agree to do so, whether at law or in equity, without the prior written consent of bos. Further assurances. The legal charge contains a further assurance provision requiring the company whenever required by bos to do anything and sign and deliver all deeds, instruments, notices and documents of any kind, in such form as bos may require, in order to enhance or perfect bos’s security under the legal charge, or to preserve the property or to enable bos to enforce the legal charge or exercise any of the powers and rights given to bos by the conditions or by law to bos or the receiver.. Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 12 nov 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 27 gen 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 09 mar 2006
    Consegnato il 22 mar 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the security beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    42 the hill littlebourne canterbury kent t/no H802134. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (In Its Capacity as Security Trustee for the Security Beneficiaries) (the Security Trustee)
    Transazioni
    • 22 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 gen 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 29 set 2000
    Consegnato il 30 set 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    42 the hill littlebourne canterbury kent t/n K802134.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transazioni
    • 30 set 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0