SOAR ENGINEERING LIMITED

SOAR ENGINEERING LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSOAR ENGINEERING LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03798751
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SOAR ENGINEERING LIMITED?

    • (7415) /

    Dove si trova SOAR ENGINEERING LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Beaumont Road
    Banbury
    OX16 1SD Oxfordshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SOAR ENGINEERING LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SEL 99 LIMITED24 ago 199924 ago 1999
    COGDYARD LIMITED30 giu 199930 giu 1999

    Quali sono gli ultimi bilanci di SOAR ENGINEERING LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al28 feb 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per SOAR ENGINEERING LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    L'azione di cancellazione obbligatoria è stata sospesa

    1 pagineDISS16(SOAS)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Bilancio annuale redatto al 30 giu 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital07 lug 2011

    Stato del capitale al 07 lug 2011

    • Capitale: GBP 11,593
    SH01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 28 feb 2010

    6 pagineAA

    Cessazione della carica di Lyndon Rohrer come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 30 giu 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs Deirdre Costello il 30 giu 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Lyndon Grainger Rohrer il 30 giu 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr. Barry Aughey il 30 giu 2010

    1 pagineCH03

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 28 feb 2009

    7 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 29 feb 2008

    7 pagineAA

    legacy

    1 pagine403a

    legacy

    1 pagine403a

    legacy

    1 pagine403a

    legacy

    2 pagine403a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288a

    Memorandum e Statuto

    15 pagineMA

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di assistenza finanziaria per l'acquisizione di azioni

    RES07
    capital

    Risoluzioni

    Grant aquisition 31/03/2008
    RES13
    incorporation

    Risoluzione di modifica del Memorandum e/o degli Articoli di Associazione

    RES01

    legacy

    1 pagine288a

    Chi sono gli amministratori di SOAR ENGINEERING LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    AUGHEY, Barry
    Tullycallick
    IRISH Glaslough
    Monaghan
    Ireland
    Segretario
    Tullycallick
    IRISH Glaslough
    Monaghan
    Ireland
    Irish154839140001
    COSTELLO, Deirdre, Mrs.
    Glaslough
    Tully Callick
    Monaghan
    Ireland
    Amministratore
    Glaslough
    Tully Callick
    Monaghan
    Ireland
    IrelandIrish131251480001
    ADAMS, Julia Louise
    22 Lutterworth Road
    NN1 5JW Northampton
    Segretario
    22 Lutterworth Road
    NN1 5JW Northampton
    British62343490001
    MILLS, Peter Anthony
    5 Bowers Croft
    CV32 6QJ Leamington Spa
    Warwickshire
    Segretario
    5 Bowers Croft
    CV32 6QJ Leamington Spa
    Warwickshire
    British2051200003
    COSTELLO, John
    Monaghan
    Ballyalbanny
    Ireland
    Amministratore
    Monaghan
    Ballyalbanny
    Ireland
    Irish132564260001
    GREEN, Philip Anthony
    Riveredge
    Chertsey Meads
    KT16 8LN Chertsey
    Surrey
    Amministratore
    Riveredge
    Chertsey Meads
    KT16 8LN Chertsey
    Surrey
    British68228320002
    LEWINGTON, Keith Edward
    Ford Cottage 17 Milton Road
    Willen Village
    MK15 9AD Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Amministratore delegato nominato
    Ford Cottage 17 Milton Road
    Willen Village
    MK15 9AD Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British900004940001
    MILLS, Peter Anthony
    5 Bowers Croft
    CV32 6QJ Leamington Spa
    Warwickshire
    Amministratore
    5 Bowers Croft
    CV32 6QJ Leamington Spa
    Warwickshire
    EnglandBritish2051200003
    PARKER, Gerald
    Glenholme House
    South Parade Harbury
    CV33 9JE Leamington Spa
    Warwickshire
    Amministratore
    Glenholme House
    South Parade Harbury
    CV33 9JE Leamington Spa
    Warwickshire
    EnglandBritish2409060002
    ROHRER, Lyndon Grainger, Mr.
    3 Allerton Drive
    Allerton
    L18 6HH Liverpool
    Merseyside
    Amministratore
    3 Allerton Drive
    Allerton
    L18 6HH Liverpool
    Merseyside
    United KingdomBritish2080710001
    SCHOFIELD, Philip
    25 The Ridings
    KT11 2PU Cobham
    Surrey
    Amministratore
    25 The Ridings
    KT11 2PU Cobham
    Surrey
    United KingdomUk54460880001
    SOAR, Elisabeth Joan
    La Vigie
    20 Hauteville
    GY1 1DG St Peter Port
    Channel Islands
    Amministratore
    La Vigie
    20 Hauteville
    GY1 1DG St Peter Port
    Channel Islands
    British106736600001
    SOAR, Richard Kenneth Henry
    La Vigie
    20 Hauteville, St.Peter Port
    GY1 1DG Guernsey
    Channel Islands
    Amministratore
    La Vigie
    20 Hauteville, St.Peter Port
    GY1 1DG Guernsey
    Channel Islands
    British71020450001
    SOAR, Richard Kenneth Henry
    La Vigie
    20 Hauteville, St.Peter Port
    GY1 1DG Guernsey
    Channel Islands
    Amministratore
    La Vigie
    20 Hauteville, St.Peter Port
    GY1 1DG Guernsey
    Channel Islands
    British71020450001

    SOAR ENGINEERING LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Charge on patents
    Creato il 24 apr 2008
    Consegnato il 09 mag 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed charge the patents being patent number WO9845516. Publication date 15 october 1998 see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ulster Bank Ireland Limited
    Transazioni
    • 09 mag 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 24 apr 2008
    Consegnato il 09 mag 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ulster Bank Ireland Limited
    Transazioni
    • 09 mag 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 16 ott 2006
    Consegnato il 03 nov 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Havelet Investments Limited
    • Havelet Investments Limited
    Transazioni
    • 03 nov 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 set 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Creato il 19 dic 2005
    Consegnato il 29 dic 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Charged accounts being barclays bank PLC re soar engineering limited business premium account account number 60165190. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 29 dic 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Guarantee & debenture
    Creato il 23 nov 2005
    Consegnato il 02 dic 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 02 dic 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed of variation relating to a debenture dated 6 july 2000
    Creato il 24 ott 2003
    Consegnato il 12 nov 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the lenders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Havelet Investments Limited
    Transazioni
    • 12 nov 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 set 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 06 lug 2000
    Consegnato il 08 lug 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies and liabilities due from the company to the chargees under the terms of the third schedule of a loan instrument dated 6TH july 2000 and executed by, inter alia, the company constituting the £6,800,000 floating rate guaranteed secured loan notes of welven limited
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Duncan Richard Docharty Soar and Robert William Horton Soar
    • Richard Kenneth Henry Soar and Elisabeth Joan Soar,
    Transazioni
    • 08 lug 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 set 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 27 ago 1999
    Consegnato il 09 set 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company (formerly known as sel 99 limited) to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 09 set 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 set 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0