CHANDLERS PRINTERS LIMITED

CHANDLERS PRINTERS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCHANDLERS PRINTERS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03800339
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CHANDLERS PRINTERS LIMITED?

    • (2222) /

    Dove si trova CHANDLERS PRINTERS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o MBI COAKLEY LTD
    Second Floor 98-110 Tunsgate Square High Street
    GU1 3HE Guildford
    Surrey
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CHANDLERS PRINTERS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BASICFRAME LIMITED05 lug 199905 lug 1999

    Quali sono gli ultimi bilanci di CHANDLERS PRINTERS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2007

    Quali sono le ultime deposizioni per CHANDLERS PRINTERS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    3 pagine4.72

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 30 ott 2011

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 30 apr 2011

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 31 ott 2010

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 30 apr 2010

    5 pagine4.68

    Dichiarazione delle attività con il modulo allegato 4.19

    7 pagine4.20

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione al 01 mag 2009

    LRESEX

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    7 pagine363s
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    annual-return14 ott 2008

    legacy

    363(288)

    legacy

    5 pagine395

    Bilancio redatto al 30 giu 2007

    15 pagineAA

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine403a

    legacy

    1 pagine403a

    legacy

    1 pagine403a

    legacy

    1 pagine403a

    Bilancio redatto al 30 giu 2006

    17 pagineAA

    legacy

    3 pagine395

    legacy

    1 pagine225

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine288c

    Chi sono gli amministratori di CHANDLERS PRINTERS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BURR, David John
    45 Kings Drive
    DA12 5BQ Gravesend
    Kent
    Segretario
    45 Kings Drive
    DA12 5BQ Gravesend
    Kent
    British7599780001
    BURR, David John
    45 Kings Drive
    DA12 5BQ Gravesend
    Kent
    Amministratore
    45 Kings Drive
    DA12 5BQ Gravesend
    Kent
    UkBritish7599780001
    GOULDING, Michael David
    35 St. Peters Road
    BN25 2HP Seaford
    Flint House
    East Sussex
    Amministratore
    35 St. Peters Road
    BN25 2HP Seaford
    Flint House
    East Sussex
    British135943830001
    HOLMES, Nigel David
    Flat 2
    11 The Martlet
    BN3 6NT Hove
    East Sussex
    Amministratore
    Flat 2
    11 The Martlet
    BN3 6NT Hove
    East Sussex
    EnglandBritish24756150004
    OGILVIE, Claire Elizabeth
    6 Amherst Road
    TN40 1QJ Bexhill On Sea
    East Sussex
    Segretario
    6 Amherst Road
    TN40 1QJ Bexhill On Sea
    East Sussex
    British67972540002
    M W DOUGLAS & COMPANY LIMITED
    Regent House
    316 Beulah Hill
    SE19 3HP London
    Segretario nominato
    Regent House
    316 Beulah Hill
    SE19 3HP London
    900007890001
    HOLLAMBY, Stephen Frank
    16 Collington Avenue
    TN39 3QA Bexhill On Sea
    East Sussex
    Amministratore
    16 Collington Avenue
    TN39 3QA Bexhill On Sea
    East Sussex
    British19669180001
    DOUGLAS NOMINEES LIMITED
    Regent House
    316 Beulah Hill
    SE19 3HF London
    Amministratore delegato nominato
    Regent House
    316 Beulah Hill
    SE19 3HF London
    900007880001

    CHANDLERS PRINTERS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 30 lug 2008
    Consegnato il 08 ago 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transazioni
    • 08 ago 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    All assets debenture
    Creato il 20 dic 2006
    Consegnato il 22 dic 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 22 dic 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 19 dic 2005
    Consegnato il 20 dic 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 20 dic 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 mag 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 29 set 2004
    Consegnato il 02 ott 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of second fixed charge all book debts and other debts,floating charge all book debts and other debts now and from time to time due.
    Persone aventi diritto
    • The Paper Company Limited
    Transazioni
    • 02 ott 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 feb 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    All assets debenture
    Creato il 17 giu 2004
    Consegnato il 30 giu 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All assets of the company by way of a first fixed and floating charge.
    Persone aventi diritto
    • Eurofactor (UK) Limited
    Transazioni
    • 30 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 feb 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 15 giu 2004
    Consegnato il 17 giu 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Twenty thousand pounds due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Saxon mews reginald road bexhill on sea east sussex.
    Persone aventi diritto
    • Steven Frank Hollamby and Sarah Josephine Mary Hollamby
    Transazioni
    • 17 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 mag 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 12 ago 2003
    Consegnato il 13 ago 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Thirty thousand pounds due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Saxon mews reginald road bexhill on sea east sussex TN39 3PJ.
    Persone aventi diritto
    • Steven Frank Hollamby and Sarah Josephine Mary Hollamby and Arbuthnot Pension Trustees Limited
    Transazioni
    • 13 ago 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 mag 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 08 nov 2002
    Consegnato il 22 nov 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Five Arrows Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 22 nov 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 07 ago 2002
    Consegnato il 08 ago 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property k/a saxon mews, reginald road, bexhill on sea, rother east sussex t/no. ESX239371. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 08 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 mag 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 25 lug 2002
    Consegnato il 06 ago 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 06 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 feb 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    All assets debenture
    Creato il 13 dic 1999
    Consegnato il 15 dic 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 15 dic 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 giu 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    All assets debenture
    Creato il 17 ago 1999
    Consegnato il 24 ago 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over all assets of the company.
    Persone aventi diritto
    • Alex Lawrie Receivables Financing Limited
    Transazioni
    • 24 ago 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 ago 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    CHANDLERS PRINTERS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    01 mag 2009Inizio della liquidazione
    26 apr 2012Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Michael Timothy Bowell
    Second Floor Tunsgate Square 98-110 High Street
    GU1 3HE Guildford
    Surrey
    Praticante
    Second Floor Tunsgate Square 98-110 High Street
    GU1 3HE Guildford
    Surrey
    Dermot Brendan Coakley
    Second Floor, Tunsgate Square 98-110 High Street
    GU1 3HE Guildford
    Surrey
    Praticante
    Second Floor, Tunsgate Square 98-110 High Street
    GU1 3HE Guildford
    Surrey

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0