VINUM RESTAURANT COMPANY LTD.

VINUM RESTAURANT COMPANY LTD.

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàVINUM RESTAURANT COMPANY LTD.
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03803658
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di VINUM RESTAURANT COMPANY LTD.?

    • Ristoranti con licenza (56101) / Attività di alloggio e di ristorazione
    • Attività di ristorazione per eventi (56210) / Attività di alloggio e di ristorazione

    Dove si trova VINUM RESTAURANT COMPANY LTD.?

    Indirizzo della sede legale
    c/o THISTLEDOWN
    Brook House Asher Lane Business Park
    Asher Lane
    DE5 3SW Pentrich
    Derbyshire
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di VINUM RESTAURANT COMPANY LTD.?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 lug 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per VINUM RESTAURANT COMPANY LTD.?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 lug 2016

    13 pagineAA

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Cessazione della carica di Alexander Campbell Anderson come amministratore in data 01 set 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Jason John Melrose come amministratore in data 01 set 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Jason John Melrose come segretario in data 01 set 2016

    1 pagineTM02

    Nomina di George Thomas Walsh-Waring come amministratore in data 01 set 2016

    2 pagineAP01

    Nomina di Rob Macdonald Tyson come amministratore in data 01 set 2016

    2 pagineAP01

    Soddisfazione dell'onere 1 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    2 pagineMR04

    Dichiarazione di conformità presentata il 08 lug 2016 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da 1 Bank End London SE1 9BU a C/O Thistledown Brook House Asher Lane Business Park Asher Lane Pentrich Derbyshire DE5 3SW in data 15 apr 2016

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Simon Timothy Wood come amministratore in data 14 gen 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Simon Timothy Wood come segretario in data 14 gen 2016

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Jason John Melrose come amministratore in data 04 gen 2016

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Jason John Melrose come segretario in data 14 gen 2016

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Claudio Pulze come amministratore in data 04 gen 2016

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 lug 2015

    21 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 08 lug 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital10 lug 2015

    Stato del capitale al 10 lug 2015

    • Capitale: GBP 249,999.5
    SH01

    Bilancio redatto al 31 lug 2014

    16 pagineAA

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Bilancio annuale redatto al 08 lug 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital18 lug 2014

    Stato del capitale al 18 lug 2014

    • Capitale: GBP 249,999.5
    SH01

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Chi sono gli amministratori di VINUM RESTAURANT COMPANY LTD.?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    TYSON, Rob Macdonald
    Air Street
    W1B 5AN London
    20
    England
    Amministratore
    Air Street
    W1B 5AN London
    20
    England
    United KingdomBritish213377300001
    WALSH-WARING, George Thomas
    Air Street
    W1B 5AN London
    20
    England
    Amministratore
    Air Street
    W1B 5AN London
    20
    England
    United KingdomBritish213377700001
    CONROY, Simon Thomas
    32 Solon Road
    SW2 5UY London
    Segretario
    32 Solon Road
    SW2 5UY London
    British59978960001
    CONROY, Simon Thomas
    32 Solon Road
    SW2 5UY London
    Segretario
    32 Solon Road
    SW2 5UY London
    British59978960001
    ELLWOOD, Rupert James
    7 Coliston Road
    SW18 4PJ London
    Segretario
    7 Coliston Road
    SW18 4PJ London
    British121886910001
    MELROSE, Jason John
    c/o Thistledown
    Asher Lane Business Park
    Asher Lane
    DE5 3SW Pentrich
    Brook House
    Derbyshire
    England
    Segretario
    c/o Thistledown
    Asher Lane Business Park
    Asher Lane
    DE5 3SW Pentrich
    Brook House
    Derbyshire
    England
    206421770001
    WOOD, Simon Timothy
    Bank End
    SE1 9BU London
    1
    Segretario
    Bank End
    SE1 9BU London
    1
    154907200001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    WRIGHTS SECRETARIES LIMITED
    8 Lincoln's Inn Fields
    WC2A 3BP London
    Segretario
    8 Lincoln's Inn Fields
    WC2A 3BP London
    34371850004
    ANDERSON, Alexander Campbell
    Costock Grange Farm
    Nottingham Road Costock
    LE12 6XE Loughborough
    Leicestershire
    Amministratore
    Costock Grange Farm
    Nottingham Road Costock
    LE12 6XE Loughborough
    Leicestershire
    EnglandBritish43710680002
    BALL, Malcolm
    The Laurels
    Pinewood Road Sands
    HP12 4DA High Wycombe
    Buckinghamshire
    Amministratore
    The Laurels
    Pinewood Road Sands
    HP12 4DA High Wycombe
    Buckinghamshire
    British36122220001
    CONROY, Simon Thomas
    32 Solon Road
    SW2 5UY London
    Amministratore
    32 Solon Road
    SW2 5UY London
    British59978960001
    CONROY, Simon Thomas
    32 Solon Road
    SW2 5UY London
    Amministratore
    32 Solon Road
    SW2 5UY London
    British59978960001
    FRY, Leslie George
    5 Linces Way
    AL7 3JN Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Amministratore
    5 Linces Way
    AL7 3JN Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    United KingdomBritish59092150001
    GULLIVER, Trevor
    Deodar Road
    Putney
    SW15 2NN London
    18
    Amministratore
    Deodar Road
    Putney
    SW15 2NN London
    18
    EnglandBritish15258290001
    LACEY, Carole Mary
    54 Bromley Gardens
    BR2 0ET Shortlands
    Kent
    Amministratore
    54 Bromley Gardens
    BR2 0ET Shortlands
    Kent
    Irish80673620001
    LACEY, Carole Mary
    24 Howard Road
    BR1 3QJ Bromley
    Kent
    Amministratore
    24 Howard Road
    BR1 3QJ Bromley
    Kent
    Irish77345590002
    LANDER, Nicholas Laurence
    24 Belsize Lane
    NW3 5AB London
    Amministratore
    24 Belsize Lane
    NW3 5AB London
    United KingdomBritish12469120001
    LOWTHER, John
    Cornerstone
    7 Swinnertons Lane
    NN6 6LS Yelvestoft
    Northamptonshire
    Amministratore
    Cornerstone
    7 Swinnertons Lane
    NN6 6LS Yelvestoft
    Northamptonshire
    UkBritish63343230001
    MELROSE, Jason John
    c/o Thistledown
    Asher Lane Business Park
    Asher Lane
    DE5 3SW Pentrich
    Brook House
    Derbyshire
    England
    Amministratore
    c/o Thistledown
    Asher Lane Business Park
    Asher Lane
    DE5 3SW Pentrich
    Brook House
    Derbyshire
    England
    EnglandBritish59908760002
    PULZE, Claudio
    8 Baslow Road
    Meads
    BN20 7UJ Eastbourne
    Myton House
    E Sussex
    Great Britain
    Amministratore
    8 Baslow Road
    Meads
    BN20 7UJ Eastbourne
    Myton House
    E Sussex
    Great Britain
    EnglandItalian103526580005
    WOOD, Simon Timothy
    The Old Malthouse
    Church Street
    OX15 0TG Deddington
    Oxfordshire
    Amministratore
    The Old Malthouse
    Church Street
    OX15 0TG Deddington
    Oxfordshire
    United KingdomBritish96459470001
    WOOD, Simon Timothy
    The Old Malthouse
    Church Street
    OX15 0TG Deddington
    Oxfordshire
    Amministratore
    The Old Malthouse
    Church Street
    OX15 0TG Deddington
    Oxfordshire
    United KingdomBritish96459470001

    Chi sono le persone con controllo significativo di VINUM RESTAURANT COMPANY LTD.?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Asher Lane Business Park
    Asher Lane
    DE5 3SW Ripley
    Brook House
    Derbyshire
    England
    06 apr 2016
    Asher Lane Business Park
    Asher Lane
    DE5 3SW Ripley
    Brook House
    Derbyshire
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Compnay
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleCompanies Act
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione02663676
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    VINUM RESTAURANT COMPANY LTD. ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 21 giu 2000
    Consegnato il 29 giu 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The l/h property k/a the interior of the arches numbered 222, 223, 224, 232 and part of 221 located in the north west of vinopolis 1 bank end london for lantina vinopolis and the two storet building on stoney street east of arches 197 and 198 of vinopolis 1 bank end london. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 29 giu 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 ago 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 21 giu 2000
    Consegnato il 23 giu 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 23 giu 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 ago 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0