TYMEL WEST SCOTLAND

TYMEL WEST SCOTLAND

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTYMEL WEST SCOTLAND
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà privata a responsabilità illimitata
    Numero di società 03804532
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TYMEL WEST SCOTLAND?

    • Acquisto e vendita di immobili propri (68100) / Attività immobiliari
    • Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari

    Dove si trova TYMEL WEST SCOTLAND?

    Indirizzo della sede legale
    3 Field Court
    Grays Inn
    WC1R 5EF London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TYMEL WEST SCOTLAND?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HIGHCROSS WEST SCOTLAND LIMITED 13 dic 199913 dic 1999
    DMWSL 277 LIMITED09 lug 199909 lug 1999

    Quali sono gli ultimi bilanci di TYMEL WEST SCOTLAND?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al21 lug 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per TYMEL WEST SCOTLAND?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per TYMEL WEST SCOTLAND?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    16 pagine4.72

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 17 mar 2015

    16 pagine4.68

    Indirizzo della sede legale modificato da * C/O Clyne & Co. Plymouth Chambers Bartlett Street Caerphilly Mid Glamorgan CF83 1JS Wales* in data 28 mar 2014

    1 pagineAD01

    Dichiarazione delle attività con il modulo allegato 4.19

    6 pagine4.20

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione

    LRESEX

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 21 lug 2013

    9 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 mag 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital05 giu 2013

    Stato del capitale al 05 giu 2013

    • Capitale: GBP 1.05
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 21 lug 2012

    4 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da * 3 Mountain Road Caerphilly Mid Glamorgan CF83 1HG* in data 19 apr 2013

    1 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da * Victoria House Southampton Row London WC1B 4DA* in data 10 lug 2012

    2 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 31 mag 2012 con elenco completo degli azionisti

    14 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 21 lug 2011

    11 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 mag 2011 con elenco completo degli azionisti

    13 pagineAR01

    Bilancio annuale redatto al 31 mag 2010 con elenco completo degli azionisti

    13 pagineAR01

    Bilancio annuale redatto al 31 mag 2009 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Bilancio annuale redatto al 31 mag 2008 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Bilancio redatto al 21 lug 2010

    15 pagineAA

    Bilancio redatto al 21 lug 2009

    15 pagineAA

    Bilancio redatto al 21 lug 2008

    16 pagineAA

    Bilancio redatto al 21 lug 2007

    17 pagineAA

    Domanda di ripristino amministrativo

    3 pagineRT01

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Chi sono gli amministratori di TYMEL WEST SCOTLAND?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ALLARD, Imelda
    3 The Spires
    BT18 9DY Holywood
    County Down
    N Ireland
    Segretario
    3 The Spires
    BT18 9DY Holywood
    County Down
    N Ireland
    British82441870001
    ALLARD, Tyrone James
    The Spires
    BT18 9DY Holywood
    3
    County Down
    Northern Ireland
    Amministratore
    The Spires
    BT18 9DY Holywood
    3
    County Down
    Northern Ireland
    Northern IrelandIrishDirector2343150005
    MASSEY, Jill Elizabeth Ann
    15 Hatch Close
    Chapel Row
    RG7 6NZ Bucklebury
    Berkshire
    Segretario
    15 Hatch Close
    Chapel Row
    RG7 6NZ Bucklebury
    Berkshire
    British34436710001
    MEGAN, Michael Francis
    15 Blackthorn Drive
    RG18 4BP Thatcham
    Berkshire
    Segretario
    15 Blackthorn Drive
    RG18 4BP Thatcham
    Berkshire
    Irish46067860002
    DM COMPANY SERVICES LIMITED
    16 Charlotte Square
    EH2 4DF Edinburgh
    Midlothian
    Segretario nominato
    16 Charlotte Square
    EH2 4DF Edinburgh
    Midlothian
    900000320001
    GUBB, Peter Griffiths
    Donnington Hurst
    Wantage Road Donnington
    RG14 3BE Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Donnington Hurst
    Wantage Road Donnington
    RG14 3BE Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish Chartered Surveyor6163460002
    HUNTER, Iain Gordon
    Headshaw
    TD7 4NT Ashkirk
    Selkirkshire
    Amministratore
    Headshaw
    TD7 4NT Ashkirk
    Selkirkshire
    United KingdomBritishChartered Surveyor34752600001
    MEGAN, Michael Francis
    15 Blackthorn Drive
    RG18 4BP Thatcham
    Berkshire
    Amministratore
    15 Blackthorn Drive
    RG18 4BP Thatcham
    Berkshire
    IrishAccountant46067860002
    WOODS, Keith Desmond
    8 Walters Close
    Cold Ash
    RG18 9PU Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    8 Walters Close
    Cold Ash
    RG18 9PU Newbury
    Berkshire
    UkBritishArchitect87234820001
    WRIGHT, Helen Marjorie Elizabeth
    Merrilees Cottage
    Main Street
    RG20 7EW Chaddleworth
    Berkshire
    Amministratore
    Merrilees Cottage
    Main Street
    RG20 7EW Chaddleworth
    Berkshire
    BritishSurveyor56779440004
    25 NOMINEES LIMITED
    Royal London House
    22-25 Finsbury Square
    EC2A 1DX London
    Amministratore
    Royal London House
    22-25 Finsbury Square
    EC2A 1DX London
    42409900001

    TYMEL WEST SCOTLAND ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Assignation of rent due under occupational leases
    Creato il 03 lug 2002
    Consegnato il 18 lug 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due from highcross west scotland limited to the chargee
    Brevi particolari
    All sums due and that may become due to the borrower whether by way of rent or otherwise by the tenants detailed. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland (Ireland) Limited
    Transazioni
    • 18 lug 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 ott 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 31 mag 2002
    Consegnato il 18 giu 2002
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland (Ireland) Limited
    Transazioni
    • 18 giu 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 ott 2004Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 7 june 2002 and
    Creato il 31 mag 2002
    Consegnato il 13 giu 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due from the company (formerly known as highcross west scotland limited) to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Subjects known as crowngate centre,114-127 brook st,glasgow being the subjects at 117-127 brook st,glasgow and subjects on south west side of rimsdale st,glasgow; GLA113510 and GLA119195.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland (Ireland) Limited
    Transazioni
    • 13 giu 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 ott 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignation of rent
    Creato il 31 mag 2002
    Consegnato il 13 giu 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due from the company (formerly known as highcross west scotland limited) to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All sums due by way of rent in respect of their interest in the occupation leases as detailed in the schedule. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland (Ireland) Limited
    Transazioni
    • 13 giu 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 ott 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 21 dic 1999
    Consegnato il 07 gen 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 07 gen 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 giu 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 29 december 1999 and
    Creato il 20 dic 1999
    Consegnato il 15 gen 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee in the terms of a facility agreement dated 17TH and 20TH december 1999 relating to a facility to make available £1,622,400 to the company
    Brevi particolari
    Land at brook street glasgow t/n GLA113510 and land on the west south west side of rimsdale street glasgow t/n GLA119195.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 15 gen 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 giu 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    TYMEL WEST SCOTLAND ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    08 ago 2015Data prevista di scioglimento
    18 mar 2014Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    William Antony Batty
    3 Field Court
    Grays Inn
    WC1R 5EF London
    Praticante
    3 Field Court
    Grays Inn
    WC1R 5EF London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0