FOOD PARTNERS LIMITED

FOOD PARTNERS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàFOOD PARTNERS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03804549
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di FOOD PARTNERS LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova FOOD PARTNERS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    2 The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di FOOD PARTNERS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    DMWSL 270 LIMITED09 lug 199909 lug 1999

    Quali sono gli ultimi bilanci di FOOD PARTNERS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per FOOD PARTNERS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    L'azione di cancellazione obbligatoria è stata sospesa

    1 pagineDISS16(SOAS)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Cessazione della carica di Martin Johnson come amministratore in data 03 giu 2020

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Diarmuid Brendan Conifrey come amministratore in data 24 giu 2020

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Diarmuid Brendan Conifrey come amministratore in data 08 apr 2020

    2 pagineAP01

    Ordinanza giudiziaria

    S1096 Court Order to Rectify
    6 pagineOC

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 ago 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2018

    22 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 11 in pieno

    4 pagineMR04

    legacy

    pagineANNOTATION

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 ago 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 30 set 2017

    23 pagineAA

    legacy

    2 pagineAGREEMENT2

    legacy

    47 paginePARENT_ACC

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 mar 2017 al 30 set 2017

    1 pagineAA01

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 ago 2017 con aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 mar 2016

    31 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 ago 2016 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    Cessazione della carica di Mark Ian Tentori come amministratore in data 27 apr 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Gavin Cox come segretario in data 08 mar 2016

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Gavin Eliot Cox come amministratore in data 07 mar 2016

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Martin Johnson come amministratore in data 25 feb 2016

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Mark Ian Tentori come amministratore in data 06 ott 2015

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di FOOD PARTNERS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    COX, Gavin
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    England
    Segretario
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    England
    165756650001
    MOMEN, Julian Akhtar Karim
    Tanners Drive
    MK14 5BN Blakelands
    28
    Milton Keynes
    Segretario
    Tanners Drive
    MK14 5BN Blakelands
    28
    Milton Keynes
    British150500050001
    ROBERTSON, Neil Charles
    16 Barmstedt Drive
    LE15 6RG Oakham
    Rutland
    Segretario
    16 Barmstedt Drive
    LE15 6RG Oakham
    Rutland
    BritishChartered Accountant48323870001
    THORNE, Michael
    48 Station Road
    Woburn Sands
    MK17 8RU Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Segretario
    48 Station Road
    Woburn Sands
    MK17 8RU Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British71735980002
    DM COMPANY SERVICES LIMITED
    16 Charlotte Square
    EH2 4DF Edinburgh
    Midlothian
    Segretario nominato
    16 Charlotte Square
    EH2 4DF Edinburgh
    Midlothian
    900000320001
    MACLAY MURRAY & SPENS LLP
    St. Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    151
    Segretario nominato
    St. Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    151
    900003400001
    CHREE, Ian Charles Gordon
    6 The Grange
    Perceton
    KA11 2EU Irvine
    Ayrshire
    Amministratore
    6 The Grange
    Perceton
    KA11 2EU Irvine
    Ayrshire
    ScotlandBritishCompany Director65127980003
    CONIFREY, Diarmuid Brendan
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    Amministratore
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    EnglandIrishChief Finance Officer268799160001
    COX, Gavin Eliot
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    England
    Amministratore
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    England
    United KingdomBritishDirector153840250001
    EARL, Elizabeth Jane
    Waverley
    Burners Heath
    GU24 0DJ Pirbright Woking
    Surrey
    Amministratore
    Waverley
    Burners Heath
    GU24 0DJ Pirbright Woking
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director202375770001
    HAZELDEAN, William James
    6a Balmoral Court
    Gleneagles Village
    PH3 1SH Auchterarder
    Perthshire
    Amministratore
    6a Balmoral Court
    Gleneagles Village
    PH3 1SH Auchterarder
    Perthshire
    ScotlandBritishCompany Director83660790002
    HULBERT, David John
    St Michaels Way
    Steeple Claydon
    MK18 2QD Buckingham
    53
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Amministratore
    St Michaels Way
    Steeple Claydon
    MK18 2QD Buckingham
    53
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritishOperational And Technical Dire136463020001
    JOHNSON, Martin
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    Amministratore
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    EnglandBritishDirector140167360001
    KILSHAW, David Charles
    Drumallan
    283 North Deeside Road, Cults
    AB15 9PA Aberdeen
    Amministratore
    Drumallan
    283 North Deeside Road, Cults
    AB15 9PA Aberdeen
    United KingdomBritishIndustrial Manager18455470002
    KINGSLEY BATES, Paul
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United Kingdom
    Amministratore
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United Kingdom
    United KingdomBritishManaging Director132962170001
    MCLELLAND, Stewart
    36 East Craigs Rigg
    EH12 8JA Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    36 East Craigs Rigg
    EH12 8JA Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritishDirector157009150001
    MOMEN, Julian Akhtar Karim
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United Kingdom
    Amministratore
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector51784930002
    POCOCK, Patrick William
    The Steadings
    Woodside Of Cloghill, Kingswells
    AB15 8SA Aberdeen
    Amministratore
    The Steadings
    Woodside Of Cloghill, Kingswells
    AB15 8SA Aberdeen
    BritishCompany Director96978470001
    ROBERTSON, Neil Charles
    16 Barmstedt Drive
    LE15 6RG Oakham
    Rutland
    Amministratore
    16 Barmstedt Drive
    LE15 6RG Oakham
    Rutland
    United KingdomBritishChartered Accountant48323870001
    ROBINSON, Stuart John
    Westfield House
    Harburn
    EH55 8RB West Calder
    West Lothian
    Amministratore
    Westfield House
    Harburn
    EH55 8RB West Calder
    West Lothian
    BritishCompany Director63448390001
    TENTORI, Mark Ian
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    Amministratore
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    EnglandBritishChief Finance Officer119564310001
    THOMAS, Christopher
    Poyle Road
    Colnbrook
    SL3 0QX Slough
    Food Partners House
    England
    Amministratore
    Poyle Road
    Colnbrook
    SL3 0QX Slough
    Food Partners House
    England
    United KingdomBritishDirector63844650001
    THORNE, Michael
    48 Station Road
    Woburn Sands
    MK17 8RU Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Amministratore
    48 Station Road
    Woburn Sands
    MK17 8RU Milton Keynes
    Buckinghamshire
    BritishCompany Director71735980002
    THORPE, Alan
    7 Oak Wynd
    Cambuslang
    G72 7GS Glasgow
    Amministratore
    7 Oak Wynd
    Cambuslang
    G72 7GS Glasgow
    BritishDistribution Manager81775420001
    TRUELOVE, Amelia Anne
    Bentley Hall
    Fenny Bentley
    DE6 1LE Ashbourne
    Derbyshire
    Amministratore
    Bentley Hall
    Fenny Bentley
    DE6 1LE Ashbourne
    Derbyshire
    BritishDirector37845970003
    WOOD, Steven John
    Poyle Road
    Colnbrook
    SL3 0QX Slough
    Food Partners House
    England
    Amministratore
    Poyle Road
    Colnbrook
    SL3 0QX Slough
    Food Partners House
    England
    United KingdomBritishDirector232132390001
    25 NOMINEES LIMITED
    Royal London House
    22-25 Finsbury Square
    EC2A 1DX London
    Amministratore
    Royal London House
    22-25 Finsbury Square
    EC2A 1DX London
    42409900001

    Chi sono le persone con controllo significativo di FOOD PARTNERS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Adelie Foods Group Limited
    The Square, Southall Lane
    UB2 5NH Southall
    2
    England
    06 apr 2016
    The Square, Southall Lane
    UB2 5NH Southall
    2
    England
    No
    Forma giuridicaAdelie Foods Group Limited
    Paese di registrazioneEngalnd & Wales
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneRegistrar Of Companies
    Numero di registrazione07964277
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    FOOD PARTNERS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 05 mar 2015
    Consegnato il 11 mar 2015
    In corso
    Breve descrizione
    None.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee
    Transazioni
    • 11 mar 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 31 mag 2013
    Consegnato il 07 giu 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    A fixed charge over all land (I.E. any interest in heritable, freehold or leasehold land) vested in or charged to food partners limited, owned now or in the future. This includes all fixtures and fittings attached to the land and all rents receivable from any lease granted out of the land.. A fixed charge, subject to third party consents, over all intellectual property of food partners limited, owned now or in the future.. Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transazioni
    • 07 giu 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 10 mar 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 31 mag 2013
    Consegnato il 05 giu 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Punjab National Bank (International) Limited
    Transazioni
    • 05 giu 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 06 feb 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 11 apr 2012
    Consegnato il 14 apr 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor or any future obligor and each grantor of security to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 14 apr 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 07 giu 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 11 apr 2012
    Consegnato il 14 apr 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any member of the group to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Pnc Business Credit, a Trading Style of Pnc Financial Services UK LTD
    Transazioni
    • 14 apr 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 07 giu 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Rent deposit deed
    Creato il 20 ott 2011
    Consegnato il 01 nov 2011
    In corso
    Importo garantito
    £56,000 due or to become due
    Brevi particolari
    The deposit amount see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Trw Pensions Trust Limited
    Transazioni
    • 01 nov 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Rent deposit deed
    Creato il 20 ott 2011
    Consegnato il 01 nov 2011
    In corso
    Importo garantito
    £18,066.80 due or to become due
    Brevi particolari
    The deposit amount see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Trw Pensions Trust Limited
    Transazioni
    • 01 nov 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Rent deposit deed
    Creato il 23 feb 2009
    Consegnato il 04 mar 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All monies standing to the credit of the deposit account see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Brixton (Unit 6 Horton Road Poyle) Limited
    Transazioni
    • 04 mar 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Rent deposit deed
    Creato il 24 apr 2008
    Consegnato il 10 mag 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £43,505.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    £43,505.00 or the amount of the credit in the account from time to time.
    Persone aventi diritto
    • Microsoft Limited
    Transazioni
    • 10 mag 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 mar 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 21 apr 2008
    Consegnato il 02 mag 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Duke Street Capital General Partner Limited (As Security Agent for the Secured Parties)
    Transazioni
    • 02 mag 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 giu 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Rent deposit deed
    Creato il 01 mar 2007
    Consegnato il 10 mar 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Premium of £56,000 plus vat deposited by the company with the chargee and all other sums from time to time.
    Persone aventi diritto
    • Trw Pensions Trust Limited
    Transazioni
    • 10 mar 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture accession deed
    Creato il 04 apr 2006
    Consegnato il 13 apr 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each member of the group to the security agent and/or the other secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Agent for the Secured Parties)
    Transazioni
    • 13 apr 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 giu 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 8 may 2006 and
    Creato il 02 apr 2006
    Consegnato il 27 mag 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the security agent and/or the other security parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Rowallan business park, southcraig avenue, kilmarnock t/no. AYR3588.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Agent for the Security Parties)
    Transazioni
    • 27 mag 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 giu 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Share pledge
    Creato il 02 apr 2006
    Consegnato il 20 apr 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Any additional shares and related rights, additional shares means any shares in the company including any such shares comprised in related rights meaning all dividends, interest. The comapany and the existing shares being food partners kilmarnock limited reg no:SC140577, ordinary shares of £1. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland 'Security Agent'
    Transazioni
    • 20 apr 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 giu 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 26TH september 2005 and
    Creato il 31 mag 2005
    Consegnato il 07 ott 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The property k/a rowallan business park, kilmarnock.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 07 ott 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 apr 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 07 ago 2003
    Consegnato il 13 ago 2003
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The sum of £62,500 or such greater sum as is equal to one half of the current annual rental as defined in the lease.
    Persone aventi diritto
    • Cockspur Property (General Partner) Limited and Cockspur Property (Nominee No.1) Limited
    Transazioni
    • 13 ago 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    Composite corporate guarantee
    Creato il 31 ott 2001
    Consegnato il 17 nov 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    To exercise a right of set-off or retention in respect of all money at any time standing to the credit of the guarantor's accounts whatsoever. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 17 nov 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 apr 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 31 ott 2001
    Consegnato il 14 nov 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 14 nov 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 apr 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 09 ott 2000
    Consegnato il 19 ott 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 19 ott 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 nov 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0