SOUTHERN CROSS CARE HOMES HOLDINGS LIMITED

SOUTHERN CROSS CARE HOMES HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSOUTHERN CROSS CARE HOMES HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03805939
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SOUTHERN CROSS CARE HOMES HOLDINGS LIMITED?

    • Attività di altre società holding n.c.a. (64209) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova SOUTHERN CROSS CARE HOMES HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SOUTHERN CROSS CARE HOMES HOLDINGS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HIGHFIELD HOLDINGS LIMITED01 ott 199901 ott 1999
    PORTSURF LIMITED13 lug 199913 lug 1999

    Quali sono gli ultimi bilanci di SOUTHERN CROSS CARE HOMES HOLDINGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per SOUTHERN CROSS CARE HOMES HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Cessazione della carica di Francis Declan Finbar Tempany Mccormack come segretario in data 09 ott 2012

    1 pagineTM02

    Notifica di esecuzione dell'accordo di composizione

    6 pagine1.4

    Cessazione della carica di Timothy James Bolot come amministratore in data 17 ago 2012

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 13 lug 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital17 lug 2012

    Stato del capitale al 17 lug 2012

    • Capitale: GBP 8,300,196
    SH01

    Notifica al Registro delle imprese dell'accordo di composizione volontario che entra in vigore

    4 pagine1.1

    Cessazione della carica di William James Buchan come amministratore in data 15 nov 2011

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di David Andrew Smith come amministratore in data 01 nov 2011

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Stephen Jonathan Taylor come amministratore in data 26 ott 2011

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Timothy James Bolot come amministratore in data 26 ott 2011

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 30 set 2010

    20 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 13 lug 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Cessazione della carica di William Mcleish come segretario

    1 pagineTM02

    Nomina di Francis Declan Finbar Tempany Mccormack come segretario

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Richard Midmer come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 13 lug 2010 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Enter agreements 14/05/2010
    RES13

    Bilancio redatto al 27 set 2009

    18 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr David Andrew Smith il 07 gen 2010

    2 pagineCH01

    Nomina di Mr David Andrew Smith come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di David Smith come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr David Andrew Smith come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Kamma Foulkes come amministratore

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di SOUTHERN CROSS CARE HOMES HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    TAYLOR, Stephen Jonathan
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Amministratore
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish163496070001
    JOYCE, Meriel Lucy Ann
    21 Easter Steil
    EH10 5XE Edinburgh
    Segretario
    21 Easter Steil
    EH10 5XE Edinburgh
    British16385330010
    KAUL, Sheila
    35 Princes Court
    HA9 7JJ Wembley
    Middlesex
    Segretario
    35 Princes Court
    HA9 7JJ Wembley
    Middlesex
    British70194600001
    MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Segretario
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    158305800001
    MCLEISH, William David
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Segretario
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    British168970640001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BOLOT, Timothy James
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Amministratore
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish107837080002
    BUCHAN, William James
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Amministratore
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    EnglandBritish79917240001
    COLVIN, William
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    Amministratore
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    United KingdomBritish51697890003
    COLVIN, William
    1 Patterdale
    Coldharbour Road
    KT14 6JN West Byfleet
    Surrey
    Amministratore
    1 Patterdale
    Coldharbour Road
    KT14 6JN West Byfleet
    Surrey
    United KingdomBritish51697890001
    FOULKES, Kamma
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Amministratore
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish111188390002
    GROOMBRIDGE, Kevin John
    51 Old Croft Road
    ST17 0NL Stafford
    Amministratore
    51 Old Croft Road
    ST17 0NL Stafford
    EnglandBritish105722880001
    JOYCE, Anthony
    Gibliston Farmhouse
    Colinsburgh
    KY9 1JS Leven
    Fife
    Amministratore
    Gibliston Farmhouse
    Colinsburgh
    KY9 1JS Leven
    Fife
    ScotlandBritish95693160002
    JOYCE, Martin Patrick
    La Rue A
    St Peter Port
    GY1 1QG Guernsey
    Amministratore
    La Rue A
    St Peter Port
    GY1 1QG Guernsey
    United KingdomBritish27130160009
    JOYCE, Meriel Lucy Ann
    21 Easter Steil
    EH10 5XE Edinburgh
    Amministratore
    21 Easter Steil
    EH10 5XE Edinburgh
    British16385330010
    LOCK, Jason David
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    Amministratore
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    EnglandBritish144822040001
    MALHAM, Janette
    The Limekilns
    9a Elm Grove
    TS26 8LZ Hartlepool
    Amministratore
    The Limekilns
    9a Elm Grove
    TS26 8LZ Hartlepool
    EnglandBritish91088900003
    MCKEEVER, Pauline Ann
    40 Pine Place
    G5 0BX Glasgow
    Amministratore
    40 Pine Place
    G5 0BX Glasgow
    BritainBritish91521130001
    MIDMER, Richard Neil
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Amministratore
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    EnglandBritish110640170001
    MILLOY, Alastair Harvey
    Flat 1/1 Camphill House
    Queens Park
    G41 2DX Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    Flat 1/1 Camphill House
    Queens Park
    G41 2DX Glasgow
    Lanarkshire
    British69398880001
    MURPHY, John
    21 Montgreenan View
    KA13 7NL Kilwinning
    Ayrshire
    Amministratore
    21 Montgreenan View
    KA13 7NL Kilwinning
    Ayrshire
    British26177180002
    MURPHY, John
    4 Lochend Road
    KA10 6JJ Troon
    Amministratore
    4 Lochend Road
    KA10 6JJ Troon
    United KingdomBritish26177180004
    RUTTER, Christopher
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    Amministratore
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    British103588940001
    SCOTT, Philip Henry
    The Old Vicarage
    Newgate
    DL12 8NW Barnard Castle
    County Durham
    Amministratore
    The Old Vicarage
    Newgate
    DL12 8NW Barnard Castle
    County Durham
    EnglandBritish174231320001
    SIZER, Graham Kevin
    Old Salutation Barn
    Low Street Little Fencote
    DL7 9LR Northallerton
    Amministratore
    Old Salutation Barn
    Low Street Little Fencote
    DL7 9LR Northallerton
    EnglandBritish77274540003
    SMITH, David Andrew, Mr.
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Amministratore
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish147997950001
    SMITH, David Andrew, Mr.
    Durham Road
    Low Fell
    NE9 5AL Gateshead
    377
    England
    England
    Amministratore
    Durham Road
    Low Fell
    NE9 5AL Gateshead
    377
    England
    England
    United KingdomBritish147997950001
    STEIN, Anthony Karl
    9 Birmingham Road
    Coughton
    B49 5HR Alcester
    Amministratore
    9 Birmingham Road
    Coughton
    B49 5HR Alcester
    United KingdomBritish109518530001
    TAYLOR, John James
    Ben Sayers Park
    North Berwick
    EH39 5PT Edinburgh
    19
    East Lothian
    Amministratore
    Ben Sayers Park
    North Berwick
    EH39 5PT Edinburgh
    19
    East Lothian
    ScotlandBritish138774840001
    WILSON, Mark Stephen
    9 Wheatear Lane
    Ingleby Barwick
    TS17 0TB Stockton On Tees
    Amministratore
    9 Wheatear Lane
    Ingleby Barwick
    TS17 0TB Stockton On Tees
    British90893350001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    SOUTHERN CROSS CARE HOMES HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 29 feb 2008
    Consegnato il 14 mar 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capital buildings fixed plant and machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC in Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries
    Transazioni
    • 14 mar 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 06 giu 2007
    Consegnato il 19 giu 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, bookdebts, uncalled capital, plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 19 giu 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 ago 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 07 lug 2006
    Consegnato il 20 lug 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 20 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 ago 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 08 apr 2005
    Consegnato il 15 apr 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 15 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 ago 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 02 ago 2002
    Consegnato il 13 ago 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the security trustee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of fixed charge the real property other than scottish real property, all goodwill, insurance, debts, investments and uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Trustee for the Beneficiaries (Thesecurity Trustee))
    Transazioni
    • 13 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 feb 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Share pledge
    Creato il 31 gen 2001
    Consegnato il 10 feb 2001
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from highfield operations limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The shares in the capital of highfield operations limited and any shares in the capital of highfield operations LTD from time to time and all rights to dividends and other distributions payable and all other rights thereon,bonus,etc.
    Persone aventi diritto
    • Quercus (Nursing Homes) Limited
    Transazioni
    • 10 feb 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    Share pledge
    Creato il 19 gen 2001
    Consegnato il 26 gen 2001
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from highfield operations (no.2) limited under the terms of the lease or under the terms of any other document whether actual or contingent
    Brevi particolari
    The shares listed in the schedule to the share pledge and all rights to dividends and other distributions paid or payable on all or any of these shares and all other rights accruing or offered at any time by way of redemption, bonus, pre-emption or otherwise. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Quintain (No.5) Limited
    Transazioni
    • 26 gen 2001Registrazione di un'ipoteca (395)

    SOUTHERN CROSS CARE HOMES HOLDINGS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    20 giu 2012Data della riunione per approvare il CVA
    20 ago 2012Data di completamento o cessazione del CVA
    Accordo volontario di ristrutturazione aziendale (CVA)
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Howard Smith
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds
    Praticante
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0