TES 2013 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTES 2013 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03808437
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TES 2013 LIMITED?

    • Altre industrie manifatturiere n.c.a. (32990) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova TES 2013 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Rmt
    Gosforth Park Avenue
    NE12 8EG Newcastle Upon Tyne
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TES 2013 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    TANFIELD ENGINEERING SYSTEMS LIMITED07 dic 200507 dic 2005
    TANFIELD HOLDINGS LIMITED02 dic 200302 dic 2003
    TANFIELD GROUP LIMITED25 nov 199925 nov 1999
    SANDCO 635 LIMITED16 lug 199916 lug 1999

    Quali sono gli ultimi bilanci di TES 2013 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per TES 2013 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    22 pagineLIQ14

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 06 apr 2018

    22 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 06 apr 2017

    29 pagineLIQ03

    Ordinanza giudiziaria in materia di insolvenza

    Court order INSOLVENCY:court order re. Removal of liquidator
    4 pagineLIQ MISC OC

    Avviso di cessazione di funzioni come liquidatore volontario

    1 pagine4.40

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 06 apr 2016

    16 pagine4.68

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Ordinanza giudiziaria in materia di insolvenza

    Court order insolvency:co to remove/replace liquidator
    3 pagineLIQ MISC OC

    Avviso di cessazione di funzioni come liquidatore volontario

    1 pagine4.40

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 23 mar 2015

    21 pagine2.24B

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    1 pagine2.34B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 02 ott 2014

    19 pagine2.24B

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    1 pagine2.31B

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed tanfield engineering systems LIMITED\certificate issued on 23/05/14
    3 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name23 mag 2014

    Risoluzione di cambio di nome della società il 15 mag 2014

    RES15

    Avviso di cambio di nome"

    2 pagineCONNOT

    Risultato della riunione dei creditori

    7 pagine2.23B

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B/2.15B

    41 pagine2.16B

    Indirizzo della sede legale modificato da * Vigo Centre Birtley Road Washington Tyne and Wear NE38 9DA* in data 03 dic 2013

    2 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    Bilancio annuale redatto al 22 nov 2012 con elenco completo degli azionisti

    9 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital23 nov 2012

    Stato del capitale al 23 nov 2012

    • Capitale: GBP 960,400
    SH01

    Bilancio annuale redatto al 16 lug 2012 con elenco completo degli azionisti

    9 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    24 pagineAA

    legacy

    MG01

    Chi sono gli amministratori di TES 2013 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BROOKS, Charles David
    Planetrees
    Wall
    NE46 4EQ Hexham
    Northumberland
    Segretario
    Planetrees
    Wall
    NE46 4EQ Hexham
    Northumberland
    British78876890002
    BROOKS, Charles David
    Planetrees
    Wall
    NE46 4EQ Hexham
    Northumberland
    Amministratore
    Planetrees
    Wall
    NE46 4EQ Hexham
    Northumberland
    EnglandBritish78876890002
    HUTCHINSON, Mark David
    15 Larkspur Close
    TS26 0WD Bishop Cuthbert
    Hartlepool
    Amministratore
    15 Larkspur Close
    TS26 0WD Bishop Cuthbert
    Hartlepool
    United KingdomBritish66723660002
    KELL, Darren Stephen
    Ashwick House
    Tranwell Woods
    NE61 6BH Morpeth
    Northumberland
    Amministratore
    Ashwick House
    Tranwell Woods
    NE61 6BH Morpeth
    Northumberland
    United KingdomBritish92136700001
    STANLEY, Roy Robert Edward
    16 Graham Park Road
    Gosforth
    NE3 4BH Newcastle Upon Tyne
    Amministratore
    16 Graham Park Road
    Gosforth
    NE3 4BH Newcastle Upon Tyne
    United KingdomBritish8609980002
    WRIGHT, Michael
    152 Whitehall Road
    NE8 1TP Gateshead
    Tyne & Wear
    Amministratore
    152 Whitehall Road
    NE8 1TP Gateshead
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish43664940002
    ROBINSON, Timothy Philip
    Stanegates Leazes Lane
    NE46 3BA Hexham
    Segretario
    Stanegates Leazes Lane
    NE46 3BA Hexham
    British18158790003
    ROGAN, Eileen Theresa
    54 York Street
    Pelaw
    NE10 0QL Gateshead
    Tyne & Wear
    Segretario nominato
    54 York Street
    Pelaw
    NE10 0QL Gateshead
    Tyne & Wear
    British900013580001
    THOMPSON, Robert Alfons
    5 Oakdale
    Nedderton Village
    NE22 6BE Bedlington
    Northumberland
    Segretario
    5 Oakdale
    Nedderton Village
    NE22 6BE Bedlington
    Northumberland
    British51515430004
    WARD, David
    69 Langdale Way
    The Pastures
    NE36 0UF East Boldon
    Tyne & Wear
    Segretario
    69 Langdale Way
    The Pastures
    NE36 0UF East Boldon
    Tyne & Wear
    British79459910001
    YOUNG, Ronald Desmond
    42 Commissioners Wharf
    NE29 6DN North Shields
    Tyne & Wear
    Segretario
    42 Commissioners Wharf
    NE29 6DN North Shields
    Tyne & Wear
    British67962880001
    BALL, Andrew Derek
    The Barn
    3 Devonshire House
    BD20 8EU Lothersdale
    Keighley
    Amministratore
    The Barn
    3 Devonshire House
    BD20 8EU Lothersdale
    Keighley
    United KingdomBritish93558090001
    CLARK, Andrew
    4 West Farm
    North Road
    NE36 0DQ East Boldon
    Tyne & Wear
    Amministratore
    4 West Farm
    North Road
    NE36 0DQ East Boldon
    Tyne & Wear
    British86171080001
    GORDON, Jennifer
    The Old School
    Church Lane
    NE44 6DS Riding Mill
    Northumberland
    Amministratore
    The Old School
    Church Lane
    NE44 6DS Riding Mill
    Northumberland
    British72057320004
    HEWITT, Colin Thompson
    Middlesbrook
    Darras Hall Ponteland
    NE20 9XH Darras Hall
    7
    Newcastle Upon Tyne
    Amministratore
    Middlesbrook
    Darras Hall Ponteland
    NE20 9XH Darras Hall
    7
    Newcastle Upon Tyne
    United KingdomBritish146097790001
    MCDONALD, Ian James
    41 Beatty Avenue
    Jesmond
    NE2 3QN Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Amministratore
    41 Beatty Avenue
    Jesmond
    NE2 3QN Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British62710670001
    MURTAGH, Kevin
    27 Grosvenor Way
    Chapel Park Estate
    NE5 1SF Newcastle Upon Tyne
    Amministratore
    27 Grosvenor Way
    Chapel Park Estate
    NE5 1SF Newcastle Upon Tyne
    British72057280001
    RHODES, Stuart
    22 Butterwick Gardens
    LS22 6GX Wetherby
    West Yorkshire
    Amministratore
    22 Butterwick Gardens
    LS22 6GX Wetherby
    West Yorkshire
    British61033980001
    ROBINSON, Alexander Charles
    Church Barn
    Arkendale
    HG5 0QT Knaresborough
    North Yorkshire
    Amministratore
    Church Barn
    Arkendale
    HG5 0QT Knaresborough
    North Yorkshire
    EnglandBritish75636850001
    ROBINSON, Timothy Philip
    Stanegates Leazes Lane
    NE46 3BA Hexham
    Amministratore
    Stanegates Leazes Lane
    NE46 3BA Hexham
    United KingdomBritish18158790003
    ROGAN, Eileen Theresa
    54 York Street
    Pelaw
    NE10 0QL Gateshead
    Tyne & Wear
    Amministratore delegato nominato
    54 York Street
    Pelaw
    NE10 0QL Gateshead
    Tyne & Wear
    British900013580001
    WARD, David
    69 Langdale Way
    The Pastures
    NE36 0UF East Boldon
    Tyne & Wear
    Amministratore
    69 Langdale Way
    The Pastures
    NE36 0UF East Boldon
    Tyne & Wear
    British79459910001
    YOUNG, Ronald Desmond
    42 Commissioners Wharf
    NE29 6DN North Shields
    Tyne & Wear
    Amministratore
    42 Commissioners Wharf
    NE29 6DN North Shields
    Tyne & Wear
    British67962880001

    TES 2013 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Supplemental chattel mortgage
    Creato il 19 ott 2011
    Consegnato il 27 ott 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Bystronic s/no 2105 model bystar 4020 cnc laser cutter load system with machine no. 2105 equipment no. 10009983 laser type bylaser 4400 s/no R0411232, bystronic s/no 258 model bysprint 3015 cnc laser bystronic loader with s/no 258 job no K990210 machine c/w laser, haas s/no 7517 model VF4 cnc vmc yom 1996 c/w toolchanger tooling and haas cnc control for details of further assets charged please refer to form MG01 see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • State Securities PLC
    Transazioni
    • 27 ott 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Chattel mortage
    Creato il 31 dic 2005
    Consegnato il 19 gen 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Pullmax bystronic bysprint 3015 cnc laser profile cutting machine serial no/ K990210(1999), pullmax pullmatic 126 cnc turret punch serial no/ 45000-66(2000) and pillmax ekp optima 160 4.13.15 cnc press brake serial no/ 4087(1989) for details of further chattels charges please refer to form 395 together with the benefit of any guarantees, warranties and other secured amounts. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Five Arrows Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 19 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 31 dic 2005
    Consegnato il 19 gen 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Five Arrows Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 19 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    All assets debenture (including qualifying floating charge)
    Creato il 19 mag 2005
    Consegnato il 28 mag 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Five Arrows Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 28 mag 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 25 giu 2001
    Consegnato il 28 giu 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 28 giu 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 mag 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 28 set 1999
    Consegnato il 01 ott 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 01 ott 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 set 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    TES 2013 LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    07 apr 2015Fine dell'amministrazione
    22 nov 2013Inizio dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Linda Ann Farish
    Rmt
    Gosforth Park Avenue
    NE12 8EG Newcastle Upon Tyne
    Praticante
    Rmt
    Gosforth Park Avenue
    NE12 8EG Newcastle Upon Tyne
    Anthony Alan Josephs
    Rmt
    Gosforth Park Avenue
    NE12 8EG Newcastle Upon Tyne
    Praticante
    Rmt
    Gosforth Park Avenue
    NE12 8EG Newcastle Upon Tyne
    2
    DataTipo
    24 gen 2019Data prevista di scioglimento
    07 apr 2015Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Emily Thompson
    Patrick House Gosforth Park Avenue
    Newcastle Upon Tyne
    Tyne And Wear
    Praticante
    Patrick House Gosforth Park Avenue
    Newcastle Upon Tyne
    Tyne And Wear
    Linda Ann Farish
    Rmt
    Gosforth Park Avenue
    NE12 8EG Newcastle Upon Tyne
    Liquidatore proposto
    Rmt
    Gosforth Park Avenue
    NE12 8EG Newcastle Upon Tyne
    Anthony Alan Josephs
    Rmt
    Gosforth Park Avenue
    NE12 8EG Newcastle Upon Tyne
    Liquidatore proposto
    Rmt
    Gosforth Park Avenue
    NE12 8EG Newcastle Upon Tyne

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0