TLC (TENDER LOVING CHILDCARE) LIMITED

TLC (TENDER LOVING CHILDCARE) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTLC (TENDER LOVING CHILDCARE) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03808866
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TLC (TENDER LOVING CHILDCARE) LIMITED?

    • Istruzione prescolare (85100) / Istruzione

    Dove si trova TLC (TENDER LOVING CHILDCARE) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Busy Bees At St Matthews
    Shaftesbury Drive
    WS7 9QP Burntwood
    Staffordshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TLC (TENDER LOVING CHILDCARE) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    TLC NEXUS LIMITED16 dic 199916 dic 1999
    SHELFCO (NO.1717) LIMITED16 lug 199916 lug 1999

    Quali sono gli ultimi bilanci di TLC (TENDER LOVING CHILDCARE) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per TLC (TENDER LOVING CHILDCARE) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Cessazione della carica di Lynn Carol Woodward come amministratore in data 01 dic 2012

    1 pagineTM01

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio annuale redatto al 16 lug 2012 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital19 lug 2012

    Stato del capitale al 19 lug 2012

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    21 pagineAA

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio annuale redatto al 16 lug 2011 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    6 pagineMG01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 23 dic 2010

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Share premium account reduced to nil 22/12/2010
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio annuale redatto al 16 lug 2010 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    20 pagineAA

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 30 giu 2009 al 31 dic 2009

    1 pagineAA01

    legacy

    5 pagine363a

    legacy

    17 pagine395

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di modifica degli Articoli di Associazione

    RES01

    Bilancio redatto al 30 giu 2008

    22 pagineAA

    Dimissioni del revisore

    2 pagineAUD

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    legacy

    2 pagine88(2)

    Chi sono gli amministratori di TLC (TENDER LOVING CHILDCARE) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    IRONS, Simon Andrew
    The Cottage
    The Grange High Street
    ST14 8LD Marchington
    Segretario
    The Cottage
    The Grange High Street
    ST14 8LD Marchington
    BritishChartered Accountant55976790005
    IRONS, Simon Andrew
    The Cottage
    The Grange High Street
    ST14 8LD Marchington
    Amministratore
    The Cottage
    The Grange High Street
    ST14 8LD Marchington
    EnglandBritishChartered Accountant55976790005
    RANDLES, Margaret Josephine
    222 Beacon Street
    WS13 7BH Lichfield
    Staffordshire
    Amministratore
    222 Beacon Street
    WS13 7BH Lichfield
    Staffordshire
    EnglandBritishDirector9070120002
    WOODWARD, John Brian
    75 Upper Way
    Upper Longdon
    WS15 1QD Rugeley
    Staffordshire
    Amministratore
    75 Upper Way
    Upper Longdon
    WS15 1QD Rugeley
    Staffordshire
    EnglandBritishDirector9070090003
    BAKER, Barbara
    Bridge House
    2 Swinnertons Lane Yelvertoft
    NN6 6LS Northampton
    Northamptonshire
    Segretario
    Bridge House
    2 Swinnertons Lane Yelvertoft
    NN6 6LS Northampton
    Northamptonshire
    BritishNurse58817820002
    BAKER, Barbara
    Bridge House
    2 Swinnertons Lane Yelvertoft
    NN6 6LS Northampton
    Northamptonshire
    Segretario
    Bridge House
    2 Swinnertons Lane Yelvertoft
    NN6 6LS Northampton
    Northamptonshire
    BritishNurse58817820002
    ROBINSON, Richard
    11 The Courtyard
    Stoke Golding
    CV13 6EX Nuneaton
    Warwickshire
    Segretario
    11 The Courtyard
    Stoke Golding
    CV13 6EX Nuneaton
    Warwickshire
    BritishNone107829020001
    STONE, David Michael
    The Paddocks 147 Gillway Lane
    B79 8PN Tamworth
    Staffordshire
    Segretario
    The Paddocks 147 Gillway Lane
    B79 8PN Tamworth
    Staffordshire
    BritishChartered Accountant57522290001
    TURNER, Nicholas Robert
    15 Manor Gardens
    Desford
    LE9 9QB Leicester
    Leicestershire
    Segretario
    15 Manor Gardens
    Desford
    LE9 9QB Leicester
    Leicestershire
    British123183150001
    E P S SECRETARIES LIMITED
    50 Stratton Street
    W1X 6NX London
    Segretario nominato
    50 Stratton Street
    W1X 6NX London
    900004930001
    NEXUS MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    Alexandra House
    Alexandra Terrace
    GU1 3DA Guildford
    Surrey
    Segretario
    Alexandra House
    Alexandra Terrace
    GU1 3DA Guildford
    Surrey
    57253330001
    BAKER, Barbara
    Bridge House
    2 Swinnertons Lane Yelvertoft
    NN6 6LS Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    Bridge House
    2 Swinnertons Lane Yelvertoft
    NN6 6LS Northampton
    Northamptonshire
    United KingdomBritishDirector58817820002
    GRIFFIN, Catherine Margaret
    30 Finmere
    CV21 1RT Rugby
    Warwickshire
    Amministratore
    30 Finmere
    CV21 1RT Rugby
    Warwickshire
    BritishDirector58817810002
    HYMAN, Harry Abraham
    Tara House Cleardown
    The Hockering
    GU22 7HH Woking
    Surrey
    Amministratore
    Tara House Cleardown
    The Hockering
    GU22 7HH Woking
    Surrey
    United KingdomBritishChartered Accountant35560380001
    KELLY, Bernard Noel David
    72 Piper Buildings
    Peterborough Road
    SW6 3EF London
    Amministratore
    72 Piper Buildings
    Peterborough Road
    SW6 3EF London
    EnglandBritishCompany Director111133320001
    ROBINSON, Richard
    11 The Courtyard
    Stoke Golding
    CV13 6EX Nuneaton
    Warwickshire
    Amministratore
    11 The Courtyard
    Stoke Golding
    CV13 6EX Nuneaton
    Warwickshire
    BritishNone107829020001
    STONE, David Michael
    The Paddocks 147 Gillway Lane
    B79 8PN Tamworth
    Staffordshire
    Amministratore
    The Paddocks 147 Gillway Lane
    B79 8PN Tamworth
    Staffordshire
    EnglandBritishChartered Accountant57522290001
    TEMPLE, John
    3 Victoria Crescent
    Queens Park
    CH4 7AX Chester
    Amministratore
    3 Victoria Crescent
    Queens Park
    CH4 7AX Chester
    BritishCompany Director62721620002
    TURNER, Nicholas Robert
    15 Manor Gardens
    Desford
    LE9 9QB Leicester
    Leicestershire
    Amministratore
    15 Manor Gardens
    Desford
    LE9 9QB Leicester
    Leicestershire
    EnglandBritishFinance Director123183150001
    WOODWARD, Lynn Carol
    33 Cherry Orchard
    WS14 9AN Lichfield
    Staffordshire
    Amministratore
    33 Cherry Orchard
    WS14 9AN Lichfield
    Staffordshire
    EnglandBritishDirector3850190004
    MIKJON LIMITED
    50 Stratton Street
    W1X 5FL London
    Amministratore delegato nominato
    50 Stratton Street
    W1X 5FL London
    900004920001

    TLC (TENDER LOVING CHILDCARE) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Composite debenture
    Creato il 21 dic 2010
    Consegnato il 30 dic 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC (As Security Trustee)
    Transazioni
    • 30 dic 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 20 set 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of accession
    Creato il 05 giu 2009
    Consegnato il 16 giu 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Princess christian college wilbraham road fallowfields manchester. Chester street, aston lock south birmingham, land on the west side of manton lane bedford. For further properties please see form 395 see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 16 giu 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 feb 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Rent deposit deed
    Creato il 12 ott 2007
    Consegnato il 19 ott 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    A cash sum of £20,362.50 and any additional sums deposited under the terms of the rent deposit deed.
    Persone aventi diritto
    • Gml Construction Limited
    Transazioni
    • 19 ott 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 nov 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 10 ott 2006
    Consegnato il 19 ott 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All land all the goodwill and uncalled capital the securities the debts and fixed plant and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nexus Structured Finance Limited
    Transazioni
    • 19 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment by way of security of the benefit of a building contract
    Creato il 15 set 2004
    Consegnato il 22 set 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The entire beneficial interest in and benefit to the mortgagor of the building contract dated 29 march 2004.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 22 set 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over development agreement and childcare agreement
    Creato il 15 set 2004
    Consegnato il 22 set 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the benefit of the company's interest the development agreement dated 13TH september 2004 all the benefit of the company's interest in the childcare agreement dated 13TH september 2004,all rights,titles,benefits and interests of the company whatsoever present and future whether proprietary,contractual or otherwise arising out of or connected with or relating to the development agreement and childcare agreement including without limitation all claims for damages in respect of any breach thereof.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 22 set 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 15 set 2004
    Consegnato il 22 set 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a hillingdon hospital childcare facility,hillingdon hospital,pield heath road,uxbridge. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 22 set 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 03 giu 2003
    Consegnato il 11 giu 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the l/h property known as child care unit, milton keynes general hospital, milton. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 11 giu 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 13 gen 2003
    Consegnato il 01 feb 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nexus Structured Finance Limited
    Transazioni
    • 01 feb 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment by way of security of the benefit of a building contract
    Creato il 09 dic 2002
    Consegnato il 14 dic 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The entire beneficial interest in a building contract dated 31 july 2002.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 14 dic 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over agreement for lease
    Creato il 09 dic 2002
    Consegnato il 14 dic 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the benefit of the company's interest in agreement for lease. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 14 dic 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 16 lug 2002
    Consegnato il 18 lug 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H land at university park nottingham. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 18 lug 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 24 gen 2002
    Consegnato il 28 gen 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The leasehold property known as land at university park, nottingham. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 28 gen 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 12 nov 2001
    Consegnato il 20 nov 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The day care centre nottingham city hospital huchwall road nottingham. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 20 nov 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment of keyman life policy
    Creato il 12 nov 2001
    Consegnato il 20 nov 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Policy number 10C51H11 on the life of david stone for the sum assured of £333,000, policy number 91B36B58 on the life of catherine griffin for the sum assured of £500,000 and policy number 91B36X65 on the life of barbara baker for the sum assured of £500,000 all policies are with j rothschild. All sums assured by the policies and all bonuses and benefits. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 20 nov 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 12 nov 2001
    Consegnato il 20 nov 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 20 nov 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 24 nov 2000
    Consegnato il 13 dic 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Murray Vct 3 PLC
    Transazioni
    • 13 dic 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 24 nov 2000
    Consegnato il 13 dic 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Murray Vct 4 PLC
    Transazioni
    • 13 dic 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 14 dic 1999
    Consegnato il 24 dic 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nexus Structured Finance Limited,as Security Trustee
    Transazioni
    • 24 dic 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 dic 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0