MONEYBOX CORPORATION LIMITED

MONEYBOX CORPORATION LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMONEYBOX CORPORATION LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03823774
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MONEYBOX CORPORATION LIMITED?

    • Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova MONEYBOX CORPORATION LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o CARDTRONICS UK LIMITED
    Building 4, Trident Place Trident Place
    Mosquito Way
    AL10 9UL Hatfield
    Hertfordshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MONEYBOX CORPORATION LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CARDPOINT SERVICES LIMITED31 dic 200231 dic 2002
    CASH CARD SERVICES LIMITED11 ago 199911 ago 1999

    Quali sono gli ultimi bilanci di MONEYBOX CORPORATION LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per MONEYBOX CORPORATION LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per MONEYBOX CORPORATION LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01
    A3MO40CG

    legacy

    1 pagineSH20
    L3LJAMLF

    Stato del capitale al 27 nov 2014

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19
    L3LJAML7

    legacy

    1 pagineCAP-SS
    L3LJAMLN

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    capital

    Risoluzioni

    Reduction of share option reserve 21/11/2014
    RES13

    Cessazione della carica di Jeremy David Kraft come amministratore in data 30 set 2014

    1 pagineTM01
    X3L21FRC

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    7 pagineAA
    A3HHWVH4

    Bilancio annuale redatto al 30 lug 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    X3D6VTXT

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Eversheds House 70 Great Bridgewater Street Manchester M1 5ES United Kingdom a C/O Squire Patton Boggs (Uk) Llp (Ref: Csu) Rutland House 148 Edmund Street Birmingham B3 2JR

    1 pagineAD02
    X3D6VU3E

    Indirizzo della sede legale modificato da , Squire Sanders (Uk) Llp (Ref: Csu) Rutland House, 148 Edmund Street, Birmingham, B3 2JR, England in data 16 giu 2014

    1 pagineAD01
    X3A5Q0P5

    Nomina di Mr Jeremy David Kraft come amministratore in data 22 set 2013

    2 pagineAP01
    X2HQ5BE1

    Nomina di Michael Keller come segretario in data 07 ago 2013

    3 pagineAP03
    A2GZYX34

    Nomina di John Christopher Brewster come amministratore in data 07 ago 2013

    3 pagineAP01
    A2GZYX3C

    Nomina di Michael Keller come amministratore in data 07 ago 2013

    3 pagineAP01
    A2GZYX3K

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 30 set 2013 al 31 dic 2013

    1 pagineAA01
    X2GPYVV5

    Indirizzo della sede legale modificato da , Davidson House Gadbrook Park, Northwich, Cheshire, CW9 7TW in data 12 set 2013

    1 pagineAD01
    X2GPYVNE

    Cessazione della carica di Brenda Mary Hogan come segretario in data 07 ago 2013

    1 pagineTM02
    X2GPYVGR

    Cessazione della carica di Mark Simon Edwards come amministratore in data 01 set 2013

    1 pagineTM01
    X2GPYV8W

    Cessazione della carica di Michael John Maloney come amministratore in data 07 ago 2013

    1 pagineTM01
    X2GPYV78

    Bilancio annuale redatto al 31 lug 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    X2DRYJT6

    Bilancio redatto al 30 set 2012

    13 pagineAA
    A2BANU8R

    Bilancio annuale redatto al 31 lug 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    X1EW3Q3N

    Bilancio redatto al 30 set 2011

    13 pagineAA
    A1930F1L

    Chi sono gli amministratori di MONEYBOX CORPORATION LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    KELLER, Michael Edward
    c/o Cardtronics Uk Limited
    Trident Place
    Mosquito Way
    AL10 9UL Hatfield
    Building 4, Trident Place
    Hertfordshire
    England
    Segretario
    c/o Cardtronics Uk Limited
    Trident Place
    Mosquito Way
    AL10 9UL Hatfield
    Building 4, Trident Place
    Hertfordshire
    England
    American105857220002
    BREWSTER, John Christopher
    c/o Cardtronics Uk Limited
    Trident Place
    Mosquito Way
    AL10 9UL Hatfield
    Building 4, Trident Place
    Hertfordshire
    England
    Amministratore
    c/o Cardtronics Uk Limited
    Trident Place
    Mosquito Way
    AL10 9UL Hatfield
    Building 4, Trident Place
    Hertfordshire
    England
    UsaAmericanChief Financial Officer181428100001
    KELLER, Michael Edward
    c/o Cardtronics Uk Limited
    Trident Place
    Mosquito Way
    AL10 9UL Hatfield
    Building 4, Trident Place
    Hertfordshire
    England
    Amministratore
    c/o Cardtronics Uk Limited
    Trident Place
    Mosquito Way
    AL10 9UL Hatfield
    Building 4, Trident Place
    Hertfordshire
    England
    UsaAmericanGeneral Counsel105857220002
    GREGSON, Robin Anthony
    2 Lakeside
    East Morton
    BD20 5UY Keighley
    West Yorkshire
    Segretario
    2 Lakeside
    East Morton
    BD20 5UY Keighley
    West Yorkshire
    EnglishDirector107835250001
    HANSON, David Christopher
    The Maltings
    Highfield Court Cross Lane
    HD8 8BG Huddersfield
    Segretario
    The Maltings
    Highfield Court Cross Lane
    HD8 8BG Huddersfield
    BritishDirector119682940001
    HOGAN, Brenda Mary
    Sandyford View Simonsridge
    Blackglen Road Sandyford
    Dublin 18
    Apartment 55,
    Ireland
    Segretario
    Sandyford View Simonsridge
    Blackglen Road Sandyford
    Dublin 18
    Apartment 55,
    Ireland
    Other130814140001
    LANIGAN, Philip Nicholas
    120 Buckingham Road
    SK4 4RG Stockport
    Cheshire
    Segretario
    120 Buckingham Road
    SK4 4RG Stockport
    Cheshire
    BritishDirector42734310002
    MILLS, Mark Richard
    55 Hove Road
    FY8 1XH Lytham St Annes
    Lancashire
    Segretario
    55 Hove Road
    FY8 1XH Lytham St Annes
    Lancashire
    BritishDirector10402540005
    HL SECRETARIES LIMITED
    St James's Court
    Brown Street
    M2 2JF Manchester
    Lancashire
    Segretario
    St James's Court
    Brown Street
    M2 2JF Manchester
    Lancashire
    66785830001
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Segretario nominato
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    EDWARDS, Mark Simon
    2 Brook House Court
    Lakeside Road
    WA13 0GR Lymm
    Cheshire
    Amministratore
    2 Brook House Court
    Lakeside Road
    WA13 0GR Lymm
    Cheshire
    BritishFinance Director109659860001
    GREGSON, Robin Anthony
    2 Lakeside
    East Morton
    BD20 5UY Keighley
    West Yorkshire
    Amministratore
    2 Lakeside
    East Morton
    BD20 5UY Keighley
    West Yorkshire
    EnglandEnglishDirector107835250001
    HANSON, David Christopher
    The Maltings
    Highfield Court Cross Lane
    HD8 8BG Huddersfield
    Amministratore
    The Maltings
    Highfield Court Cross Lane
    HD8 8BG Huddersfield
    EnglandBritishFinance Director119682940001
    KRAFT, Jeremy David
    Avenue Gardens
    TW11 0BH Teddington
    27
    Middlesex
    England
    Amministratore
    Avenue Gardens
    TW11 0BH Teddington
    27
    Middlesex
    England
    United KingdomBritishChartered Accountant71360190003
    LANIGAN, Philip Nicholas
    120 Buckingham Road
    SK4 4RG Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    120 Buckingham Road
    SK4 4RG Stockport
    Cheshire
    EnglandBritishDirector42734310002
    MALONEY, Michael John
    Beechwood Road
    Ranelagh
    8
    Dublin 6
    Ireland
    Amministratore
    Beechwood Road
    Ranelagh
    8
    Dublin 6
    Ireland
    IrelandIrishDirector161364970001
    MILLS, Mark Richard
    3 Neptune Court
    FY4 5LZ Blackpool
    Lancashire
    Amministratore
    3 Neptune Court
    FY4 5LZ Blackpool
    Lancashire
    United KingdomBritishDirector10402540008
    MILLS, Nigel John
    55 Hove Road
    FY8 1XH Lytham St Annes
    Lancashire
    Amministratore
    55 Hove Road
    FY8 1XH Lytham St Annes
    Lancashire
    EnglandBritishDirector35371340003
    MURPHY, James Timmerman
    Park Ave #10c
    Nyc
    1120
    10728 New York
    Usa
    Amministratore
    Park Ave #10c
    Nyc
    1120
    10728 New York
    Usa
    AmericanDirector130237490001
    SAXTON, Paul
    19 Ashdale Close
    ST7 2EN Alsager
    Staffordshire
    Amministratore
    19 Ashdale Close
    ST7 2EN Alsager
    Staffordshire
    BritishDirector121726830001
    SMYTH, Peter Francis
    Flat 2 62 Queens Gate
    SW7 5JP London
    Amministratore
    Flat 2 62 Queens Gate
    SW7 5JP London
    IrishDirector63863190002
    TURRELL, Mary Margaret
    1 St Catherine Drive
    Hartford
    CW8 2FE Northwich
    Cheshire
    Amministratore
    1 St Catherine Drive
    Hartford
    CW8 2FE Northwich
    Cheshire
    EnglandBritishFinance Director92654710001
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Amministratore delegato nominato
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001

    MONEYBOX CORPORATION LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A confirmatory security agreement
    Creato il 09 apr 2010
    Consegnato il 13 apr 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due of each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Agent)
    Transazioni
    • 13 apr 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 18 nov 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A security agreement
    Creato il 05 dic 2007
    Consegnato il 15 dic 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the parent and each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Agent)
    Transazioni
    • 15 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 nov 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Rent deposit deed
    Creato il 09 ott 2006
    Consegnato il 12 ott 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The deposit balance. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Electricity Supply Nominees (Scotland) Limited
    Transazioni
    • 12 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Intercreditor deed
    Creato il 25 ago 2005
    Consegnato il 06 set 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any member of the group to any finance party, or any obligor to any hedge counterparty under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Until after the discharge date, if the company receives or recovers ant intra-group recoveries exceptfor any permitted intra-group payments, it shall pay all such assets and monies received or recovered by it (the turnover receipts) to the security trustee for application in accordance with clause 10 (application of recoveries) of the deed. Pending such payment to the security trustee, the company shall hold the same on trust for application by the security trustee in accordance with clause 10 (application of recoveries) of the deed. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland in Its Capacity as Security Trustee on Behalfof the Finance Parties (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 06 set 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 dic 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Syndicated debenture
    Creato il 14 lug 2005
    Consegnato il 22 lug 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland in Its Capacity as Trustee for the Beneficiariaries
    Transazioni
    • 22 lug 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 dic 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Share charge
    Creato il 30 giu 2003
    Consegnato il 02 lug 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The investments which are the securities and the derivative assets (as further defined therein). See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 02 lug 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 dic 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 30 set 2002
    Consegnato il 04 ott 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 04 ott 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 dic 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 15 giu 2000
    Consegnato il 16 giu 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Grovefield Finance Limited
    Transazioni
    • 16 giu 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 giu 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0