EXTRA MSA SERVICES LIMITED

EXTRA MSA SERVICES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàEXTRA MSA SERVICES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03829281
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di EXTRA MSA SERVICES LIMITED?

    • (7020) /

    Dove si trova EXTRA MSA SERVICES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Peterborough Services Great North Road
    Haddon
    PE7 3UQ Peterborough
    Cambridgeshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di EXTRA MSA SERVICES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    EXTRA-MSA SERVICES LIMITED25 ott 199925 ott 1999
    HAMSARD 5052 LIMITED20 ago 199920 ago 1999

    Quali sono gli ultimi bilanci di EXTRA MSA SERVICES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al06 ott 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per EXTRA MSA SERVICES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    legacy

    9 pagineMG04

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Cessazione della carica di Craig Stuart Beevers come amministratore in data 13 mag 2011

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 20 ago 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital25 ago 2011

    Stato del capitale al 25 ago 2011

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Nomina di Mr Trishul Thakore come amministratore

    3 pagineAP01

    Bilancio redatto al 06 ott 2010

    20 pagineAA

    Varie

    Section 519
    2 pagineMISC

    Varie

    Section 519
    2 pagineMISC

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 30 apr 2010 al 06 ott 2010

    1 pagineAA01

    Indirizzo della sede legale modificato da 1 Castle Hill Lincoln Lincolnshire LN1 3AA in data 05 nov 2010

    2 pagineAD01

    Nomina di Harold Denis Mccarney come segretario

    3 pagineAP03

    Nomina di Harold Denis Mccarney come amministratore

    3 pagineAP01

    Nomina di Mr Craig Stuart Beevers come amministratore

    3 pagineAP01

    legacy

    3 pagineMG02

    Cessazione della carica di Robert Wade come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Timothy Spouge come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Stephen Spouge come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Gordon Pullan come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Geoffrey Goodwill come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Gordon Pullan come segretario

    1 pagineTM02

    legacy

    38 pagineMG01

    Bilancio annuale redatto al 20 ago 2010 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    Chi sono gli amministratori di EXTRA MSA SERVICES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MCCARNEY, Harold Denis
    Piccadilly
    W1J 9ER London
    6th Floor 180
    England
    Segretario
    Piccadilly
    W1J 9ER London
    6th Floor 180
    England
    British155467620001
    MCCARNEY, Harold Denis
    Piccadilly
    W1J 9ER London
    6th Floor 180
    Amministratore
    Piccadilly
    W1J 9ER London
    6th Floor 180
    United KingdomIrishDirector90469430002
    THAKORE, Trishul
    Piccadily
    W1J 9ER London
    6th Floor 180
    Amministratore
    Piccadily
    W1J 9ER London
    6th Floor 180
    United KingdomBritishDirector159206370001
    CROOKS, Michael Clive
    1 Sykes Close
    HU14 3GD Swanland
    East Yorkshire
    Segretario
    1 Sykes Close
    HU14 3GD Swanland
    East Yorkshire
    BritishFinancial Director48504730008
    PULLAN, Gordon Waite
    The Water Tower
    Potterhanworth
    LN4 2DN Lincoln
    Segretario
    The Water Tower
    Potterhanworth
    LN4 2DN Lincoln
    BritishChartered Accountant72016900002
    HAMMOND SUDDARDS SECRETARIES LIMITED
    7 Devonshire Square
    EC2M 4YH London
    Segretario nominato
    7 Devonshire Square
    EC2M 4YH London
    900008750001
    BEEVERS, Craig Stuart
    Piccadilly
    W1J 9ER London
    6th Floor 180
    England
    Amministratore
    Piccadilly
    W1J 9ER London
    6th Floor 180
    England
    EnglandBritishDirector103311310001
    CROOKS, Michael Clive
    1 Sykes Close
    HU14 3GD Swanland
    East Yorkshire
    Amministratore
    1 Sykes Close
    HU14 3GD Swanland
    East Yorkshire
    United KingdomBritishFinancial Director48504730008
    FISH, Andrew Stuart
    15 Wensley Avenue
    Chapel Allerton
    LS7 3QX Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    15 Wensley Avenue
    Chapel Allerton
    LS7 3QX Leeds
    West Yorkshire
    BritishAccountant99181180001
    GOODWILL, Geoffrey Mortimer
    White Court
    5 Foxhill Drive, Weetwood
    LS16 5PG Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    White Court
    5 Foxhill Drive, Weetwood
    LS16 5PG Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritishChartered Surveyor100020003
    HEALEY, Edwin Dyson
    West Ella Hall
    West Ella Road West Ella
    HU10 7RP Hull
    East Yorkshire
    Amministratore
    West Ella Hall
    West Ella Road West Ella
    HU10 7RP Hull
    East Yorkshire
    EnglandBritishDirector1798990001
    HEALEY, Paul Dyson
    Woodhouse Grange
    Westfield Lane Raywell
    HU16 5YL Cottingham
    East Yorkshire
    Amministratore
    Woodhouse Grange
    Westfield Lane Raywell
    HU16 5YL Cottingham
    East Yorkshire
    United KingdomBritishDirector7349500003
    LONG, Andrew Edward
    The Old Rectory
    Rectory Road, Coleby
    LN5 0AJ Lincoln
    Lincolnshire
    Amministratore
    The Old Rectory
    Rectory Road, Coleby
    LN5 0AJ Lincoln
    Lincolnshire
    United KingdomBritishChartered Surveyor2537680002
    PULLAN, Gordon Waite
    The Water Tower
    Potterhanworth
    LN4 2DN Lincoln
    Amministratore
    The Water Tower
    Potterhanworth
    LN4 2DN Lincoln
    EnglandBritishChartered Accountant72016900002
    SPOUGE, Stephen William
    1 Castle Hill
    Lincoln
    LN1 3AA Lincolnshire
    Amministratore
    1 Castle Hill
    Lincoln
    LN1 3AA Lincolnshire
    EnglandBritishDirector2537020001
    SPOUGE, Stephen William
    The Grange Barlings
    Langworth
    LN3 5DG Lincoln
    Lincolnshire
    Amministratore
    The Grange Barlings
    Langworth
    LN3 5DG Lincoln
    Lincolnshire
    EnglandBritishProperty Developer2537020001
    SPOUGE, Timothy James
    The Grange
    Barlings, Langworth
    LN3 5DG Lincoln
    Lincolnshire
    Amministratore
    The Grange
    Barlings, Langworth
    LN3 5DG Lincoln
    Lincolnshire
    United KingdomBritishOperations Director46349280001
    SWALES, Paul Nigel
    9 Hartley Park Avenue
    WF8 4AW Pontefract
    West Yorkshire
    Amministratore
    9 Hartley Park Avenue
    WF8 4AW Pontefract
    West Yorkshire
    BritishAccountant42213720001
    WADE, Robert Alexander Mercer
    Vergers House
    1 The Old Palace Palace Road
    HG4 3HF Ripon
    Amministratore
    Vergers House
    1 The Old Palace Palace Road
    HG4 3HF Ripon
    United KingdomBritishConsultant14261170002
    HAMMOND SUDDARDS DIRECTORS LIMITED
    7 Devonshire Square
    EC2M 4YH London
    Amministratore delegato nominato
    7 Devonshire Square
    EC2M 4YH London
    900008740001

    EXTRA MSA SERVICES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 06 ott 2010
    Consegnato il 16 ott 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Agent
    Transazioni
    • 16 ott 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 13 apr 2012Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    Debenture
    Creato il 24 giu 2008
    Consegnato il 01 lug 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any of the finance parties on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC (As Security Trustee)
    Transazioni
    • 01 lug 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ott 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge and rental assignment
    Creato il 03 giu 2008
    Consegnato il 06 giu 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any of the finance parties (or any of them) on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Rights title and interest in and to the account balances, floating charge all rental income and any guarantee of rental income see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 06 giu 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 set 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite debenture
    Creato il 21 dic 2005
    Consegnato il 28 dic 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargor to any of the finance parties (or any of them) on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As "Security Trustee")
    Transazioni
    • 28 dic 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 set 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage and legal charge
    Creato il 21 dic 2005
    Consegnato il 05 gen 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land comprising two parcels of land lying to the south west of A1 haddon t/n CB180394 all its right title and interest in and to the f/h interest in the property and all buildings fixtures and fittings (including trade fixtures) from time to time thereon together with all rights easements and privileges appurtenant to or benefitting the same. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Texaco Limited
    Transazioni
    • 05 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 dic 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage and legal charge
    Creato il 21 dic 2005
    Consegnato il 05 gen 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property comprising land on the south side of huntingdon road lolworth t/n CB222657 all its right title and interest in and to the f/h interest in the property and all buildings fixtures and fittings (including trade fixtures) from time to time thereon together with all rights easements and privileges appurtenant to or benefitting the same. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Texaco Limited
    Transazioni
    • 05 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 dic 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage and legal charge
    Creato il 21 dic 2005
    Consegnato il 05 gen 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land on the north side of great north road radwell near baldock t/n HD329633 all its right title and interest in and to the f/h interest in the property and all buildings fixtures and fittings (including trade fixtures) from time to time thereon together with all rights easements and privileges appurtenant to or benefitting the same. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Texaco Limited
    Transazioni
    • 05 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 dic 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite debenture
    Creato il 11 giu 2004
    Consegnato il 18 giu 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H land being two parcels of land lying to the south west of the A1 haddon t/no CB180394, f/h land on the south west side huntingdon road lolworth t/no CB222657, f/h land on the north side of great north road radwell t/no HD329633. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 18 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 set 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security agreement between extra-msa services limited (the chargor) and bayerische hypo- und vereinsbank aktiengesellschaft, london branch (the agent) (the services security agreement)
    Creato il 05 apr 2000
    Consegnato il 11 apr 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities of each obligor (as defined) to any finance party (as defined) under each finance document (as defined)
    Brevi particolari
    Including f/h land on sw side of A14 (formerly A604) huntingdon road swavesey cambridge CB222657, f/h land on sw side of A1 motoway at haddon huntingdon cambs CB180394 and f/h land on north side of A1(m) at radwell north hertford herts HD329633. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Hypo- Und Vereinsbank Aktiengesellschaft, London Branch (The Agent)
    Transazioni
    • 11 apr 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 dic 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Secvurity agreement
    Creato il 20 dic 1999
    Consegnato il 24 dic 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee as agent and trustee for the finance parties (as defined in the credit agreement of even date) under each finance document (as threin defined)
    Brevi particolari
    Property as detailed on the continuation sheets attached to the form 395 by way of first fixed charge all property specified in the schedule to the securiity agreement and all estates or interests in any f/h or l/h property a floating charge over over all the assets etc S. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Stadium City Limited (The Agent)
    Transazioni
    • 24 dic 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 dic 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0