OPUS TRUST MARKETING LIMITED
Panoramica
Nome della società | OPUS TRUST MARKETING LIMITED |
---|---|
Stato della società | Attiva |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 03829462 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di OPUS TRUST MARKETING LIMITED?
- fabbricazione di articoli di cartoleria (17230) / Industrie manifatturiere
Dove si trova OPUS TRUST MARKETING LIMITED?
Indirizzo della sede legale | 133 Scudamore Road Braunstone Frith Industrial Estate LE3 1UQ Leicester |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di OPUS TRUST MARKETING LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
OPUS DIRECT MARKETING LIMITED | 12 mag 2000 | 12 mag 2000 |
SHELFCO (NO.1739) LIMITED | 20 ago 1999 | 20 ago 1999 |
Quali sono gli ultimi bilanci di OPUS TRUST MARKETING LIMITED?
Scaduto | No |
---|---|
Prossimi bilanci | |
Fine del prossimo esercizio al | 31 mar 2025 |
Scadenza dei prossimi bilanci il | 31 dic 2025 |
Ultimi bilanci | |
Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2024 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per OPUS TRUST MARKETING LIMITED?
Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 05 apr 2025 |
---|---|
Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 19 apr 2025 |
Ultima dichiarazione di conferma | |
Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 05 apr 2024 |
Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per OPUS TRUST MARKETING LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nomina di Shane William Joseph Woods come amministratore in data 23 dic 2024 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Nicholas Keegan come amministratore in data 23 dic 2024 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Pawel Jernas come amministratore in data 23 dic 2024 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Marcin Jernas come amministratore in data 23 dic 2024 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Andrew Charles Lindsey come amministratore in data 23 dic 2024 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Simon Christopher Johnson come amministratore in data 23 dic 2024 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Samantha Jayne Ghysen come segretario in data 23 dic 2024 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di John William Tew come amministratore in data 15 dic 2024 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
legacy | pagine | ANNOTATION | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 47 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Memorandum e Statuto | 45 pagine | MA | ||||||||||
Iscrizione dell'ipoteca 038294620007, creata il 23 dic 2024 | 61 pagine | MR01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 038294620005 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 038294620006 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Bilancio consolidato redatto al 31 mar 2024 | 53 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 05 apr 2024 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 10 feb 2024 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio consolidato redatto al 31 mar 2023 | 52 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Tom Graham Prestwich come amministratore in data 31 mar 2023 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 10 feb 2023 con aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio consolidato redatto al 31 mar 2022 | 49 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Allan Rowan come amministratore in data 01 dic 2022 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Andrew David Herd come amministratore in data 21 gen 2022 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Mrs Samantha Jayne Ghysen il 31 lug 2022 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 29 mar 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di OPUS TRUST MARKETING LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DICKSON, Christian Alexander Paul | Amministratore | c/o Adare Sec Ltd Wakefield Road Clayton West HD8 9QQ Huddersfield Park Mill England | England | British | Company Director | 208390720001 | ||||
HERD, Andrew David | Amministratore | Scudamore Road Braunstone Frith Industrial Estate LE3 1UQ Leicester 133 | England | British | Company Director | 129949980001 | ||||
JERNAS, Marcin | Amministratore | Scudamore Road Braunstone Frith Industrial Estate LE3 1UQ Leicester 133 | Poland | Polish | Chief Technology Officer | 332061240001 | ||||
JERNAS, Pawel | Amministratore | Scudamore Road Braunstone Frith Industrial Estate LE3 1UQ Leicester 133 | Ireland | Polish | Chief Product Officer | 332061590001 | ||||
KEEGAN, Nicholas | Amministratore | Scudamore Road Braunstone Frith Industrial Estate LE3 1UQ Leicester 133 | Ireland | Irish | Chief Executive Officer | 332061670001 | ||||
SAVAGE, Hayden John | Amministratore | Scudamore Road Braunstone Frith Industrial Estate LE3 1UQ Leicester 133 | England | British | Company Director | 255239970001 | ||||
STRONG, Anthony John | Amministratore | Scudamore Road Braunstone Frith Industrial Estate LE3 1UQ Leicester 133 | England | British | Company Director | 251441190002 | ||||
WOODS, Shane William Joseph | Amministratore | Scudamore Road Braunstone Frith Industrial Estate LE3 1UQ Leicester 133 | Ireland | Irish | Chief Financial Officer | 332061840001 | ||||
GHYSEN, Samantha Jayne | Segretario | Scudamore Road Braunstone Frith Industrial Estate LE3 1UQ Leicester 133 | 185952540002 | |||||||
LAVERY, Andrew Charles | Segretario | Scudamore Road Braunstone Frith Industrial Estate LE3 1UQ Leicester 133 England | British | 82900930001 | ||||||
RANDALL, John David | Segretario | 29 Gresham Avenue CT9 5EH Margate Kent | British | Director | 57217680001 | |||||
E P S SECRETARIES LIMITED | Segretario nominato | 50 Stratton Street W1X 6NX London | 900004930001 | |||||||
AGAR, Stephen | Amministratore | Scudamore Road Braunstone Frith Industrial Estate LE3 1UQ Leicester 133 | United Kingdom | British | Director | 287849740001 | ||||
BALL, Craig Dominic | Amministratore | Scudamore Road Braunstone Frith Industrial Estate LE3 1UQ Leicester 133 | United Kingdom | British | Director | 114361840001 | ||||
BARRATT, Colin Leslie Allen | Amministratore | Flat 3 15 Private Road Sherwood NG5 4DD Nottingham Nottinghamshire | England | British | Director | 67569480001 | ||||
BATH, Evan | Amministratore | Scudamore Road Braunstone Frith Industrial Estate LE3 1UQ Leicester 133 Leicestershire | England | British | Operations Director | 120466730001 | ||||
BOWEN, Ian | Amministratore | 14 Thornhill Road UB10 8SF Uxbridge Middlesex | British | Director | 101474900001 | |||||
BROUGH, Paul James | Amministratore | Scudamore Road Braunstone Frith Industrial Estate LE3 1UQ Leicester 133 England | United Kingdom | British | None | 180273640001 | ||||
BROWN, Roland | Amministratore | 18 Millcross BS21 5JL Clevedon North Somerset | British | Managing Director | 39595680001 | |||||
CLARK, Barry | Amministratore | Scudamore Road Braunstone Frith Industrial Estate LE3 1UQ Leicester 133 Leicestershire | England | British | It Director | 95985770001 | ||||
COLES, Michael Nicholas | Amministratore | 54 Bermondsey Street SE1 3UD London Woolyard Uk | United Kingdom | British | Director | 134854350001 | ||||
CORDY, Julian Peter | Amministratore | Home Farmhouse Church Lane OX25 3QS Wendlebury Oxfordshire | England | British | Director | 86414270001 | ||||
DE HAAN, Peter Charles | Amministratore | Scudamore Road Braunstone Frith Industrial Estate LE3 1UQ Leicester 133 England | United Kingdom | British | Company Director | 32531270009 | ||||
FARMER, Richard | Amministratore | Scudamore Road Braunstone Frith Industrial Estate LE3 1UQ Leicester 133 | England | British | Company Director | 250540630001 | ||||
GASS, Steven | Amministratore | 1 Clarkes Way NN11 5JJ Welton Northamptonshire | American | Director | 86414680001 | |||||
HETEM, Mark | Amministratore | Scudamore Road Braunstone Frith Industrial Estate LE1 1UQ Leicester 133 | England | British | Director | 180273510001 | ||||
HOWELL, Simon Leonard | Amministratore | Scudamore Road Braunstone Frith Industrial Estate LE3 1UQ Leicester 133 | England | British | Company Director | 126990880007 | ||||
JACKSON, Terence George | Amministratore | Glengarry 395 Thornaby Road Thornaby Village TS17 8QN Stockton On Tees | British | Sales-Marketing | 74363830001 | |||||
JOHNSON, Simon Christopher | Amministratore | Scudamore Road Braunstone Frith Industrial Estate LE3 1UQ Leicester 133 England | England | British | None | 110558260001 | ||||
LAVERY, Andrew Charles | Amministratore | Scudamore Road Braunstone Frith Industrial Estate LE3 1UQ Leicester 133 England | England | British | Director | 82900930001 | ||||
LINDSEY, Andrew Charles | Amministratore | Scudamore Road Braunstone Frith Industrial Estate LE3 1UQ Leicester 133 | England | British | Company Director | 151617210001 | ||||
MACAVOY, Anne-Marie | Amministratore | Scudamore Road Braunstone Frith Industrial Estate LE3 1UQ Leicester 133 | England | British | Company Director | 246195100001 | ||||
PAZOS-ALONSO, Luis Roberto | Amministratore | Scudamore Road Braunstone Frith Industrial Estate LE3 1UQ Leicester 133 | England | British | Director | 180014370001 | ||||
POWELL, Laurence Harold | Amministratore | 4 Appleby Way Scotton Gates HG5 9LX Knaresborough North Yorkshire | British | Company Director | 61295480001 | |||||
PRASHAD, Kris | Amministratore | Orchard Grange Main Street LE8 0PG Shangton Leicestershire | British | Director | 73621820002 |
Chi sono le persone con controllo significativo di OPUS TRUST MARKETING LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opus 107 Limited | 06 apr 2016 | 54 Bermondsey Street SE1 3UD London Woolyard England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
OPUS TRUST MARKETING LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Creato il 23 dic 2024 Consegnato il 06 gen 2025 | In corso | ||
Breve descrizione The intellectual property (as defined in the debenture) more particularly set out in schedule 2 part 7 of the debenture (intellectual property) including any patents, trade marks, service marks, designs, business names, copyrights, database rights, design rights, domain names, moral rights, inventions, confidential information, knowhow and other intellectual property rights and interests (which may now or in the future subsist), whether registered or unregistered and the benefit of all applications and rights to use such assets of each member of the group of companies of which opus trust marketing limited is a part(which may now or in the future subsists). L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 26 ott 2021 Consegnato il 27 ott 2021 | Soddisfatta integralmente | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 06 mag 2020 Consegnato il 07 mag 2020 | Soddisfatta integralmente | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 01 apr 2011 Consegnato il 02 apr 2011 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 30 set 2009 Consegnato il 14 ott 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Composite guarantee and debenture | Creato il 25 feb 2005 Consegnato il 11 mar 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any initial chargor to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 05 feb 2001 Consegnato il 07 feb 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0