OPUS TRUST MARKETING LIMITED

OPUS TRUST MARKETING LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàOPUS TRUST MARKETING LIMITED
    Stato della societàAttiva
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03829462
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di OPUS TRUST MARKETING LIMITED?

    • fabbricazione di articoli di cartoleria (17230) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova OPUS TRUST MARKETING LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    133 Scudamore Road
    Braunstone Frith Industrial Estate
    LE3 1UQ Leicester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di OPUS TRUST MARKETING LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    OPUS DIRECT MARKETING LIMITED12 mag 200012 mag 2000
    SHELFCO (NO.1739) LIMITED20 ago 199920 ago 1999

    Quali sono gli ultimi bilanci di OPUS TRUST MARKETING LIMITED?

    ScadutoNo
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 mar 2025
    Scadenza dei prossimi bilanci il31 dic 2025
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2024

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per OPUS TRUST MARKETING LIMITED?

    Ultima dichiarazione di conferma redatta al05 apr 2025
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma19 apr 2025
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al05 apr 2024
    ScadutoNo

    Quali sono le ultime deposizioni per OPUS TRUST MARKETING LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Nomina di Shane William Joseph Woods come amministratore in data 23 dic 2024

    2 pagineAP01

    Nomina di Nicholas Keegan come amministratore in data 23 dic 2024

    2 pagineAP01

    Nomina di Pawel Jernas come amministratore in data 23 dic 2024

    2 pagineAP01

    Nomina di Marcin Jernas come amministratore in data 23 dic 2024

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Andrew Charles Lindsey come amministratore in data 23 dic 2024

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Simon Christopher Johnson come amministratore in data 23 dic 2024

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Samantha Jayne Ghysen come segretario in data 23 dic 2024

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di John William Tew come amministratore in data 15 dic 2024

    1 pagineTM01

    legacy

    pagineANNOTATION

    Risoluzioni

    Resolutions
    47 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Memorandum e Statuto

    45 pagineMA

    Iscrizione dell'ipoteca 038294620007, creata il 23 dic 2024

    61 pagineMR01

    Soddisfazione dell'onere 038294620005 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 038294620006 in pieno

    4 pagineMR04

    Bilancio consolidato redatto al 31 mar 2024

    53 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 apr 2024 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 feb 2024 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio consolidato redatto al 31 mar 2023

    52 pagineAA

    Cessazione della carica di Tom Graham Prestwich come amministratore in data 31 mar 2023

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 feb 2023 con aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio consolidato redatto al 31 mar 2022

    49 pagineAA

    Cessazione della carica di Allan Rowan come amministratore in data 01 dic 2022

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Andrew David Herd come amministratore in data 21 gen 2022

    2 pagineAP01

    Dettagli del segretario cambiati per Mrs Samantha Jayne Ghysen il 31 lug 2022

    1 pagineCH03

    Dichiarazione di conformità presentata il 29 mar 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Chi sono gli amministratori di OPUS TRUST MARKETING LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    DICKSON, Christian Alexander Paul
    c/o Adare Sec Ltd
    Wakefield Road
    Clayton West
    HD8 9QQ Huddersfield
    Park Mill
    England
    Amministratore
    c/o Adare Sec Ltd
    Wakefield Road
    Clayton West
    HD8 9QQ Huddersfield
    Park Mill
    England
    EnglandBritishCompany Director208390720001
    HERD, Andrew David
    Scudamore Road
    Braunstone Frith Industrial Estate
    LE3 1UQ Leicester
    133
    Amministratore
    Scudamore Road
    Braunstone Frith Industrial Estate
    LE3 1UQ Leicester
    133
    EnglandBritishCompany Director129949980001
    JERNAS, Marcin
    Scudamore Road
    Braunstone Frith Industrial Estate
    LE3 1UQ Leicester
    133
    Amministratore
    Scudamore Road
    Braunstone Frith Industrial Estate
    LE3 1UQ Leicester
    133
    PolandPolishChief Technology Officer332061240001
    JERNAS, Pawel
    Scudamore Road
    Braunstone Frith Industrial Estate
    LE3 1UQ Leicester
    133
    Amministratore
    Scudamore Road
    Braunstone Frith Industrial Estate
    LE3 1UQ Leicester
    133
    IrelandPolishChief Product Officer332061590001
    KEEGAN, Nicholas
    Scudamore Road
    Braunstone Frith Industrial Estate
    LE3 1UQ Leicester
    133
    Amministratore
    Scudamore Road
    Braunstone Frith Industrial Estate
    LE3 1UQ Leicester
    133
    IrelandIrishChief Executive Officer332061670001
    SAVAGE, Hayden John
    Scudamore Road
    Braunstone Frith Industrial Estate
    LE3 1UQ Leicester
    133
    Amministratore
    Scudamore Road
    Braunstone Frith Industrial Estate
    LE3 1UQ Leicester
    133
    EnglandBritishCompany Director255239970001
    STRONG, Anthony John
    Scudamore Road
    Braunstone Frith Industrial Estate
    LE3 1UQ Leicester
    133
    Amministratore
    Scudamore Road
    Braunstone Frith Industrial Estate
    LE3 1UQ Leicester
    133
    EnglandBritishCompany Director251441190002
    WOODS, Shane William Joseph
    Scudamore Road
    Braunstone Frith Industrial Estate
    LE3 1UQ Leicester
    133
    Amministratore
    Scudamore Road
    Braunstone Frith Industrial Estate
    LE3 1UQ Leicester
    133
    IrelandIrishChief Financial Officer332061840001
    GHYSEN, Samantha Jayne
    Scudamore Road
    Braunstone Frith Industrial Estate
    LE3 1UQ Leicester
    133
    Segretario
    Scudamore Road
    Braunstone Frith Industrial Estate
    LE3 1UQ Leicester
    133
    185952540002
    LAVERY, Andrew Charles
    Scudamore Road
    Braunstone Frith Industrial Estate
    LE3 1UQ Leicester
    133
    England
    Segretario
    Scudamore Road
    Braunstone Frith Industrial Estate
    LE3 1UQ Leicester
    133
    England
    British82900930001
    RANDALL, John David
    29 Gresham Avenue
    CT9 5EH Margate
    Kent
    Segretario
    29 Gresham Avenue
    CT9 5EH Margate
    Kent
    BritishDirector57217680001
    E P S SECRETARIES LIMITED
    50 Stratton Street
    W1X 6NX London
    Segretario nominato
    50 Stratton Street
    W1X 6NX London
    900004930001
    AGAR, Stephen
    Scudamore Road
    Braunstone Frith Industrial Estate
    LE3 1UQ Leicester
    133
    Amministratore
    Scudamore Road
    Braunstone Frith Industrial Estate
    LE3 1UQ Leicester
    133
    United KingdomBritishDirector287849740001
    BALL, Craig Dominic
    Scudamore Road
    Braunstone Frith Industrial Estate
    LE3 1UQ Leicester
    133
    Amministratore
    Scudamore Road
    Braunstone Frith Industrial Estate
    LE3 1UQ Leicester
    133
    United KingdomBritishDirector114361840001
    BARRATT, Colin Leslie Allen
    Flat 3 15 Private Road
    Sherwood
    NG5 4DD Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Flat 3 15 Private Road
    Sherwood
    NG5 4DD Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritishDirector67569480001
    BATH, Evan
    Scudamore Road
    Braunstone Frith Industrial Estate
    LE3 1UQ Leicester
    133
    Leicestershire
    Amministratore
    Scudamore Road
    Braunstone Frith Industrial Estate
    LE3 1UQ Leicester
    133
    Leicestershire
    EnglandBritishOperations Director120466730001
    BOWEN, Ian
    14 Thornhill Road
    UB10 8SF Uxbridge
    Middlesex
    Amministratore
    14 Thornhill Road
    UB10 8SF Uxbridge
    Middlesex
    BritishDirector101474900001
    BROUGH, Paul James
    Scudamore Road
    Braunstone Frith Industrial Estate
    LE3 1UQ Leicester
    133
    England
    Amministratore
    Scudamore Road
    Braunstone Frith Industrial Estate
    LE3 1UQ Leicester
    133
    England
    United KingdomBritishNone180273640001
    BROWN, Roland
    18 Millcross
    BS21 5JL Clevedon
    North Somerset
    Amministratore
    18 Millcross
    BS21 5JL Clevedon
    North Somerset
    BritishManaging Director39595680001
    CLARK, Barry
    Scudamore Road
    Braunstone Frith Industrial Estate
    LE3 1UQ Leicester
    133
    Leicestershire
    Amministratore
    Scudamore Road
    Braunstone Frith Industrial Estate
    LE3 1UQ Leicester
    133
    Leicestershire
    EnglandBritishIt Director95985770001
    COLES, Michael Nicholas
    54 Bermondsey Street
    SE1 3UD London
    Woolyard
    Uk
    Amministratore
    54 Bermondsey Street
    SE1 3UD London
    Woolyard
    Uk
    United KingdomBritishDirector134854350001
    CORDY, Julian Peter
    Home Farmhouse
    Church Lane
    OX25 3QS Wendlebury
    Oxfordshire
    Amministratore
    Home Farmhouse
    Church Lane
    OX25 3QS Wendlebury
    Oxfordshire
    EnglandBritishDirector86414270001
    DE HAAN, Peter Charles
    Scudamore Road
    Braunstone Frith Industrial Estate
    LE3 1UQ Leicester
    133
    England
    Amministratore
    Scudamore Road
    Braunstone Frith Industrial Estate
    LE3 1UQ Leicester
    133
    England
    United KingdomBritishCompany Director32531270009
    FARMER, Richard
    Scudamore Road
    Braunstone Frith Industrial Estate
    LE3 1UQ Leicester
    133
    Amministratore
    Scudamore Road
    Braunstone Frith Industrial Estate
    LE3 1UQ Leicester
    133
    EnglandBritishCompany Director250540630001
    GASS, Steven
    1 Clarkes Way
    NN11 5JJ Welton
    Northamptonshire
    Amministratore
    1 Clarkes Way
    NN11 5JJ Welton
    Northamptonshire
    AmericanDirector86414680001
    HETEM, Mark
    Scudamore Road
    Braunstone Frith Industrial Estate
    LE1 1UQ Leicester
    133
    Amministratore
    Scudamore Road
    Braunstone Frith Industrial Estate
    LE1 1UQ Leicester
    133
    EnglandBritishDirector180273510001
    HOWELL, Simon Leonard
    Scudamore Road
    Braunstone Frith Industrial Estate
    LE3 1UQ Leicester
    133
    Amministratore
    Scudamore Road
    Braunstone Frith Industrial Estate
    LE3 1UQ Leicester
    133
    EnglandBritishCompany Director126990880007
    JACKSON, Terence George
    Glengarry
    395 Thornaby Road Thornaby Village
    TS17 8QN Stockton On Tees
    Amministratore
    Glengarry
    395 Thornaby Road Thornaby Village
    TS17 8QN Stockton On Tees
    BritishSales-Marketing74363830001
    JOHNSON, Simon Christopher
    Scudamore Road
    Braunstone Frith Industrial Estate
    LE3 1UQ Leicester
    133
    England
    Amministratore
    Scudamore Road
    Braunstone Frith Industrial Estate
    LE3 1UQ Leicester
    133
    England
    EnglandBritishNone110558260001
    LAVERY, Andrew Charles
    Scudamore Road
    Braunstone Frith Industrial Estate
    LE3 1UQ Leicester
    133
    England
    Amministratore
    Scudamore Road
    Braunstone Frith Industrial Estate
    LE3 1UQ Leicester
    133
    England
    EnglandBritishDirector82900930001
    LINDSEY, Andrew Charles
    Scudamore Road
    Braunstone Frith Industrial Estate
    LE3 1UQ Leicester
    133
    Amministratore
    Scudamore Road
    Braunstone Frith Industrial Estate
    LE3 1UQ Leicester
    133
    EnglandBritishCompany Director151617210001
    MACAVOY, Anne-Marie
    Scudamore Road
    Braunstone Frith Industrial Estate
    LE3 1UQ Leicester
    133
    Amministratore
    Scudamore Road
    Braunstone Frith Industrial Estate
    LE3 1UQ Leicester
    133
    EnglandBritishCompany Director246195100001
    PAZOS-ALONSO, Luis Roberto
    Scudamore Road
    Braunstone Frith Industrial Estate
    LE3 1UQ Leicester
    133
    Amministratore
    Scudamore Road
    Braunstone Frith Industrial Estate
    LE3 1UQ Leicester
    133
    EnglandBritishDirector180014370001
    POWELL, Laurence Harold
    4 Appleby Way
    Scotton Gates
    HG5 9LX Knaresborough
    North Yorkshire
    Amministratore
    4 Appleby Way
    Scotton Gates
    HG5 9LX Knaresborough
    North Yorkshire
    BritishCompany Director61295480001
    PRASHAD, Kris
    Orchard Grange
    Main Street
    LE8 0PG Shangton
    Leicestershire
    Amministratore
    Orchard Grange
    Main Street
    LE8 0PG Shangton
    Leicestershire
    BritishDirector73621820002

    Chi sono le persone con controllo significativo di OPUS TRUST MARKETING LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Opus 107 Limited
    54 Bermondsey Street
    SE1 3UD London
    Woolyard
    England
    06 apr 2016
    54 Bermondsey Street
    SE1 3UD London
    Woolyard
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneRegister Of Companies In England & Wales
    Numero di registrazione09366057
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    OPUS TRUST MARKETING LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 23 dic 2024
    Consegnato il 06 gen 2025
    In corso
    Breve descrizione
    The intellectual property (as defined in the debenture) more particularly set out in schedule 2 part 7 of the debenture (intellectual property) including any patents, trade marks, service marks, designs, business names, copyrights, database rights, design rights, domain names, moral rights, inventions, confidential information, knowhow and other intellectual property rights and interests (which may now or in the future subsist), whether registered or unregistered and the benefit of all applications and rights to use such assets of each member of the group of companies of which opus trust marketing limited is a part(which may now or in the future subsists).
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland (As Security Agent)
    Transazioni
    • 06 gen 2025Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 26 ott 2021
    Consegnato il 27 ott 2021
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Opus Trust Group Limited
    Transazioni
    • 27 ott 2021Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 26 ott 2024Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 06 mag 2020
    Consegnato il 07 mag 2020
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Rbs Invoice Finance LTD
    Transazioni
    • 07 mag 2020Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 13 dic 2024Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 01 apr 2011
    Consegnato il 02 apr 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 02 apr 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 17 gen 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 30 set 2009
    Consegnato il 14 ott 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 14 ott 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 17 gen 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 25 feb 2005
    Consegnato il 11 mar 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any initial chargor to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Opus 102 Limited as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Agent)
    Transazioni
    • 11 mar 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 nov 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 05 feb 2001
    Consegnato il 07 feb 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 07 feb 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 nov 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0