REC ASBESTOS (SOUTH) LIMITED

REC ASBESTOS (SOUTH) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàREC ASBESTOS (SOUTH) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03830216
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di REC ASBESTOS (SOUTH) LIMITED?

    • Altre attività professionali, scientifiche e tecniche n.c.a. (74909) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova REC ASBESTOS (SOUTH) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    2 Browns Road
    NN11 4NS Daventry
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di REC ASBESTOS (SOUTH) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    NOBLE HEALTH & SAFETY CONSULTANCY LIMITED23 ago 199923 ago 1999

    Quali sono gli ultimi bilanci di REC ASBESTOS (SOUTH) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2022

    Quali sono le ultime deposizioni per REC ASBESTOS (SOUTH) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    2 pagineDS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2022

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 giu 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2021

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 giu 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2020

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 giu 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da The Forge Blisworth Hill Farm Stoke Road Blisworth Northampton NN7 3DB England a 2 Browns Road Daventry NN11 4NS in data 17 lug 2020

    1 pagineAD01

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 dic 2019 al 31 mar 2020

    1 pagineAA01

    Cessazione della carica di Mark Carnegie-Brown come amministratore in data 10 ott 2019

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Paul Mccluskey come amministratore in data 10 ott 2019

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Paul Mcclusky come amministratore in data 10 ott 2019

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Matthew James Hanson come amministratore in data 10 ott 2019

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Jonathan Matthew Clements come amministratore in data 10 ott 2019

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Gregory John Kirkman come amministratore in data 10 ott 2019

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Richard Allen Assenheim come amministratore in data 10 ott 2019

    2 pagineAP01

    Indirizzo della sede legale modificato da One St Peter's Square Manchester M2 3DE United Kingdom a The Forge Blisworth Hill Farm Stoke Road Blisworth Northampton NN7 3DB in data 15 ott 2019

    1 pagineAD01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018

    5 pagineAA

    Nomina di Dr Mark Carnegie-Brown come amministratore in data 05 ago 2019

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 giu 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Nomina di Matthew James Hanson come amministratore in data 03 giu 2019

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Mark Calderbank come amministratore in data 14 giu 2019

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    10 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di REC ASBESTOS (SOUTH) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ASSENHEIM, Richard Allen
    Kettering Road
    NN2 7DU Northampton
    263
    England
    Amministratore
    Kettering Road
    NN2 7DU Northampton
    263
    England
    United KingdomBritish107134790001
    CLEMENTS, Jonathan Matthew
    Carrs Way
    Harpole
    NN7 4DA Northampton
    66
    England
    Amministratore
    Carrs Way
    Harpole
    NN7 4DA Northampton
    66
    England
    EnglandBritish148425870001
    KIRKMAN, Gregory John
    Duston Wildes
    NN5 6NR Northampton
    73
    England
    Amministratore
    Duston Wildes
    NN5 6NR Northampton
    73
    England
    United KingdomBritish43067380003
    ELLIS, Andrew Clive
    34 Merafield Drive
    Plympton
    PL7 1TP Plymouth
    Devon
    Segretario
    34 Merafield Drive
    Plympton
    PL7 1TP Plymouth
    Devon
    British83349650001
    MCCLUSKEY, Paul
    Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    100
    United Kingdom
    Segretario
    Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    100
    United Kingdom
    191004950001
    MOSS, Karl Alan
    9 Hadfield Street
    Cornbrook
    M16 9FE Old Trafford
    Hadfield House
    Manchester
    United Kingdom
    Segretario
    9 Hadfield Street
    Cornbrook
    M16 9FE Old Trafford
    Hadfield House
    Manchester
    United Kingdom
    148196340001
    SUTHERLAND, Ronald Macnoughton
    Flat 9
    67 Cambridge Road
    PR9 9NG Southport
    Segretario
    Flat 9
    67 Cambridge Road
    PR9 9NG Southport
    British67412270002
    SECRETARIAL APPOINTMENTS LIMITED
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    Segretario nominato
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    900017270001
    CALDERBANK, Mark
    19 Spring Gardens
    M2 1FB Manchester
    C/O 1st Floor
    United Kingdom
    Amministratore
    19 Spring Gardens
    M2 1FB Manchester
    C/O 1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish250111160001
    CARNEGIE-BROWN, Mark, Dr
    Block 35s Alderley Park
    SK10 4TG Cheshire
    C/O Concept Life Sciences
    United Kingdom
    Amministratore
    Block 35s Alderley Park
    SK10 4TG Cheshire
    C/O Concept Life Sciences
    United Kingdom
    United KingdomBritish224430380001
    COLL, David Daniel
    Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    100
    United Kingdom
    Amministratore
    Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    100
    United Kingdom
    ScotlandBritish146924840001
    ELLIS, Andrew Clive
    9 Hadfield Street
    Cornbrook
    M16 9FE Old Trafford
    Hadfield House
    Manchester
    United Kingdom
    Amministratore
    9 Hadfield Street
    Cornbrook
    M16 9FE Old Trafford
    Hadfield House
    Manchester
    United Kingdom
    EnglandBritish83349650001
    ELLIS, Andrew Clive
    34 Merafield Drive
    Plympton
    PL7 1TP Plymouth
    Devon
    Amministratore
    34 Merafield Drive
    Plympton
    PL7 1TP Plymouth
    Devon
    EnglandBritish83349650001
    FORT, Michael John
    M2 3DE Manchester
    One St Peter's Square
    United Kingdom
    Amministratore
    M2 3DE Manchester
    One St Peter's Square
    United Kingdom
    United KingdomBritish189303790003
    HANSON, Matthew James
    Stoke Road
    Blisworth
    NN7 3DB Northampton
    The Forge Blisworth Hill Farm
    England
    Amministratore
    Stoke Road
    Blisworth
    NN7 3DB Northampton
    The Forge Blisworth Hill Farm
    England
    United KingdomBritish276583410001
    JENKINS, Daniel
    M2 3DE Manchester
    One St Peter's Square
    United Kingdom
    Amministratore
    M2 3DE Manchester
    One St Peter's Square
    United Kingdom
    United KingdomBritish170241030001
    MCCLUSKEY, Paul
    Stoke Road
    Blisworth
    NN7 3DB Northampton
    The Forge Blisworth Hill Farm
    England
    Amministratore
    Stoke Road
    Blisworth
    NN7 3DB Northampton
    The Forge Blisworth Hill Farm
    England
    United KingdomBritish156519370001
    MORGAN, Alan Stuart
    Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    100
    United Kingdom
    Amministratore
    Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    100
    United Kingdom
    EnglandBritish72916280001
    SUTHERLAND, Bruce
    The Hilt
    Clobells
    TQ10 9JW South Brent
    Devon
    Amministratore
    The Hilt
    Clobells
    TQ10 9JW South Brent
    Devon
    United KingdomBritish67642630001
    WOOD, David
    Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    100
    United Kingdom
    Amministratore
    Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    100
    United Kingdom
    EnglandBritish24194630001
    CORPORATE APPOINTMENTS LIMITED
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    Amministratore delegato nominato
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    900017260001

    Chi sono le persone con controllo significativo di REC ASBESTOS (SOUTH) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    St. Peters Square
    M2 3DE Manchester
    One
    England
    01 ago 2016
    St. Peters Square
    M2 3DE Manchester
    One
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione06961217
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    REC ASBESTOS (SOUTH) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    All assets debenture
    Creato il 27 gen 2012
    Consegnato il 31 gen 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transazioni
    • 31 gen 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 11 lug 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage debenture deed
    Creato il 07 giu 2010
    Consegnato il 11 giu 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of fixed equitable charge all purchased debts; all other debts and all associated rights; by way of floating charge all the undertaking and all the rights and assets of the company.
    Persone aventi diritto
    • The Governor & Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 11 giu 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 23 lug 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 18 giu 2004
    Consegnato il 22 giu 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 22 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 dic 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0