REC ASBESTOS (SOUTH) LIMITED
Panoramica
| Nome della società | REC ASBESTOS (SOUTH) LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03830216 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di REC ASBESTOS (SOUTH) LIMITED?
- Altre attività professionali, scientifiche e tecniche n.c.a. (74909) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova REC ASBESTOS (SOUTH) LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 2 Browns Road NN11 4NS Daventry England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di REC ASBESTOS (SOUTH) LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| NOBLE HEALTH & SAFETY CONSULTANCY LIMITED | 23 ago 1999 | 23 ago 1999 |
Quali sono gli ultimi bilanci di REC ASBESTOS (SOUTH) LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2022 |
Quali sono le ultime deposizioni per REC ASBESTOS (SOUTH) LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 2 pagine | DS01 | ||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2022 | 6 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 20 giu 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2021 | 6 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 20 giu 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2020 | 6 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 20 giu 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Indirizzo della sede legale modificato da The Forge Blisworth Hill Farm Stoke Road Blisworth Northampton NN7 3DB England a 2 Browns Road Daventry NN11 4NS in data 17 lug 2020 | 1 pagine | AD01 | ||
Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 dic 2019 al 31 mar 2020 | 1 pagine | AA01 | ||
Cessazione della carica di Mark Carnegie-Brown come amministratore in data 10 ott 2019 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Paul Mccluskey come amministratore in data 10 ott 2019 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Paul Mcclusky come amministratore in data 10 ott 2019 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Matthew James Hanson come amministratore in data 10 ott 2019 | 1 pagine | TM01 | ||
Nomina di Mr Jonathan Matthew Clements come amministratore in data 10 ott 2019 | 2 pagine | AP01 | ||
Nomina di Mr Gregory John Kirkman come amministratore in data 10 ott 2019 | 2 pagine | AP01 | ||
Nomina di Mr Richard Allen Assenheim come amministratore in data 10 ott 2019 | 2 pagine | AP01 | ||
Indirizzo della sede legale modificato da One St Peter's Square Manchester M2 3DE United Kingdom a The Forge Blisworth Hill Farm Stoke Road Blisworth Northampton NN7 3DB in data 15 ott 2019 | 1 pagine | AD01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018 | 5 pagine | AA | ||
Nomina di Dr Mark Carnegie-Brown come amministratore in data 05 ago 2019 | 2 pagine | AP01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 20 giu 2019 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Nomina di Matthew James Hanson come amministratore in data 03 giu 2019 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Mark Calderbank come amministratore in data 14 giu 2019 | 1 pagine | TM01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017 | 10 pagine | AA | ||
Chi sono gli amministratori di REC ASBESTOS (SOUTH) LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSENHEIM, Richard Allen | Amministratore | Kettering Road NN2 7DU Northampton 263 England | United Kingdom | British | 107134790001 | |||||
| CLEMENTS, Jonathan Matthew | Amministratore | Carrs Way Harpole NN7 4DA Northampton 66 England | England | British | 148425870001 | |||||
| KIRKMAN, Gregory John | Amministratore | Duston Wildes NN5 6NR Northampton 73 England | United Kingdom | British | 43067380003 | |||||
| ELLIS, Andrew Clive | Segretario | 34 Merafield Drive Plympton PL7 1TP Plymouth Devon | British | 83349650001 | ||||||
| MCCLUSKEY, Paul | Segretario | Barbirolli Square M2 3AB Manchester 100 United Kingdom | 191004950001 | |||||||
| MOSS, Karl Alan | Segretario | 9 Hadfield Street Cornbrook M16 9FE Old Trafford Hadfield House Manchester United Kingdom | 148196340001 | |||||||
| SUTHERLAND, Ronald Macnoughton | Segretario | Flat 9 67 Cambridge Road PR9 9NG Southport | British | 67412270002 | ||||||
| SECRETARIAL APPOINTMENTS LIMITED | Segretario nominato | 16 Churchill Way CF10 2DX Cardiff | 900017270001 | |||||||
| CALDERBANK, Mark | Amministratore | 19 Spring Gardens M2 1FB Manchester C/O 1st Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 250111160001 | |||||
| CARNEGIE-BROWN, Mark, Dr | Amministratore | Block 35s Alderley Park SK10 4TG Cheshire C/O Concept Life Sciences United Kingdom | United Kingdom | British | 224430380001 | |||||
| COLL, David Daniel | Amministratore | Barbirolli Square M2 3AB Manchester 100 United Kingdom | Scotland | British | 146924840001 | |||||
| ELLIS, Andrew Clive | Amministratore | 9 Hadfield Street Cornbrook M16 9FE Old Trafford Hadfield House Manchester United Kingdom | England | British | 83349650001 | |||||
| ELLIS, Andrew Clive | Amministratore | 34 Merafield Drive Plympton PL7 1TP Plymouth Devon | England | British | 83349650001 | |||||
| FORT, Michael John | Amministratore | M2 3DE Manchester One St Peter's Square United Kingdom | United Kingdom | British | 189303790003 | |||||
| HANSON, Matthew James | Amministratore | Stoke Road Blisworth NN7 3DB Northampton The Forge Blisworth Hill Farm England | United Kingdom | British | 276583410001 | |||||
| JENKINS, Daniel | Amministratore | M2 3DE Manchester One St Peter's Square United Kingdom | United Kingdom | British | 170241030001 | |||||
| MCCLUSKEY, Paul | Amministratore | Stoke Road Blisworth NN7 3DB Northampton The Forge Blisworth Hill Farm England | United Kingdom | British | 156519370001 | |||||
| MORGAN, Alan Stuart | Amministratore | Barbirolli Square M2 3AB Manchester 100 United Kingdom | England | British | 72916280001 | |||||
| SUTHERLAND, Bruce | Amministratore | The Hilt Clobells TQ10 9JW South Brent Devon | United Kingdom | British | 67642630001 | |||||
| WOOD, David | Amministratore | Barbirolli Square M2 3AB Manchester 100 United Kingdom | England | British | 24194630001 | |||||
| CORPORATE APPOINTMENTS LIMITED | Amministratore delegato nominato | 16 Churchill Way CF10 2DX Cardiff | 900017260001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di REC ASBESTOS (SOUTH) LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noble Health & Safety Training Limited | 01 ago 2016 | St. Peters Square M2 3DE Manchester One England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
REC ASBESTOS (SOUTH) LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| All assets debenture | Creato il 27 gen 2012 Consegnato il 31 gen 2012 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture deed | Creato il 07 giu 2010 Consegnato il 11 giu 2010 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari By way of fixed equitable charge all purchased debts; all other debts and all associated rights; by way of floating charge all the undertaking and all the rights and assets of the company. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 18 giu 2004 Consegnato il 22 giu 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0