CLIPABILITY LIMITED

CLIPABILITY LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCLIPABILITY LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03835785
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CLIPABILITY LIMITED?

    • Attività delle agenzie di stampa (63910) / Informazione e comunicazione

    Dove si trova CLIPABILITY LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1 Broadgate
    EC2M 2QS London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di CLIPABILITY LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per CLIPABILITY LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 28 dic 2018

    • Capitale: GBP 2
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Reduction of share premium 28/12/2018
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Dichiarazione di conformità presentata il 03 set 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    8 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 03 set 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Notifica di Precise Media Group Holdings Limited come persona con controllo significativo il 06 apr 2016

    1 paginePSC02

    Cessazione di Knight Banner Information Limited come persona con controllo significativo il 04 set 2016

    1 paginePSC07

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    6 pagineAA

    Cessazione della carica di Peter Low come amministratore in data 27 gen 2017

    2 pagineTM01

    Nomina di Mr Giles Harvey Roberts Richardson come amministratore in data 10 feb 2017

    3 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 03 set 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 03 set 2015 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital27 nov 2015

    Stato del capitale al 27 nov 2015

    • Capitale: GBP 200
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    6 pagineAA

    Cessazione della carica di Kier Murray Fawcus come amministratore in data 14 lug 2015

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di John Roger Haworth come amministratore in data 14 lug 2015

    1 pagineTM01

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    Bilancio annuale redatto al 03 set 2014 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital11 mag 2015

    Stato del capitale al 11 mag 2015

    • Capitale: GBP 200
    SH01

    Cessazione della carica di Stephen Lacey come segretario in data 06 giu 2014

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Stephen Lacey come amministratore in data 06 giu 2014

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di CLIPABILITY LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WPP GROUP (NOMINEES) LIMITED
    Farm Street
    W1J 5RJ London
    27
    England
    Segretario
    Farm Street
    W1J 5RJ London
    27
    England
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione2757919
    80143770001
    RICHARDSON, Giles Harvey Roberts
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    1
    Amministratore
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    1
    EnglandBritish224284590001
    BANNER, Christopher
    86 Lexington Apartments
    40 City Road
    EC1Y 2AN London
    Segretario
    86 Lexington Apartments
    40 City Road
    EC1Y 2AN London
    British76044030002
    BANNER, Christopher John
    31 Wontner Road
    SW17 7QT London
    Segretario
    31 Wontner Road
    SW17 7QT London
    British76044030001
    CROMACK, Andrew Michael
    23 Knole Road
    ME5 8PJ Chatham
    Kent
    Segretario
    23 Knole Road
    ME5 8PJ Chatham
    Kent
    British78040930001
    DAVISON, Wayne Mark
    8 Plane Tree Close
    Shadwell
    LS17 8UF Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    8 Plane Tree Close
    Shadwell
    LS17 8UF Leeds
    West Yorkshire
    British70726990001
    GULLIVER, John Keith
    The Registry
    Royal Mint Court
    EC3N 4QN London
    Segretario
    The Registry
    Royal Mint Court
    EC3N 4QN London
    British147777590001
    HUTCHINSON, Robert William
    5 Old Mill Close
    Burley In Wharfedale
    LS29 7RU Ilkley
    West Yorkshire
    Segretario
    5 Old Mill Close
    Burley In Wharfedale
    LS29 7RU Ilkley
    West Yorkshire
    British49635190001
    LACEY, Stephen
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    1
    England
    Segretario
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    1
    England
    164063300001
    LOW, Peter
    The Registry
    Royal Mint Court
    EC3N 4QN London
    Segretario
    The Registry
    Royal Mint Court
    EC3N 4QN London
    148715640001
    LOW, Peter
    10 Union Square
    Islington
    N1 7DH London
    Segretario
    10 Union Square
    Islington
    N1 7DH London
    British65476890001
    STANNETT, Robert William
    Shalford
    GU4 8JN Guildford
    Northfield
    Surrey
    Segretario
    Shalford
    GU4 8JN Guildford
    Northfield
    Surrey
    British141063520001
    THOMSON, Alastair Iain Lindsay
    30 Roehampton Close
    SW15 5LU London
    Segretario
    30 Roehampton Close
    SW15 5LU London
    British60638430002
    BANNER, Christopher
    86 Lexington Apartments
    40 City Road
    EC1Y 2AN London
    Amministratore
    86 Lexington Apartments
    40 City Road
    EC1Y 2AN London
    British76044030002
    DOLTON, Stephen
    99 Cumnor Hill
    OX2 9JR Oxford
    Amministratore
    99 Cumnor Hill
    OX2 9JR Oxford
    British70990450005
    FAWCUS, Kier Murray
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    1
    England
    Amministratore
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    1
    England
    EnglandBritish84594470002
    GULLIVER, John Keith
    The Registry
    Royal Mint Court
    EC3N 4QN London
    Amministratore
    The Registry
    Royal Mint Court
    EC3N 4QN London
    United KingdomBritish147777590001
    HARKNESS, Peter Martin
    19 Horsley Court
    Montaigne Close Regency Street
    SW1 4BF London
    Amministratore
    19 Horsley Court
    Montaigne Close Regency Street
    SW1 4BF London
    United KingdomBritish146757430001
    HAWORTH, John Roger
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    1
    England
    Amministratore
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    1
    England
    EnglandBritish91354480002
    HILLIARD, Charles Stephen
    18 Albion Works Studios
    63 Sigdon Road
    E8 1AW London
    Amministratore
    18 Albion Works Studios
    63 Sigdon Road
    E8 1AW London
    British104848990001
    JONES, Malcolm Richard
    Crossways Scotland Lane
    Horsforth
    LS18 5SF Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Crossways Scotland Lane
    Horsforth
    LS18 5SF Leeds
    West Yorkshire
    British4700740001
    KINNEAR, James Broomfield
    2 Woodliffe Court
    LS7 3RF Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    2 Woodliffe Court
    LS7 3RF Leeds
    West Yorkshire
    British68573880002
    KNIGHT, Martin
    The Cuttings 57 Cheam Road
    East Ewell
    KT17 3EB Epsom
    Surrey
    Amministratore
    The Cuttings 57 Cheam Road
    East Ewell
    KT17 3EB Epsom
    Surrey
    EnglandBritish13326400003
    LACEY, Stephen
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    1
    England
    Amministratore
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    1
    England
    EnglandBritish88368490002
    LOW, Peter
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    1
    England
    Amministratore
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    1
    England
    EnglandBritish65476890002
    MORRIS, Alec Malcolm, Mr.
    Bat Barn Morganhayes
    Southleigh
    EX24 6RY Colyton
    Devon
    Amministratore
    Bat Barn Morganhayes
    Southleigh
    EX24 6RY Colyton
    Devon
    United KingdomBritish52256040002
    MORRIS, Pauline Ann
    Bat Barn Morganhayes
    Southleigh
    EX24 6RY Colyton
    Devon
    Amministratore
    Bat Barn Morganhayes
    Southleigh
    EX24 6RY Colyton
    Devon
    British52256170002
    MORRISON, Deborah
    43c Mount Ephraim Road
    SW16 1LP London
    Amministratore
    43c Mount Ephraim Road
    SW16 1LP London
    United KingdomBritish91218120001
    SHEPHERD, Jonathan Paul
    7 Hatton Close
    Chafford Hundred
    RM16 6RP Grays
    Essex
    Amministratore
    7 Hatton Close
    Chafford Hundred
    RM16 6RP Grays
    Essex
    United KingdomBritish104848170001
    STANNETT, Robert William
    Shalford
    GU4 8JN Guildford
    Northfield
    Surrey
    Amministratore
    Shalford
    GU4 8JN Guildford
    Northfield
    Surrey
    EnglandBritish141063520001

    Chi sono le persone con controllo significativo di CLIPABILITY LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    1 Broadgate
    England
    03 set 2016
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    1 Broadgate
    England
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione4152862
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    Precise Media Group Holdings Limited
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    1
    England
    06 apr 2016
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    1
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    CLIPABILITY LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Fixed and floating charge
    Creato il 01 apr 2005
    Consegnato il 20 apr 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transazioni
    • 20 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 dic 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 01 apr 2005
    Consegnato il 15 apr 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future indebtedness liabilities and obligations due or to become due from any chargor or other member of the group to the chargee (the "security trustee") as agent and trustee for itself and each of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 15 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 dic 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 02 lug 2003
    Consegnato il 05 lug 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 05 lug 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 apr 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    All assets debenture
    Creato il 30 set 2002
    Consegnato il 02 ott 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited Trading as Alex. Lawrie Factors
    Transazioni
    • 02 ott 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 apr 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 14 mag 2001
    Consegnato il 17 mag 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 17 mag 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 apr 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0