COSFORCE SHIPPING LIMITED

COSFORCE SHIPPING LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCOSFORCE SHIPPING LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03841870
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di COSFORCE SHIPPING LIMITED?

    • Trasporto merci via acqua costiera e marittima (50200) / Trasporto e stoccaggio

    Dove si trova COSFORCE SHIPPING LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Cosco House
    Vicarage Drive
    IG11 7NA Barking
    Essex
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di COSFORCE SHIPPING LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ALLCO SEAGAS LIMITED18 nov 199918 nov 1999
    VALLEYCLOSE LIMITED15 set 199915 set 1999

    Quali sono gli ultimi bilanci di COSFORCE SHIPPING LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2022

    Quali sono le ultime deposizioni per COSFORCE SHIPPING LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01
    ACJA05F6

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2022

    3 pagineAA
    AC1J9N1U

    Dichiarazione di conformità presentata il 21 apr 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01
    XC1WBNIX

    Dichiarazione di conformità presentata il 21 apr 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01
    XB2ENUVU

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2021

    3 pagineAA
    AAX0AR7K

    Cessazione della carica di Romeo Abenes Mendoza come segretario in data 30 set 2021

    1 pagineTM02
    XAE77W80

    Cessazione della carica di Romeo Abenes Mendoza come amministratore in data 30 set 2021

    1 pagineTM01
    XAE77WG2

    Dichiarazione di conformità presentata il 21 apr 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01
    XA2VBX8W

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2020

    3 pagineAA
    AA0NCJAG

    Dichiarazione di conformità presentata il 21 apr 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01
    X93V2Z9F

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2019

    3 pagineAA
    A8ZCA4BE

    Dichiarazione di conformità presentata il 21 apr 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01
    X83ZECOX

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2018

    3 pagineAA
    A7YAJ296

    Nomina di Mr Romeo Abenes Mendoza come amministratore in data 22 gen 2018

    2 pagineAP01
    X7BADTJV

    Nomina di Mr Gang Wang come amministratore in data 22 gen 2018

    2 pagineAP01
    X7BADTSP

    Dichiarazione di conformità presentata il 21 apr 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01
    X752URVC

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2017

    3 pagineAA
    A6YZVIGI

    Cessazione della carica di Jing Guo come amministratore in data 22 gen 2018

    1 pagineTM01
    X6Z9VC3T

    Cessazione della carica di Shicheng Cheng Yang come amministratore in data 01 lug 2017

    1 pagineTM01
    X6A4MMI1

    Nomina di Jing Guo come amministratore in data 17 mag 2017

    2 pagineAP01
    X66SLUBU

    Dichiarazione di conformità presentata il 21 apr 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01
    X64T96Q1

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2016

    3 pagineAA
    A61P3JGP

    Bilancio annuale redatto al 21 apr 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital07 giu 2016

    Stato del capitale al 07 giu 2016

    • Capitale: GBP 1
    SH01
    X58LV38Q

    Chi sono gli amministratori di COSFORCE SHIPPING LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    NOROSE COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    More London Riverside
    SE1 2AQ London
    3
    Segretario
    More London Riverside
    SE1 2AQ London
    3
    138492980001
    WANG, Gang
    Vicarage Drive
    IG11 7NA Barking
    Cosco House
    Essex
    Amministratore
    Vicarage Drive
    IG11 7NA Barking
    Cosco House
    Essex
    United KingdomChineseDirector242944050001
    CARON DELION, Patrick
    First Floor Flat
    39 Nevern Square
    SW5 9PE London
    Segretario
    First Floor Flat
    39 Nevern Square
    SW5 9PE London
    BritishSolicitor/Lease Arranger95892040001
    LEWIN, Alastair Giles
    19 Severnake Close
    Isle Of Dogs
    E14 9WE London
    Segretario
    19 Severnake Close
    Isle Of Dogs
    E14 9WE London
    British73905180001
    MENDOZA, Romeo Abenes
    Vicarage Drive
    IG11 7NA Barking
    Cosco House
    Essex
    Segretario
    Vicarage Drive
    IG11 7NA Barking
    Cosco House
    Essex
    British66998480001
    SWANNELL, David William
    5c Hyde Park Mansions
    Transept Street
    NW1 5ES London
    Segretario
    5c Hyde Park Mansions
    Transept Street
    NW1 5ES London
    BritishLease Packager72665990002
    THORP, Richard Simon
    26 Murray Mews
    Camden
    NW1 9RJ London
    Segretario
    26 Murray Mews
    Camden
    NW1 9RJ London
    British98514070001
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Segretario nominato
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    900005620001
    CARON DELION, Patrick
    4 Esmond Road
    W4 1JQ London
    Amministratore
    4 Esmond Road
    W4 1JQ London
    EnglandOtherFinancier95892040003
    CHARLTON, Peter John
    17 Kirkdale Road
    AL5 2PT Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore delegato nominato
    17 Kirkdale Road
    AL5 2PT Harpenden
    Hertfordshire
    British900005610001
    DONG, Ming, Captain
    Vicarage Drive
    IG11 7NA Barking
    Cosco House
    Essex
    Amministratore
    Vicarage Drive
    IG11 7NA Barking
    Cosco House
    Essex
    ChineseChief Executive Officer And Director90829700001
    GRIFFIN, Philip Mark
    51 Olola Avenue
    2030 Vaucluse
    Nsw
    Australia
    Amministratore
    51 Olola Avenue
    2030 Vaucluse
    Nsw
    Australia
    AustralianFinancier49828980005
    GUO, Jing
    Herrengraben
    20459 Hamburg
    74
    Germany
    Amministratore
    Herrengraben
    20459 Hamburg
    74
    Germany
    GermanyChineseShipping231810330001
    HARRIS, Braden
    Flat D
    41 Lancaster Grove
    NW3 4HB London
    Amministratore
    Flat D
    41 Lancaster Grove
    NW3 4HB London
    United KingdomBritishFinancier72069860002
    JOBANPUTRA, Sandip
    7 High Holborn
    Flat 110
    WC1V 6DR London
    Amministratore
    7 High Holborn
    Flat 110
    WC1V 6DR London
    UkBritishFinancier83069380001
    KAYSER, Simon Philip
    Apartment 91
    Cinnabar Wharf East, 28 Wapping High Street
    E1W 1NG London
    Amministratore
    Apartment 91
    Cinnabar Wharf East, 28 Wapping High Street
    E1W 1NG London
    EnglandBritishFinancier99475270002
    MENDOZA, Romeo Abenes
    Vicarage Drive
    IG11 7NA Barking
    Cosco House
    Essex
    Amministratore
    Vicarage Drive
    IG11 7NA Barking
    Cosco House
    Essex
    EnglandBritishAccounts Manager66998480001
    RICHARDS, Martin Edgar
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    Amministratore delegato nominato
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    British900002870001
    SWANNELL, David William
    55 Albion Gate
    Hyde Park Place
    W2 2LG London
    Amministratore
    55 Albion Gate
    Hyde Park Place
    W2 2LG London
    BritishFinancier72665990003
    YANG, Shicheng Cheng
    Vicarage Drive
    IG11 7NA Barking
    Cosco House
    Essex
    Amministratore
    Vicarage Drive
    IG11 7NA Barking
    Cosco House
    Essex
    United KingdomChineseChief Executive Officer147770930003
    ZHAO, Lei, Mister
    Vicarage Drive
    IG11 7NA Barking
    Cosco House
    Essex
    Amministratore
    Vicarage Drive
    IG11 7NA Barking
    Cosco House
    Essex
    United KingdomChineseAccounts Manager127091490001

    Chi sono le persone con controllo significativo di COSFORCE SHIPPING LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Vicarage Drive
    IG11 7NA Barking
    Cosco House
    Essex
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Vicarage Drive
    IG11 7NA Barking
    Cosco House
    Essex
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleUnited Kingdom
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione4013305
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    COSFORCE SHIPPING LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Second priority mortgage relating to M.V."cosco rotterdam",kawasaki hull no.1505 (Registered under the bahamas flag) as supplemented by collateral deed of covenant dated 11TH december 2000 and
    Creato il 13 feb 2002
    Consegnato il 05 mar 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All 64/64TH shares in the vessel and all boats,gun,etc.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Maritime Leasing (No.1) Limited
    Transazioni
    • 05 mar 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 ago 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Transfer of mortgage executed by nedship bank N.V. (the "prior mortgagee") in favour of dvb group merchant bank (asia) limited transferring a first priority bahamas statutory mortgage in respect of M.V. "cosco rotterdam" executed by the owner in favour of the prior mortgagee
    Creato il 13 feb 2002
    Consegnato il 27 feb 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the company's right title and interest in and to the vessel registered under the flag of the bahamas at the port of nassau with official number 8000417. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Dvb Group Merchant Bank (Asia) LTD (as Security Trustee for the Banks)
    Transazioni
    • 27 feb 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 ago 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    First priority bahamas statutory mortgage in respect of M.V. "cosco rotterdam" by the company (as owner) to nedship bank N.V.
    Creato il 13 feb 2002
    Consegnato il 27 feb 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the company's right title and interest in and to the vessel registered under the flag of the bahamas at the port of nassau with official number 8000417. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nedship Bank N.V. (As Security Trustee for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 27 feb 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 ago 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A third priority assignment of insurances and requisition proceeds
    Creato il 13 feb 2002
    Consegnato il 20 feb 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The assigned property all right title interest and benefit in respect of the vessel all policies and contracts of insurance. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Cosco (UK) Limited
    Transazioni
    • 20 feb 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 ago 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A deed of covenant
    Creato il 13 feb 2002
    Consegnato il 20 feb 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The right title and interest in and to the ship "cosco rotterdam" and in her equipment and appurtenances and in any proceeds of sale. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Cosco (U.K) Limited
    Transazioni
    • 20 feb 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 ago 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 13 feb 2002
    Consegnato il 20 feb 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All right title and interest in and to the ship "cosco rotterdam" official no. 8000417 and in her equipment and appurtenances.
    Persone aventi diritto
    • Cosco (U.K.) Limited
    Transazioni
    • 20 feb 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 ago 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of general assignment dated 6TH april 2001 between the company allco finance limited (afl) ,allco finance (UK) limited (afuk) and lloyds tsb maritime leasing (no.1) limited (the "assignee")
    Creato il 06 apr 2001
    Consegnato il 12 apr 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company, afl or afuk to the chargee under the terms of the security document
    Brevi particolari
    All the company's right title and interest present and future in and to (I) the insurances including all payments to the company in respect of all claims rights and remedies of the company arising therefrom (ii) any requisition compensation (iii) all sums standing to the credit of the account in the name of the company (iv) the bareboat charter (other than the b charterhire payable thereunder) and the bareboat charterers assignment and all claims rights and remedies of the company arising therefrom (v) the refund guarantees (vi) the novated shipbuilding contract and novation agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Maritime Leasing (No.1 ) Limited
    Transazioni
    • 12 apr 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 ago 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Investor assignment (owner) (the "security document") dated 6TH april 2001 between the company, cosforce shipping limited (the "owner") and lloyds tsb maritime leasing (no.1) limited (the "assignee")
    Creato il 06 apr 2001
    Consegnato il 12 apr 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the security document
    Brevi particolari
    All rights title and interest present and future actual or contingent of the company and the owner in and under (I) the bareboat charter to the extent that the same relates to the obligation of the bareboat charterer to pay b charthire and (ii) the agreement to charter and the time charter to the extent as the same relates to the obligation of the time charterers to pay certain amounts (together with b charterhire, the "relevant amounts") referred in the agreement to charter. Including in each case all payments to the owner pursuant thereto and all claims rights and remedies of the owner arisiarising therefrom including a).all damages and compensation payable for or in respect thereof.b). The right to amend, vary or supplement the bareboat charter, the agreement to charter or the time charter as they relate to the relevant amounts c). The right to grant any consent, approval waiver or confirmation under the bareboat charter the agreement to charter or the time charter as they relate to the relevant amounts. (The "assigned property"),. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Maritime Leasing (No.1) Limited
    Transazioni
    • 12 apr 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 ago 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of general assignment and covenant relating to hull no 1505 (T.B.N. "river cosforce") executed by cosforce shipping limited (the "owner"), allco finance limited ("afl") and allco finance (UK) limited ("afuk") in favour or nedship bank N.V. (the "assignee")
    Creato il 11 dic 2000
    Consegnato il 22 dic 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies, liabilities and obligations (whether actual or contingent, whether now existing or hereafter arising, whether as principal or surety, whether or not for the payment of money and including any obligation or liability to pay damages) which are now or which may at any time and from time to time hereafter be due, owing, payable or incurred from or by afuk to the assignee (in its own capacity or in its capacity as security trusteee for the beneficiaries)
    Brevi particolari
    All right title and interest in to any under the account, the agreement and the insurances and any requisitions compensation the vessel all sums to the credit of the account. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nedship Bank N.V. (As Security Trustee for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 22 dic 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 ago 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture creating a floating charge postponed to all other security interests
    Creato il 11 dic 2000
    Consegnato il 22 dic 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies, liabilities and obligations (whether actual or contingent, whether now existing or hereafter arising, whether as principal or surety, whether or not for the payment of money and including any obligation or liability to pay damages) which are now or which may at any time and from time to time hereafter be due, owing, payable or incurred from or by the security party (as defined) to the chargee and/or any of the beneficiaries (as defined) under the transaction documents (as defined)
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Nedship Bank N.V. (Acting as Security Trustee for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 22 dic 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 ago 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0